REGENERSIS (NOTTINGHAM) LTD
Обзор
Название компании | REGENERSIS (NOTTINGHAM) LTD |
---|---|
Статус компании | Ликвидирована |
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Номер компании | 03078605 |
Юрисдикция | Англия/Уэльс |
Дата создания | |
Дата прекращения деятельности |
Резюме
Имеет суперзащищенные PSCs | Нет |
---|---|
Имеет залоги | Да |
Имеет историю несостоятельности | Нет |
Юридический адрес оспаривается | Нет |
Какова цель REGENERSIS (NOTTINGHAM) LTD?
- Прочие услуги н.в.и.д. (96090) / Деятельность по оказанию прочих услуг
Где находится REGENERSIS (NOTTINGHAM) LTD?
Юридический адрес | 4th Floor 32 Wigmore Street W1U 2RP London United Kingdom |
---|---|
Юридический адрес недоступен для доставки | Нет |
Какие были предыдущие названия REGENERSIS (NOTTINGHAM) LTD?
Название компании | С | По |
---|---|---|
COMMUNICATION REPAIR CENTRE (U.K.) LIMITED | 11 июл. 1995 г. | 11 июл. 1995 г. |
Каковы последние отчеты REGENERSIS (NOTTINGHAM) LTD?
Последние отчеты | |
---|---|
Последние отчеты составлены по состоянию на | 30 июн. 2011 г. |
Какие последние документы подавались REGENERSIS (NOTTINGHAM) LTD?
Дата | Описание | Документ | Тип | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации | 1 страницы | GAZ2(A) | ||||||||||
Изменение данных директора для Mr Jog Dhody 22 окт. 2012 г. | 2 страницы | CH01 | ||||||||||
Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации | 1 страницы | GAZ1(A) | ||||||||||
Заявление о снятии компании с учета | 3 страницы | DS01 | ||||||||||
Годовой отчет с полным списком акционеров | 5 страницы | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Юридический адрес изменен с Kingfisher Way Hinchingbrooke Business Park Huntingdon Cambridgeshire PE29 6FN United Kingdom 21 июн. 2012 г. | 1 страницы | AD01 | ||||||||||
Назначение Mr Jog Dhody на должность директора 21 мар. 2012 г. | 2 страницы | AP01 | ||||||||||
Прекращение полномочий Jeremy Michael Charles Wilson в качестве директора 21 мар. 2012 г. | 1 страницы | TM01 | ||||||||||
Изменение данных директора для Mr Andrew Stephen Lee 05 дек. 2011 г. | 2 страницы | CH01 | ||||||||||
Изменение данных директора для Mr Jeremy Michael Charles Wilson 05 дек. 2011 г. | 2 страницы | CH01 | ||||||||||
Изменение данных секретаря для Prism Cosec Limited 13 янв. 2012 г. | 2 страницы | CH04 | ||||||||||
Юридический адрес изменен с 4 Elm Place Old Witney Road, Eynsham, Witney Oxfordshire OX29 4BD 05 дек. 2011 г. | 1 страницы | AD01 | ||||||||||
Годовая бухгалтерская отчетность | 16 страницы | AA | ||||||||||
Назначение Mr Andrew Stephen Lee на должность директора | 2 страницы | AP01 | ||||||||||
Прекращение полномочий Sally Weatherall в качестве секретаря | 1 страницы | TM02 | ||||||||||
Назначение Prism Cosec Limited на должность секретаря | 2 страницы | AP04 | ||||||||||
Годовой отчет с полным списком акционеров | 4 страницы | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 страницы | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 страницы | MG02 | ||||||||||
Прекращение полномочий Gary Stokes в качестве директора | 2 страницы | TM01 | ||||||||||
Годовая бухгалтерская отчетность | 17 страницы | AA | ||||||||||
Годовой отчет с полным списком акционеров | 5 страницы | AR01 | ||||||||||
Прекращение полномочий David Kelham в качестве директора | 1 страницы | TM01 | ||||||||||
Прекращение полномочий David Kelham в качестве директора | 1 страницы | TM01 | ||||||||||
Назначение Mr David William Kelham на должность директора | 2 страницы | AP01 | ||||||||||
Кто является должностными лицами REGENERSIS (NOTTINGHAM) LTD?
Имя | Назначен | Ушел в отставку | Роль | Адрес | Идентификация компании | Страна проживания | Гражданство | Дата рождения | Профессия | Номер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISM COSEC LIMITED | Секретарь компании | 10 Margaret Street W1W 8RL London Prism Cosec United Kingdom |
| 116519070002 | ||||||||||
DHODY, Jog | Директор | Floor 32 Wigmore Street W1U 2RP London 4th United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 104269910003 | ||||||||
LEE, Andrew Stephen | Директор | Hinchingbrooke Business Park Huntingdon PE29 6FN Cambridgeshire Kingfisher Way United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 159105430001 | ||||||||
BOWEN, John | Секретарь | Flowergate 5 Heol Don Whitchurch CF14 2AR Cardiff | British | Solicitor | 33947050001 | |||||||||
CROCKER, Arthur Rupert | Секретарь | 35 Palmerston Road Wimbledon SW19 1PG London | British | Finance Director | 79797070001 | |||||||||
HOWARD, Paul Edward | Секретарь | 43 Sandringham Road Sandiacre NG10 5LD Nottingham | British | Engineer | 46938230002 | |||||||||
TEMPLE, John Nicholas | Секретарь | Windfalls Highfield Road West Moors BH22 0NA Ferndown Dorset | British | 84493950001 | ||||||||||
WEATHERALL, Sally | Секретарь | 4 Elm Place Old Witney Road, Eynsham, Witney OX29 4BD Oxfordshire | 152389760001 | |||||||||||
BOWEN, John | Директор | Flowergate 5 Heol Don Whitchurch CF14 2AR Cardiff | United Kingdom | British | Company Secretary | 33947050001 | ||||||||
CROCKER, Arthur Rupert | Директор | 35 Palmerston Road Wimbledon SW19 1PG London | England | British | Finance Director | 79797070001 | ||||||||
HOWARD, Paul Edward | Директор | 43 Sandringham Road Sandiacre NG10 5LD Nottingham | British | Engineer | 46938230002 | |||||||||
KELHAM, David William | Директор | 4 Elm Place Old Witney Road, Eynsham, Witney OX29 4BD Oxfordshire | England | British | Director | 87146390001 | ||||||||
KELHAM, David William | Директор | 4 Elm Place Old Witney Road, Eynsham, Witney OX29 4BD Oxfordshire | England | British | Director | 87146390001 | ||||||||
KELHAM, David William | Директор | Chastilian Gough Road GU51 4LJ Fleet Hampshire | England | British | It Services | 87146390001 | ||||||||
MATTHEWS, Christopher John | Директор | The Long House Hillesden Road, Gawcott MK18 4JF Buckingham Buckinghamshire | England | British | Company Director | 59807870002 | ||||||||
MCLAUGHLIN, Alan | Директор | 4 Woodstock Close OX2 8DB Oxford Oxfordshire | British | Company Chief Executive | 91543760001 | |||||||||
PEAGRAM, Michael John | Директор | Bletchingdon Park Bletchingdon OX5 3DW Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 44540370005 | ||||||||
RYAN, David | Директор | Purton Stoke House Purton Stoke SN5 4JF Swindon Wiltshire | British | Company Director | 75937900002 | |||||||||
STOKES, Gary Martin | Директор | 16a Fiery Hill Road Barnt Green B45 8LG Birmingham West Midlands | England | British | Company Director | 71396660002 | ||||||||
WAINEWRIGHT, Simon Anthony | Директор | Peggs Cottage Main Street, Hemington DE74 2RB Derby Derbyshire | British | Manager | 43791830004 | |||||||||
WILSON, Jeremy Michael Charles | Директор | Hinchingbrooke Business Park Huntingdon PE29 6FN Cambridgeshire Kingfisher Way United Kingdom | England | British | Director | 151756520001 |
Есть ли у REGENERSIS (NOTTINGHAM) LTD какие-либо обременения?
Классификация | Даты | Статус | Подробности | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Создан 18 сент. 2007 г. Поставлен 27 сент. 2007 г. | Полностью погашен | Обеспеченная сумма All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Краткое описание Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Уполномоченные лица
| ||||
Транзакции
| ||||
Debenture | Создан 21 февр. 2007 г. Поставлен 09 мар. 2007 г. | Полностью погашен | Обеспеченная сумма All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Краткое описание Fixed and floating charges over the undertaking and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Уполномоченные лица
| ||||
Транзакции
| ||||
Counterpart rent deposit deed | Создан 22 июн. 1999 г. Поставлен 26 июн. 1999 г. | Полностью погашен | Обеспеченная сумма All monies due or to become due from the company to the chargee under an underlease of even date | |
Краткое описание The deposit sum as defined in the rent deposit deed totalling £10,000 and any further sum deposited under clause 11 of the rent deposit deed in respect of vat. | ||||
Уполномоченные лица
| ||||
Транзакции
| ||||
Mortgage debenture | Создан 03 авг. 1995 г. Поставлен 10 авг. 1995 г. | Полностью погашен | Обеспеченная сумма All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Краткое описание A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Уполномоченные лица
| ||||
Транзакции
|
Источник данных
- Companies House Великобритании
Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность. - Лицензия: CC0