GPL 2024 REALISATIONS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подтверждающее заявление
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииGPL 2024 REALISATIONS LIMITED
    Статус компанииВ управлении
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03121752
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель GPL 2024 REALISATIONS LIMITED?

    • Аренда грузовых автомобилей и других грузовых транспортных средств (77120) / Административные и вспомогательные услуги

    Где находится GPL 2024 REALISATIONS LIMITED?

    Юридический адрес
    Suite 3 Regency House
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия GPL 2024 REALISATIONS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    GO PLANT LIMITED19 дек. 1995 г.19 дек. 1995 г.
    DE FACTO 437 LIMITED03 нояб. 1995 г.03 нояб. 1995 г.

    Каковы последние отчеты GPL 2024 REALISATIONS LIMITED?

    ПросроченоДа
    Следующие отчеты
    Следующий отчетный период заканчивается30 июн. 2023 г.
    Следующие отчеты должны быть представлены30 июн. 2024 г.
    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 июн. 2022 г.

    Каков статус последнего подтверждающего заявления для GPL 2024 REALISATIONS LIMITED?

    ПросроченоДа
    Последнее подтверждающее заявление составлено по состоянию на31 дек. 2024 г.
    Следующее подтверждающее заявление должно быть представлено14 янв. 2025 г.
    Последнее подтверждающее заявление
    Следующее подтверждающее заявление составлено по состоянию на31 дек. 2023 г.
    ПросроченоДа

    Какие последние документы подавались GPL 2024 REALISATIONS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Отчет о ходе администрации

    37 страницыAM10

    Полное погашение обременения 031217520030

    1 страницыMR04

    Заявление о состоянии дел с приложенной формой AM02SOA/AM02SOC

    23 страницыAM02

    Уведомление о предполагаемом одобрении предложений

    3 страницыAM06

    Разное

    Statement of fact – change of name correction. Incorrect name:gpl realisations LIMITED correct name: gpl 2024 realisations LIMITED
    1 страницыMISC
    страницыANNOTATION

    Свидетельство об изменении наименования компании

    Company name changed go plant LIMITED\certificate issued on 24/05/24
    3 страницыCERTNM
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    change-of-name

    Решение об изменении наименования

    RES15

    Уведомление об изменении наименования"

    2 страницыCONNOT

    Заявление о предложениях администратора

    56 страницыAM03

    Юридический адрес изменен с 1a Franks Road Bardon Hill Coalville Leicestershire LE67 1TT United Kingdom на Suite 3 Regency House 91 Western Road Brighton BN1 2NW 14 мая 2024 г.

    3 страницыAD01

    Назначение администратора

    3 страницыAM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 31 дек. 2023 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Прекращение полномочий Katherine Victoria Green в качестве директора 13 нояб. 2023 г.

    1 страницыTM01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    36 страницыAA

    Назначение Mr Paul James Dove на должность директора 02 мая 2023 г.

    2 страницыAP01

    Уведомление о подтверждении, составленное 31 дек. 2022 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Адрес для ознакомления с регистрами изменен с Go Plant Limited Leicester Road Ibstock LE67 6HP England на 1a Franks Road Bardon Hill Coalville LE67 1TT

    1 страницыAD02

    Годовая бухгалтерская отчетность

    32 страницыAA

    Прекращение полномочий Christopher Benjamin Gilmore в качестве директора 29 июн. 2022 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Graham Kevin Hale в качестве директора 24 февр. 2022 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Philip Richard Quelch в качестве директора 01 янв. 2022 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 31 дек. 2021 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Юридический адрес изменен с Jarvis House 157 Sadler Road Lincoln LN6 3RS England на 1a Franks Road Bardon Hill Coalville Leicestershire LE67 1TT 20 нояб. 2021 г.

    1 страницыAD01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    31 страницыAA

    Назначение Mr Christopher Benjamin Gilmore на должность директора 01 июл. 2021 г.

    2 страницыAP01

    Кто является должностными лицами GPL 2024 REALISATIONS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    DOVE, Paul James
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    Suite 3 Regency House
    Директор
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    Suite 3 Regency House
    EnglandBritishCommercial Director308590320001
    GALLIMORE, Mark Robert
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    Suite 3 Regency House
    Директор
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    Suite 3 Regency House
    EnglandBritishDirector240963310001
    BROOKES, Keith Robert
    Leicester Road
    LE67 6HP Ibstock
    Wilson House
    Leicestershire
    United Kingdom
    Секретарь
    Leicester Road
    LE67 6HP Ibstock
    Wilson House
    Leicestershire
    United Kingdom
    BritishDirector61439410001
    O'CONNELL, Christian John
    C/O Fishers Solicitors
    4-8 Kilwardby Street
    LE65 2FU Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Секретарь
    C/O Fishers Solicitors
    4-8 Kilwardby Street
    LE65 2FU Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    210129030001
    SILBER, Adrian Giles
    C/O Fishers Solicitors
    4-8 Kilwardby Street
    LE65 2FU Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Секретарь
    C/O Fishers Solicitors
    4-8 Kilwardby Street
    LE65 2FU Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    161704180001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Номинированный секретарь
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001
    BROOKES, Keith Robert
    Leicester Road
    LE67 6HP Ibstock
    Wilson House
    Leicestershire
    United Kingdom
    Директор
    Leicester Road
    LE67 6HP Ibstock
    Wilson House
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector61439410001
    BROWN, Graham Marshall
    Leicester Road
    LE67 6HP Ibstock
    Wilson House
    Leicestershire
    Директор
    Leicester Road
    LE67 6HP Ibstock
    Wilson House
    Leicestershire
    United KingdomBritishDirector9631280002
    DOHERTY, Anthony
    157 Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Jarvis House
    England
    Директор
    157 Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Jarvis House
    England
    EnglandBritishDirector240962990001
    GILMORE, Christopher Benjamin
    Franks Road
    Bardon Hill
    LE67 1TT Coalville
    1a
    Leicestershire
    United Kingdom
    Директор
    Franks Road
    Bardon Hill
    LE67 1TT Coalville
    1a
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector284866080001
    GREEN, Katherine Victoria
    Franks Road
    Bardon Hill
    LE67 1TT Coalville
    1a
    Leicestershire
    United Kingdom
    Директор
    Franks Road
    Bardon Hill
    LE67 1TT Coalville
    1a
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector278720610001
    GREENBURY, James Brett
    6 Montague Road
    TW10 6QW Richmond
    Surrey
    Директор
    6 Montague Road
    TW10 6QW Richmond
    Surrey
    BritishDirector13172950004
    HALE, Graham Kevin
    Franks Road
    Bardon Hill
    LE67 1TT Coalville
    1a
    Leicestershire
    United Kingdom
    Директор
    Franks Road
    Bardon Hill
    LE67 1TT Coalville
    1a
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector67199830004
    LANGFORD, Stuart Allan
    7 Copes Drive
    B79 8HH Tamworth
    Staffordshire
    Директор
    7 Copes Drive
    B79 8HH Tamworth
    Staffordshire
    United KingdomBritishOperations Director45769400001
    LANGHAM, Paul
    Leicester Road
    LE67 6HP Ibstock
    Wilson House
    Leicestershire
    United Kingdom
    Директор
    Leicester Road
    LE67 6HP Ibstock
    Wilson House
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector122926950001
    LOCKE, Gregson Horace
    C/O Fishers Solicitors
    4-8 Kilwardby Street
    LE65 2FU Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Директор
    C/O Fishers Solicitors
    4-8 Kilwardby Street
    LE65 2FU Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector40820130001
    MCLEOD, Colin Vaughan
    157 Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Jarvis House
    England
    Директор
    157 Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Jarvis House
    England
    EnglandBritishCompany Director32924830001
    NORTON, Malcolm
    Leicester Road
    LE67 6HP Ibstock
    Wilson House
    Leicestershire
    United Kingdom
    Директор
    Leicester Road
    LE67 6HP Ibstock
    Wilson House
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector122926820001
    O'CONNELL, Christian John
    157 Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Jarvis House
    England
    Директор
    157 Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Jarvis House
    England
    EnglandBritishDirector199065370001
    QUELCH, Philip Richard
    Franks Road
    Bardon Hill
    LE67 1TT Coalville
    1a
    Leicestershire
    United Kingdom
    Директор
    Franks Road
    Bardon Hill
    LE67 1TT Coalville
    1a
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Operating Officer251749880002
    REED, Carole Ann
    157 Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Jarvis House
    England
    Директор
    157 Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Jarvis House
    England
    EnglandBritishDirector124125370001
    SILBER, Adrian Giles
    C/O Fishers Solicitors
    4-8 Kilwardby Street
    LE65 2FU Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Директор
    C/O Fishers Solicitors
    4-8 Kilwardby Street
    LE65 2FU Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    United KingdomBritishCompany Director10161590001
    SINCLAIR, Hugh Alastair
    Leicester Road
    LE67 6HP Ibstock
    Wilson House
    Leicestershire
    United Kingdom
    Директор
    Leicester Road
    LE67 6HP Ibstock
    Wilson House
    Leicestershire
    United Kingdom
    UkBritishChartered Accountant122706030001
    TIERNEY, Patrick James
    14 Woodcock Close
    Gilmorton
    LE17 5SE Lutterworth
    Leicestershire
    Директор
    14 Woodcock Close
    Gilmorton
    LE17 5SE Lutterworth
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector45769360002
    WILSON, David William
    Leicester Road
    LE67 6HP Ibstock
    Wilson House
    Leicestershire
    United Kingdom
    Директор
    Leicester Road
    LE67 6HP Ibstock
    Wilson House
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChairman205503570001
    WILSON, James David
    4-8 Kilwardby Street
    LE65 2FU Ashby-De-La-Zouch
    Fishers Solicitors
    Leicestershire
    England
    Директор
    4-8 Kilwardby Street
    LE65 2FU Ashby-De-La-Zouch
    Fishers Solicitors
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishCompany Director159703760001
    YOUNG, Andrew James Bruce
    157 Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Jarvis House
    England
    Директор
    157 Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Jarvis House
    England
    United KingdomBritishFinance Director251115930001
    TRAVERS SMITH LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Номинированный директор
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006090001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Номинированный директор
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над GPL 2024 REALISATIONS LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Alpha Holdco 1 Limited
    157 Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Jarvis House
    England
    13 июл. 2017 г.
    157 Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Jarvis House
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаPrivate Limited Company
    Страна регистрацииEngland And Wales
    Юридическое основаниеCompanies Act 2006
    Место регистрацииEngland And Wales
    Регистрационный номер09496091
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    Mr James David Wilson
    C/O Fishers Solicitors
    4-8 Kilwardby Street
    LE65 2FU Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    06 апр. 2016 г.
    C/O Fishers Solicitors
    4-8 Kilwardby Street
    LE65 2FU Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Да
    Гражданство: British
    Страна проживания: United Kingdom
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 25%, но не более 50% акций компании.
    Beacon Hill Group 2010 Limited
    Grenville Street
    JE1 4HH St Helier
    No 2 The Forum
    Jersey
    06 апр. 2016 г.
    Grenville Street
    JE1 4HH St Helier
    No 2 The Forum
    Jersey
    Да
    Организационно-правовая формаCompany Limited By Shares
    Страна регистрацииJersey
    Юридическое основаниеCompanies (Jersey) Law 1991
    Место регистрацииJersey Registry
    Регистрационный номерFc029718
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    Mr David William Wilson
    C/O Fishers Solicitors
    4-8 Kilwardby Street
    LE65 2FU Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    06 апр. 2016 г.
    C/O Fishers Solicitors
    4-8 Kilwardby Street
    LE65 2FU Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Да
    Гражданство: British
    Страна проживания: England
    Характер контроля
    • Лицо имеет право осуществлять или фактически осуществляет существенное влияние или контроль над компанией.
    Mr Richard William Henry Wilson
    157 Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Jarvis House
    England
    06 апр. 2016 г.
    157 Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Jarvis House
    England
    Да
    Гражданство: British
    Страна проживания: United Kingdom
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 25%, но не более 50% акций компании.
    Mr Robert Edward Charles Wilson
    157 Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Jarvis House
    England
    06 апр. 2016 г.
    157 Sadler Road
    LN6 3RS Lincoln
    Jarvis House
    England
    Да
    Гражданство: British
    Страна проживания: England
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 25%, но не более 50% акций компании.

    Есть ли у GPL 2024 REALISATIONS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 07 февр. 2020 г.
    Поставлен 13 февр. 2020 г.
    Не погашен
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    • Lloyds Udt Leasing LTD
    Транзакции
    • 13 февр. 2020 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 30 окт. 2019 г.
    Поставлен 05 нояб. 2019 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    N/A.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Secure Trust Bank PLC
    Транзакции
    • 05 нояб. 2019 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 19 мар. 2019 г.
    Поставлен 20 мар. 2019 г.
    Не погашен
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Close Leasing Limited
    Транзакции
    • 20 мар. 2019 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 12 июл. 2018 г.
    Поставлен 17 июл. 2018 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    Not applicable.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Secure Trust Bank PLC
    Транзакции
    • 17 июл. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 09 мар. 2018 г.
    Поставлен 14 мар. 2018 г.
    Не погашен
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Lombard North Central PLC
    Транзакции
    • 14 мар. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 20 сент. 2017 г.
    Поставлен 23 сент. 2017 г.
    Полностью погашен
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • United Trust Bank Limited
    Транзакции
    • 23 сент. 2017 г.Регистрация залога (MR01)
    • 29 авг. 2024 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 13 июл. 2017 г.
    Поставлен 25 июл. 2017 г.
    Полностью погашен
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Endless LLP (As Security Trustee)
    Транзакции
    • 25 июл. 2017 г.Регистрация залога (MR01)
    • 01 авг. 2018 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 13 июл. 2017 г.
    Поставлен 25 июл. 2017 г.
    Не погашен
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Endless LLP (As Security Trustee)
    Транзакции
    • 25 июл. 2017 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 13 июл. 2017 г.
    Поставлен 25 июл. 2017 г.
    Не погашен
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Andrew Cope (As Security Trustee)
    Транзакции
    • 25 июл. 2017 г.Регистрация залога (MR01)
    Debenture
    Создан 01 июн. 2012 г.
    Поставлен 08 июн. 2012 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 08 июн. 2012 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 04 февр. 2021 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Deposit agreement
    Создан 17 мая 2011 г.
    Поставлен 19 мая 2011 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The company with full title guarantee hereby charges by way of separate first fixed charge each of the items comprised within the deposit and all such respective rights to the repayment thereof as the company may have under the terms upon which the deposit was made as a continuing security for the payment to the bank of all money liabilities and other sums hereby agreed to be paid by the company to the bank see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 19 мая 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 01 окт. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Mortgage
    Создан 17 мар. 2011 г.
    Поставлен 19 мар. 2011 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    F/H land on west side of stafford park 13 stafford park telford shropshire t/no. SL28363 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 19 мар. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 15 авг. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Mortgage
    Создан 17 мар. 2011 г.
    Поставлен 19 мар. 2011 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    F/H property k/a 88 hawcliffe road granite way mountsorrell leicestershire t/no. LT244000 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 19 мар. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 14 июн. 2017 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Debenture
    Создан 21 февр. 2011 г.
    Поставлен 22 февр. 2011 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 22 февр. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 15 авг. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Legal charge
    Создан 21 июн. 2010 г.
    Поставлен 24 июн. 2010 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Land on the west side of stafford park telford t/no SL28363 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 24 июн. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 01 окт. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Legal charge
    Создан 25 нояб. 2004 г.
    Поставлен 02 дек. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H k/a land and buildings on the west side of paynes lane,nazeing t/no EX235704. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 02 дек. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 окт. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Legal charge
    Создан 25 нояб. 2004 г.
    Поставлен 02 дек. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H k/a 88 hawcliffe road,mountsorrel,leicestershire t/no LT244000. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 02 дек. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 окт. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Legal charge
    Создан 25 нояб. 2004 г.
    Поставлен 02 дек. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    L/H property being land lying to the south side of rossfield road ellesmere port t/no CH123250. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 02 дек. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 окт. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Debenture
    Создан 25 нояб. 2004 г.
    Поставлен 27 нояб. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 27 нояб. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 июл. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Legal charge
    Создан 01 мар. 2000 г.
    Поставлен 09 мар. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Land and buildings on the west side of paynes lane nazeing essex t/n-EX235704.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 09 мар. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 дек. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 01 мар. 2000 г.
    Поставлен 09 мар. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    88 hawcliffe road mountsorrel leicestershire t/n-LT244000.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 09 мар. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 дек. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 01 мар. 2000 г.
    Поставлен 09 мар. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Land and buildings lying to the west of bournemouth road, chandlers ford, hampshire. T/no. HP386254.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 09 мар. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 дек. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee & debenture
    Создан 22 окт. 1999 г.
    Поставлен 30 окт. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or shropshire roadsweepers limited to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 30 окт. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 дек. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Memorandum of deposit of stocks and shares
    Создан 22 окт. 1999 г.
    Поставлен 30 окт. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The depositor declared that the stocks shares bonds debentures or other securities deposited with or transferred to the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 30 окт. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 дек. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 30 июн. 1999 г.
    Поставлен 12 июл. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The freehold property k/a land & buildings to the west of bournemouth road chandlers ford hampshire t/l no hp 386254. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 12 июл. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 дек. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у GPL 2024 REALISATIONS LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    03 мая 2024 г.Начало управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Jonathan Charles Marston
    Suite 3 Regency House 91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    East Sussex
    Практик
    Suite 3 Regency House 91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    East Sussex
    Michael Thomas Denny
    Suite 3 Regency House
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    Практик
    Suite 3 Regency House
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0