BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Годовая отчетность
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииBRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03156768
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?

    • Прочая аренда и эксплуатация собственной или арендованной недвижимости (68209) / Операции с недвижимым имуществом

    Где находится BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?

    Юридический адрес
    c/o BRUNTWOOD LIMITED
    York House
    York Street
    M2 3BB Manchester
    England
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    SLATERSHELFCO 312 LIMITED08 февр. 1996 г.08 февр. 1996 г.

    Каковы последние отчеты BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 сент. 2014 г.

    Каков статус последней годовой декларации для BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?

    Годовая отчетность
    Последняя годовая отчетность

    Какие последние документы подавались BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Юридический адрес изменен с C/O Bruntwood Limited City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT на C/O Bruntwood Limited York House York Street Manchester M2 3BB 07 июн. 2016 г.

    1 страницыAD01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital09 февр. 2016 г.

    Отчет о капитале на 09 февр. 2016 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением для малых предприятий

    5 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital12 февр. 2015 г.

    Отчет о капитале на 12 февр. 2015 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением для малых предприятий

    5 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital20 февр. 2014 г.

    Отчет о капитале на 20 февр. 2014 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Изменение данных директора для Mr Kevin James Crotty 28 июн. 2013 г.

    2 страницыCH01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением для малых предприятий

    5 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01

    Назначение Mr Kevin James Crotty на должность директора

    2 страницыAP01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением для малых предприятий

    5 страницыAA

    Прекращение полномочий Andrew Allan в качестве директора

    1 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01

    Юридический адрес изменен с * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT United Kingdom* 21 дек. 2011 г.

    1 страницыAD01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением для малых предприятий

    5 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01

    Прекращение полномочий Robert Yates в качестве директора

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Richard Malin в качестве директора

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Iain Grant в качестве директора

    1 страницыTM01

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением для малых предприятий

    5 страницыAA

    Юридический адрес изменен с * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BD* 10 мар. 2010 г.

    1 страницыAD01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01

    Кто является должностными лицами BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    VOKES, Katharine Jane
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Секретарь
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    British96739300002
    CROTTY, Kevin James
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Директор
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    EnglandBritish117797270004
    OGLESBY, Christopher George
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Директор
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritish53530470002
    OGLESBY, Michael John
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Директор
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritish148307320001
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Секретарь
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    British2582690002
    ORRELL, Jeremy Peter
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    Номинированный секретарь
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    British900005190001
    ALLAN, Andrew John
    c/o Bruntwood Limited
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Директор
    c/o Bruntwood Limited
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish80043450001
    DUNN, Christopher Frank
    4 Ashcroft Close
    SK9 1RB Wilmslow
    Cheshire
    Номинированный директор
    4 Ashcroft Close
    SK9 1RB Wilmslow
    Cheshire
    British900005180001
    GRANT, Iain James
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Директор
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish45918940003
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Директор
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    United KingdomBritish2582690002
    MALIN, Richard William
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Директор
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish48153170001
    OGLESBY, Jean Davies
    Moss Farm Southdowns Road
    Bowdon
    WA14 3DR Altrincham
    Cheshire
    Директор
    Moss Farm Southdowns Road
    Bowdon
    WA14 3DR Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish29553390001
    ORRELL, Jeremy Peter
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    Номинированный директор
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    British900005190001
    YATES, Robert David
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Директор
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    EnglandBritish30535590006

    Есть ли у BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    B2000 borrower security agreement
    Создан 06 февр. 2007 г.
    Поставлен 20 февр. 2007 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Borrower Security Trustee) (Whether from Its Own Account Oras Trustee for the Borrower Secured Creditors)
    Транзакции
    • 20 февр. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 06 дек. 2001 г.
    Поставлен 18 дек. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee and/or the banks and each of them whether actually or contingently and whether solely or jointly with any other or others in partnership or otherwise or in any other manner whatsoever and also all monies and liabilities which shall for the time being be due or to become due from bruntwood estates limited and/or bruntwood 2000 first properties limited to the chargee and/or the banks and each of them whether actually or contingently and whether solely or jointly with any other or others in partnership and on any account or in any other manner whatsoever
    Краткое описание
    The property being freehold property known as fanum house (now known as landmark house) station road cheadle hulme stockport greater manchester title number GM76157 leasehold property known as land being part of fanum house (now known as landmark house) title number GM682291 for further details of the property please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks
    Транзакции
    • 18 дек. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 июл. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of supplemental charge
    Создан 02 февр. 2000 г.
    Поставлен 18 февр. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    (A) all monies and liabilties due or to become due from the company to lloyds tsb bank PLC, capital markets (the "agent") and/or the banks and each of them on any account whatsoever and (b) the third party liabilities (as defined)
    Краткое описание
    By way of first legal mortgage l/h land k/a north tower (formerly k/a highland house) victoria bridge street and 19 chapel street salford greater manchester. By way of first fixed charge all plant machinery implements building materials furniture and equipment; by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils building materials furniture and equipment.. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 18 февр. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 июл. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 20 сент. 1996 г.
    Поставлен 30 сент. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a credit agreement dated 20/9/96 and the finance documents (as defined)
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks (As Defined)
    Транзакции
    • 30 сент. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 июл. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 31 мая 1996 г.
    Поставлен 13 июн. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fanum house station road cheadle hulme greater manchester t/no GM676157 and GM682291 with the goodwill of the business and. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 13 июн. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 07 нояб. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 31 мая 1996 г.
    Поставлен 06 июн. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £262,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal charge
    Краткое описание
    Fanum house, station road, cheadle hume, greater manchester.
    Уполномоченные лица
    • The Automobile Association Limited
    Транзакции
    • 06 июн. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 19 июл. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 29 мая 1996 г.
    Поставлен 04 июн. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fittings fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 04 июн. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 07 нояб. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0