TRANSACSYS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииTRANSACSYS LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03221130
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель TRANSACSYS LIMITED?

    • (7260) /

    Где находится TRANSACSYS LIMITED?

    Юридический адрес
    Davidson House
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Cheshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия TRANSACSYS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    TRANSACSYS PLC06 апр. 2000 г.06 апр. 2000 г.
    GIROVEND CASHLESS SYSTEMS PLC21 февр. 1997 г.21 февр. 1997 г.
    ROBINBUY PLC05 июл. 1996 г.05 июл. 1996 г.

    Каковы последние отчеты TRANSACSYS LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 сент. 2009 г.

    Какие последние документы подавались TRANSACSYS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Годовой отчет с массовым списком акционеров

    16 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital22 июл. 2010 г.

    Отчет о капитале на 22 июл. 2010 г.

    • Капитал: GBP 2,428,705.65
    SH01

    Регистры перемещены в место для ознакомления с регистрами

    1 страницыAD03

    Регистры перемещены в место для ознакомления с регистрами

    1 страницыAD03

    Регистры перемещены в место для ознакомления с регистрами

    1 страницыAD03

    Регистры перемещены в место для ознакомления с регистрами

    1 страницыAD03

    Регистры перемещены в место для ознакомления с регистрами

    1 страницыAD03

    Регистры перемещены в место для ознакомления с регистрами

    1 страницыAD03

    Адрес для ознакомления с регистрами изменен

    1 страницыAD02

    Бухгалтерская отчетность с полным освобождением

    16 страницыAA

    Прекращение полномочий Peter Smyth в качестве директора

    2 страницыTM01

    legacy

    8 страницы363a

    legacy

    8 страницы363a

    legacy

    8 страницы363a

    legacy

    7 страницы363a

    legacy

    2 страницы288a

    legacy

    1 страницы288b

    Годовая бухгалтерская отчетность

    14 страницыAA

    legacy

    3 страницы288a

    legacy

    1 страницы288b

    Годовая бухгалтерская отчетность

    13 страницыAA

    legacy

    2 страницы288a

    legacy

    1 страницы288a

    Кто является должностными лицами TRANSACSYS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    HOGAN, Brenda Mary
    Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road Sandyford
    Dublin 18
    Apartment 55,
    Ireland
    Секретарь
    Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road Sandyford
    Dublin 18
    Apartment 55,
    Ireland
    Other130814140001
    EDWARDS, Mark Simon
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    Директор
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    British109659860001
    MALONEY, Michael John
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    Директор
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrish161364970001
    FIETH, Robin Paul
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    Секретарь
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    British49907850002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Секретарь
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    English107835250001
    HARRINGTON, Michael
    28 Arlington Avenue
    N1 7AX London
    Секретарь
    28 Arlington Avenue
    N1 7AX London
    British42936520001
    KATZ, Peter David
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    Секретарь
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    British64682050001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Секретарь
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    British42734310002
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Секретарь
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    British116252510001
    PECK, Martin David
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    Секретарь
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    British78149370002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Номинированный секретарь
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ALLEN, Matthew Charles
    75 Park Road
    W4 3EY London
    Директор
    75 Park Road
    W4 3EY London
    EnglandBritish37599910001
    BEERLING, Kevin Michael
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    Директор
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    United KingdomBritish64677850002
    BRIGHT, Keith, Sir
    16 Westbourne Park Villas
    W2 5EA London
    Директор
    16 Westbourne Park Villas
    W2 5EA London
    United KingdomBritish1770160001
    CLARK, Ronald Thomson
    Gill House
    Runsell Green, Danbury
    CM3 4QZ Chelmsford
    Essex
    Директор
    Gill House
    Runsell Green, Danbury
    CM3 4QZ Chelmsford
    Essex
    British69705410001
    CLYDE, James Donald Laurence
    12 Arundel Gardens
    W11 2LA London
    Greater London
    Директор
    12 Arundel Gardens
    W11 2LA London
    Greater London
    British54439570001
    DITCHBURN, John Blackett Dennison
    The Laurels
    Frieth
    RG9 6PJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Директор
    The Laurels
    Frieth
    RG9 6PJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British61233990002
    FIETH, Robin Paul
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    Директор
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    EnglandBritish49907850002
    GAHAGNON, Jacques Andre
    92 Place Louvois
    Velizy
    78140
    France
    Директор
    92 Place Louvois
    Velizy
    78140
    France
    French68163380001
    GOVETT, Nigel Jeremy Cloudesley
    15 Tantallon Court
    Woodstone Village
    DH4 6TJ Houghton Le Spring
    County Durham
    Директор
    15 Tantallon Court
    Woodstone Village
    DH4 6TJ Houghton Le Spring
    County Durham
    British89929500001
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Директор
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish107835250001
    LAING, Andrew Murray
    14 Petley Road
    W6 9ST London
    Директор
    14 Petley Road
    W6 9ST London
    British28771390001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Директор
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish42734310002
    MASSEY, Peter Derek
    Pullington House Pullington Cottages
    Benenden
    TN17 4EH Cranbrook
    Kent
    Директор
    Pullington House Pullington Cottages
    Benenden
    TN17 4EH Cranbrook
    Kent
    British42440170003
    MCGRANE, Paul Steven
    21 Stony Lane
    NR10 4QS Reepham
    Norwich
    Директор
    21 Stony Lane
    NR10 4QS Reepham
    Norwich
    United KingdomBritish51004210002
    MCNAIR, Iain
    23 Mycenae Road
    SE3 7SF London
    Greater London
    Директор
    23 Mycenae Road
    SE3 7SF London
    Greater London
    British85499250001
    MCNAIR, John
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    Директор
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    British61297520001
    MILLS, Mark Richard
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    Директор
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    British10402540005
    MURPHY, James Timmerman
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    Директор
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    American130237490001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Директор
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    EnglandBritish116252510001
    NEWMARCH, Michael George
    7 The Bromptons
    Rose Square
    SW3 6RS London
    Директор
    7 The Bromptons
    Rose Square
    SW3 6RS London
    British1109560005
    PECK, Martin David
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    Директор
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    EnglandBritish78149370002
    SALMON, Claire Louise
    Flat 2
    47 Montagu Square
    W1H 1TH London
    Директор
    Flat 2
    47 Montagu Square
    W1H 1TH London
    British70197550002
    SAXTON, Paul
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    Директор
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    British121726830001
    SMART, Richard Ernest
    Oak House,Webbs Lane
    Beenham
    RG7 5LL Reading
    Berkshire
    Директор
    Oak House,Webbs Lane
    Beenham
    RG7 5LL Reading
    Berkshire
    British7970090001

    Есть ли у TRANSACSYS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Accession deed to an intercreditor deed
    Создан 21 февр. 2006 г.
    Поставлен 07 мар. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any member of the group to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By clause 5.1 (turnover: turnover obligations) of the deed until after the discharge date if the additional obligor receives or recovers any intra-group recoveries except for any permitted intra-group payments, it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the chargee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the chargee, the additional obligor shall hold the same on trust for the application by the chargee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 07 мар. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 20 дек. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Syndicated debenture
    Создан 21 февр. 2006 г.
    Поставлен 07 мар. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Trustee for Thebeneficiaries
    Транзакции
    • 07 мар. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 20 дек. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 12 июл. 2005 г.
    Поставлен 15 июл. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All land (other than the short l/h land) rights in atm equipment, all other plant, machinery, vehicles and other equipment used in a business, investments; any contract entered into after the date of the debenture which is designated as a key contract by moneybox PLC and the chargee, any account, all copyright, any monetary claim of any kind and goodwill and uncalled capital, floating charge the company's undertaking and all its present and future assets;. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Транзакции
    • 15 июл. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 21 окт. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Rent deposit deed
    Создан 15 окт. 1999 г.
    Поставлен 27 мар. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company (formerly known as girovend cashless systems PLC) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All rights, title and interest in the assigned cash (as defined in the rent deposit deed) and the debts represented by it.
    Уполномоченные лица
    • Madge Networks Limited
    Транзакции
    • 27 мар. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 14 февр. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 25 февр. 1997 г.
    Поставлен 11 мар. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from all or any of the companies mentioned therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All f/h and l/h land in england and wales now vested in the company including (but not limited to) the property at unit 6 (formerly unit B4) progress business centre,whittle parkway,bath road,slough t/no.bk 266697. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 11 мар. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 июл. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0