VICKERS ELECTRONICS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииVICKERS ELECTRONICS LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03227029
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель VICKERS ELECTRONICS LIMITED?

    • Производство прочего электрического оборудования (27900) / Обрабатывающая промышленность

    Где находится VICKERS ELECTRONICS LIMITED?

    Юридический адрес
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия VICKERS ELECTRONICS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    HELPDEAN LIMITED19 июл. 1996 г.19 июл. 1996 г.

    Каковы последние отчеты VICKERS ELECTRONICS LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 июл. 2015 г.

    Какие последние документы подавались VICKERS ELECTRONICS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Уведомление о переходе от администрации к роспуску

    38 страницыAM23

    Прекращение полномочий Stephen Martin Blank в качестве директора 17 янв. 2018 г.

    1 страницыTM01

    Отчет о ходе администрации

    44 страницыAM10

    Уведомление о предполагаемом одобрении предложений

    3 страницыAM06

    Заявление о состоянии дел с приложенной формой AM02SOA

    16 страницыAM02

    Заявление о предложениях администратора

    108 страницыAM03

    Юридический адрес изменен с Unit 14 Westpoint Enterprise Park Clarence Avenue Trafford Park Manchester M17 1QS на C/O Duff & Phelps Ttd the Chancery 58 Spring Gardens Manchester M2 1EW 06 июн. 2017 г.

    2 страницыAD01

    Назначение администратора

    3 страницыAM01

    Полное погашение обременения 12

    1 страницыMR04

    Уведомление о подтверждении, составленное 19 июл. 2016 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Регистрация обременения 032270290014, создано 08 июн. 2016 г.

    34 страницыMR01

    Прекращение полномочий David James Hilton в качестве директора 13 мая 2016 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Alison Jacqueline Hilton в качестве директора 13 мая 2016 г.

    1 страницыTM01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    20 страницыAA

    Регистрация обременения 032270290013, создано 29 февр. 2016 г.

    38 страницыMR01

    Назначение Mr Raymond David Breckon на должность директора 28 июл. 2015 г.

    2 страницыAP01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital29 июл. 2015 г.

    Отчет о капитале на 29 июл. 2015 г.

    • Капитал: GBP 177
    SH01

    Назначение Mr Peter Andrew Turnbull на должность секретаря 28 июл. 2015 г.

    2 страницыAP03

    Прекращение полномочий David James Hilton в качестве секретаря 28 июл. 2015 г.

    1 страницыTM02

    Прекращение полномочий Nicholas Richard Duncan Owen в качестве директора 05 июн. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    17 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital23 июл. 2014 г.

    Отчет о капитале на 23 июл. 2014 г.

    • Капитал: GBP 177
    SH01

    Изменение данных директора для David James Hilton 19 июл. 2014 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Alison Jacqueline Hilton 19 июл. 2014 г.

    2 страницыCH01

    Кто является должностными лицами VICKERS ELECTRONICS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    TURNBULL, Peter Andrew
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    Секретарь
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    199769460001
    BRECKON, Raymond David
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    Директор
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    EnglandBritishCompany Director70834670002
    THOMAS, Wayne
    Park Clarence Avenue
    Trafford Park
    M17 1QS Manchester
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    United Kingdom
    Директор
    Park Clarence Avenue
    Trafford Park
    M17 1QS Manchester
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector161712760001
    BARLOW, Ian
    11 Durnford Close
    Norden
    OL12 7RX Rochdale
    Greater Manchester
    Секретарь
    11 Durnford Close
    Norden
    OL12 7RX Rochdale
    Greater Manchester
    BritishDirector74332640001
    HILTON, David James
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    Секретарь
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    BritishCompany Director107482670001
    LEUTTON, John Frederick
    5 The Retreat
    Romiley
    SK6 3LF Stockport
    Cheshire
    Секретарь
    5 The Retreat
    Romiley
    SK6 3LF Stockport
    Cheshire
    BritishDirector9181840002
    WYSE, Ewan Gordon
    6 Ruins Lane
    Harwood
    BL2 3JG Bolton
    Секретарь
    6 Ruins Lane
    Harwood
    BL2 3JG Bolton
    British84738140001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Номинированный секретарь
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BARLOW, Ian
    11 Durnford Close
    Norden
    OL12 7RX Rochdale
    Greater Manchester
    Директор
    11 Durnford Close
    Norden
    OL12 7RX Rochdale
    Greater Manchester
    BritishDirector74332640001
    BERRY, Keith
    40 Wood Hey Grove
    Skye
    OL12 9UA Rochdale
    Lancashire
    Директор
    40 Wood Hey Grove
    Skye
    OL12 9UA Rochdale
    Lancashire
    EnglandBritishDirector60151490001
    BLANK, Stephen Martin
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    Директор
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    United KingdomBritishDirector5733490001
    CAMERON, Ian Thomas
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    Директор
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    United KingdomBritishDirector156147320001
    HILTON, Alison Jacqueline
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    Директор
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    United KingdomBritishSales Manager117736760003
    HILTON, David James
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    Директор
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    EnglandBritishCompany Director107482670005
    HILTON-TAPP, David
    9 Bayliss Close
    N21 1SP London
    Директор
    9 Bayliss Close
    N21 1SP London
    BritishDirector67068110003
    HOYLE, John Roger Horrocks
    The Riggs
    Victoria Road Heaton
    BL1 5AN Bolton
    Директор
    The Riggs
    Victoria Road Heaton
    BL1 5AN Bolton
    EnglandBritishCompany Director3986300001
    LEUTTON, John Frederick
    5 The Retreat
    Romiley
    SK6 3LF Stockport
    Cheshire
    Директор
    5 The Retreat
    Romiley
    SK6 3LF Stockport
    Cheshire
    BritishDirector9181840002
    OWEN, Nicholas Richard Duncan
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    Директор
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    United KingdomBritishDirector1800950002
    THACKRAY, Adam Matthew
    Orchard Drive
    WA15 8BB Hale
    13
    Cheshire
    Директор
    Orchard Drive
    WA15 8BB Hale
    13
    Cheshire
    United KingdomBritishOperations Manager117737630002
    THACKRAY, Simon
    St Johns Avenue
    WA16 1DH Knutsford
    1
    Cheshire
    Uk
    Директор
    St Johns Avenue
    WA16 1DH Knutsford
    1
    Cheshire
    Uk
    EnglandBritishDirector67197060005
    WYSE, Ewan Gordon
    6 Ruins Lane
    Harwood
    BL2 3JG Bolton
    Директор
    6 Ruins Lane
    Harwood
    BL2 3JG Bolton
    EnglandBritishAccountant84738140001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Номинированный директор
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над VICKERS ELECTRONICS LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Business Engagement Limited
    Westpoint Enterprise Park, Clarence Avenue
    Trafford Park
    M17 1QS Manchester
    Unit 14
    England
    06 апр. 2016 г.
    Westpoint Enterprise Park, Clarence Avenue
    Trafford Park
    M17 1QS Manchester
    Unit 14
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаPrivate Limited Company
    Страна регистрацииEngland
    Юридическое основаниеCompanies Act 2006
    Место регистрацииEngland And Wales
    Регистрационный номер05488174
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.

    Есть ли у VICKERS ELECTRONICS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 08 июн. 2016 г.
    Поставлен 22 июн. 2016 г.
    Не погашен
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Enterprise Ventures Growth Fund LP
    Транзакции
    • 22 июн. 2016 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 29 февр. 2016 г.
    Поставлен 02 мар. 2016 г.
    Не погашен
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Evbl(General Partner Ev Sme Loans) Limited
    Транзакции
    • 02 мар. 2016 г.Регистрация залога (MR01)
    Debenture
    Создан 13 июл. 2011 г.
    Поставлен 21 июл. 2011 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Транзакции
    • 21 июл. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 07 апр. 2017 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Guarantee & debenture
    Создан 13 июл. 2011 г.
    Поставлен 19 июл. 2011 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee and any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Enterprise Ventures Growth Fund LP (The "Security Trustee")
    Транзакции
    • 19 июл. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    Assignment of life policy
    Создан 12 янв. 2007 г.
    Поставлен 17 янв. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The policy in respect of alison bagnall, policy no: L0195619092DQ with aegon scottish equitable in the sum of £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 17 янв. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 19 апр. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Assignment of life policy
    Создан 12 янв. 2007 г.
    Поставлен 17 янв. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The policy in respect of david hilton, policy no: L0198455092DX with aegon scottish equitable in the sum of £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 17 янв. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 19 апр. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Assignment of life policy
    Создан 12 янв. 2007 г.
    Поставлен 17 янв. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The policy in respect of simon thackray, policy no: 223890 with lutine assurance services limited in the sum of £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 17 янв. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 19 апр. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Debenture
    Создан 12 янв. 2007 г.
    Поставлен 17 янв. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 17 янв. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 16 авг. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Deed of assignment of keyman life policy
    Создан 09 авг. 2005 г.
    Поставлен 19 авг. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Legal and general policy number 011443517-5 dated 4 july 2005 for the sum of £100,000 life assured david hilton together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 19 авг. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 27 сент. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Deed of assignment of keyman life policy
    Создан 09 авг. 2005 г.
    Поставлен 19 авг. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Lutine assurance services limited policy number 219871 dated 29 june 2005 for the sum of £200,000 life assured simon thackray together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 19 авг. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 19 апр. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Deed of assignment of keyman life policy
    Создан 09 авг. 2005 г.
    Поставлен 19 авг. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Its title right and interest in the policy. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 19 авг. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 27 сент. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Debenture
    Создан 09 авг. 2005 г.
    Поставлен 19 авг. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 19 авг. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 19 апр. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Mortgage debenture
    Создан 01 нояб. 1999 г.
    Поставлен 04 нояб. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 04 нояб. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 авг. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 04 нояб. 1996 г.
    Поставлен 06 нояб. 1996 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the finance documents (as defined) and/or on any other account whatsoever
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Mr David Russell
    Транзакции
    • 06 нояб. 1996 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 авг. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у VICKERS ELECTRONICS LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    19 апр. 2017 г.Начало управления
    22 мар. 2018 г.Окончание управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Sarah Helen Bell
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Практик
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Steven Muncaster
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Практик
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0