ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииECD (COOKHAM WOOD) LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03241233
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?

    • Строительство коммерческих зданий (41201) / Строительство
    • Техническое и профессиональное среднее образование (85320) / Образование

    Где находится ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?

    Юридический адрес
    C/O Smith & Williamson Llp Portwall Place
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Каковы последние отчеты ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 мар. 2016 г.

    Какие последние документы подавались ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    14 страницыLIQ13

    Изменение данных директора для Mr Chris Burlton 26 янв. 2018 г.

    2 страницыCH01

    Юридический адрес изменен с Third Floor Broad Quay House Prince Street Bristol BS1 4DJ на C/O Smith & Williamson Llp Portwall Place Portwall Lane Bristol BS1 6NA 15 июн. 2017 г.

    2 страницыAD01

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Заявление о платежеспособности

    5 страницыLIQ01

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 30 мая 2017 г.

    LRESSP

    Изменение данных секретаря для Semperian Secretariat Services Limited 19 мая 2017 г.

    1 страницыCH04

    Прекращение полномочий Alan Campbell Ritchie в качестве директора 31 мар. 2017 г.

    1 страницыTM01

    Полное погашение обременения 6

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 3

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 2

    2 страницыMR04

    Полное погашение обременения 1

    2 страницыMR04

    Полное погашение обременения 5

    1 страницыMR04

    Годовая бухгалтерская отчетность

    16 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital28 июн. 2016 г.

    Отчет о капитале на 28 июн. 2016 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Прекращение полномочий Paul Roger Cook в качестве директора 18 мая 2016 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Gawie Murray Nienaber в качестве директора 18 мая 2016 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий John Parker в качестве директора 18 мая 2016 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Vaishali Jagdish Patel в качестве директора 18 мая 2016 г.

    1 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    9 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital24 авг. 2015 г.

    Отчет о капитале на 24 авг. 2015 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Изменение данных директора для Mr Paul Roger Cook 01 июл. 2015 г.

    2 страницыCH01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    18 страницыAA

    Назначение Mr Chris Burlton на должность директора 02 дек. 2014 г.

    2 страницыAP01

    Назначение Mrs Vaishali Jagdish Patel на должность директора 17 нояб. 2014 г.

    2 страницыAP01

    Кто является должностными лицами ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    SEMPERIAN SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    4th Floor
    United Kingdom
    Секретарь компании
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    4th Floor
    United Kingdom
    107624260005
    BURLTON, Chris
    Broad Quay House
    Prince Street
    BS1 4DJ Bristol
    Third Floor
    United Kingdom
    Директор
    Broad Quay House
    Prince Street
    BS1 4DJ Bristol
    Third Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish191923330001
    ANDERSON, David Alexander John
    4 Elm Tree Avenue
    KT10 8JG Esher
    Surrey
    Секретарь
    4 Elm Tree Avenue
    KT10 8JG Esher
    Surrey
    British94497310001
    BARLOW, Suzanne
    22 Monteagle Drive
    DY6 7RY Kingswinford
    West Midlands
    Секретарь
    22 Monteagle Drive
    DY6 7RY Kingswinford
    West Midlands
    British49252810001
    HERZBERG, Francis Robin
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    Секретарь
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    British52429400001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Номинированный секретарь
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ANDERSON, David Alexander John
    4 Elm Tree Avenue
    KT10 8JG Esher
    Surrey
    Директор
    4 Elm Tree Avenue
    KT10 8JG Esher
    Surrey
    British94497310001
    BANKS, Andrew David
    St. Marys
    Cowl Lane, Winchcombe
    GL54 5RA Cheltenham
    Gloucestershire
    Директор
    St. Marys
    Cowl Lane, Winchcombe
    GL54 5RA Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish164295230001
    BIRCH, Alan Edward
    Broad Quay House
    Prince Street
    BS1 4DJ Bristol
    Third Floor
    United Kingdom
    Директор
    Broad Quay House
    Prince Street
    BS1 4DJ Bristol
    Third Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish90700330001
    BIRCH, Alan Edward
    7 Silsbury Grove
    Standish
    WN6 0EY Wigan
    Lancashire
    Директор
    7 Silsbury Grove
    Standish
    WN6 0EY Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish90700330001
    BROWN, Matthew Charles
    Southside
    105 Victoria Street
    SW1E 6QT London
    G4s
    England
    England
    Директор
    Southside
    105 Victoria Street
    SW1E 6QT London
    G4s
    England
    England
    EnglandBritish181465860001
    BROWN, Stephen Richard
    8 Arbour Close
    GL55 6RR Mickleton
    Gloucestershire
    Директор
    8 Arbour Close
    GL55 6RR Mickleton
    Gloucestershire
    British15085940005
    COOK, Paul Roger
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    United Kingdom
    Директор
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    United Kingdom
    UkBritish117120110001
    DALGLEISH, Bruce Warren
    Post Box House
    Abinger Road
    RH5 6HD Coldharbour
    Surrey
    Директор
    Post Box House
    Abinger Road
    RH5 6HD Coldharbour
    Surrey
    United KingdomBritish106281140002
    DALGLEISH, Bruce Warren
    Post Box House
    Abinger Road
    RH5 6HD Coldharbour
    Surrey
    Директор
    Post Box House
    Abinger Road
    RH5 6HD Coldharbour
    Surrey
    United KingdomBritish106281140002
    ELLIOTT, Christopher
    Woodcote House
    Broad Lane Bishampton
    WR10 2LY Pershore
    Worcestershire
    Директор
    Woodcote House
    Broad Lane Bishampton
    WR10 2LY Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritish64082070001
    FARLEY, Graham
    9 Manor Close
    Hinstock
    TF9 2TZ Market Drayton
    Salop
    Директор
    9 Manor Close
    Hinstock
    TF9 2TZ Market Drayton
    Salop
    United KingdomBritish183764380001
    GILBEY, Hannah
    14 Dane Park
    CM23 2PR Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Директор
    14 Dane Park
    CM23 2PR Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British78180430001
    GIRLING, Christopher Francis
    12 Spithead Close
    PO34 5AZ Seaview
    Isle Of Wight
    Директор
    12 Spithead Close
    PO34 5AZ Seaview
    Isle Of Wight
    British67125270002
    HARROWER, James Arthur
    24 Lifford Gardens
    WR12 7DA Broadway
    Worcestershire
    Директор
    24 Lifford Gardens
    WR12 7DA Broadway
    Worcestershire
    British12257110001
    HERZBERG, Francis Robin
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    Директор
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    EnglandBritish52429400001
    HERZBERG, Francis Robin
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    Директор
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    EnglandBritish52429400001
    JONES, Stuart Nigel
    23 Old Farm Drive
    Codsall
    WV8 1GF Wolverhampton
    West Midlands
    Директор
    23 Old Farm Drive
    Codsall
    WV8 1GF Wolverhampton
    West Midlands
    British79744320001
    LAVERS, Michael John
    2 Binden Road
    W12 9RJ London
    Директор
    2 Binden Road
    W12 9RJ London
    EnglandBritish3090450001
    MALMBERG, Louis Joannes
    Scheveningseslag 87
    2586 KW The Hague
    Netherlands
    Директор
    Scheveningseslag 87
    2586 KW The Hague
    Netherlands
    Dutch45086130001
    MCCORMACK, James Joseph
    Broome House
    Chapel Lane Knockin Heath
    SY10 8EB Oswestry
    Shropshire
    Директор
    Broome House
    Chapel Lane Knockin Heath
    SY10 8EB Oswestry
    Shropshire
    British678610003
    MCCULLOCH, Paul
    33 Southwood Avenue
    Highgate
    N6 5SA London
    Директор
    33 Southwood Avenue
    Highgate
    N6 5SA London
    British101810930001
    MCEWAN, Euan
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    Директор
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    British110597480001
    MORGAN, David Keir Ewart
    Care And Justice
    5th Floor, Southside 105 Victoria Street
    SW1E 6QT London
    G4s
    England
    England
    Директор
    Care And Justice
    5th Floor, Southside 105 Victoria Street
    SW1E 6QT London
    G4s
    England
    England
    EnglandBritish106484320002
    MORRIS, Richard
    Old Park Lane
    M41 7HA Manchester
    1
    United Kingdom
    Директор
    Old Park Lane
    M41 7HA Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish159675380001
    NIENABER, Gawie Murray
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    England
    England
    Директор
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    England
    England
    EnglandBritish187146260001
    OSBORNE, Robert Charles
    Heath View
    Bromstead Common
    TF10 9DG Newport
    Shropshire
    Директор
    Heath View
    Bromstead Common
    TF10 9DG Newport
    Shropshire
    British68448420001
    PARKER, John
    Chalgrove Field
    Oakhill
    MK5 6AJ Milton Keynes
    Oakhill Stc
    England
    England
    Директор
    Chalgrove Field
    Oakhill
    MK5 6AJ Milton Keynes
    Oakhill Stc
    England
    England
    United KingdomEnglish182836610001
    PATEL, Vaishali Jagdish
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    United Kingdom
    Директор
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    United Kingdom
    United KingdomBritish192721880001
    PELLARD, Brian
    33 Wyvern Road
    B74 2PS Sutton Coldfield
    West Midlands
    Директор
    33 Wyvern Road
    B74 2PS Sutton Coldfield
    West Midlands
    British33408310001

    Есть ли у ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Legal charge
    Создан 19 нояб. 2004 г.
    Поставлен 24 нояб. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    L/H property k/a cookham wood secure training centre cookham wood rochester kent.
    Уполномоченные лица
    • Abn Amro Bank N.V.
    Транзакции
    • 24 нояб. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 20 мая 2011 г.Заявление, что часть или все имущество, обремененное залогом, освобождено (MG04)
    • 21 мар. 2017 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Supplemental fixed charge
    Создан 31 янв. 2002 г.
    Поставлен 20 февр. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All right title and interest in and to the equipment including all moneyspayable and the proceeds of any claims awards or judgements together with interest. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Her Majesty's Principal Secretary of State for the Home Department (Including His Successors or Assigns or the Person Deriving Title Through or Under Him in Whole or in Part and Whether at Law or in Equity)
    Транзакции
    • 20 февр. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 февр. 2017 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Mortgage
    Создан 31 янв. 2002 г.
    Поставлен 20 февр. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The sums payable by her majesty's principal secretary of state for the home department (the "authority") to the company pursuant to schedule u of an agreement (the "dcmf contract") dated 3RD march 1997 between the mortgagor and the authority for the design construction maintenance and operation of a secure training centre at medway kent.
    Уполномоченные лица
    • Carillion Construction Limited
    Транзакции
    • 20 февр. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 нояб. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Fixed and floating charge debenture
    Создан 03 мар. 1997 г.
    Поставлен 10 мар. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any banks financing document
    Краткое описание
    .Leasehold property known as cookham wood, rochester, kent.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Abn Amro Bank N.V.(As Trustee for the Bank Secured Creditors)
    Транзакции
    • 10 мар. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 11 мая 2011 г.Заявление, что часть или все имущество, обремененное залогом, освобождено (MG04)
    • 21 мар. 2017 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 03 мар. 1997 г.
    Поставлен 10 мар. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or connection with any banks financing document
    Краткое описание
    All that leasehold property knoen as cookham wood secure training centre, cookham wood, rochester, kent.. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Abn Amro Bank N.V.(As Trustee for the Banks Secured Creditors)
    Транзакции
    • 10 мар. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 11 мая 2011 г.Заявление, что часть или все имущество, обремененное залогом, освобождено (MG04)
    • 21 мар. 2017 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Deed of fixed charge
    Создан 03 мар. 1997 г.
    Поставлен 08 мар. 1997 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    The obligation of the company owed to the chargee under or pursuant to clause 17.2 of the agreement dated 3RD march 1997 between the chargee and the company (as therein defined) ("the dcmf contract") to transfer title to the equipment (as therein defined) upon termination of the "dcmf contract" together with any damages payable by the company to the chargee by reason of a failure to comply with clause 17.2 of the "dcmf contract"
    Краткое описание
    All the company's right title and interest (present and future) to and in the equipment being all the property referred to in schedule b of the dcmf contract and all the plant machinery and other equipment referred to in schedule a of the dcmf contract by way of first fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Her Majesty's Principal Secretary of State for the Home Department(Including His Successors or Assigns or the Person Deriving Title Through or Under Him in Wholeor in Part and Whether at Law or in Equity)
    Транзакции
    • 08 мар. 1997 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 февр. 2017 г.Удовлетворение залога (MR04)

    Есть ли у ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    30 мая 2017 г.Начало ликвидации
    02 мая 2018 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Gilbert J Lemon
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Avon
    Практик
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Avon
    Richard Lewis
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Практик
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0