COACH HOLIDAY GROUP LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииCOACH HOLIDAY GROUP LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03353865
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель COACH HOLIDAY GROUP LIMITED?

    • Прочие вспомогательные услуги для бизнеса, не включенные в другие группировки (82990) / Административные и вспомогательные услуги

    Где находится COACH HOLIDAY GROUP LIMITED?

    Юридический адрес
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия COACH HOLIDAY GROUP LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    WALLACE ARNOLD GROUP LIMITED09 июл. 1997 г.09 июл. 1997 г.
    INHOCO 640 LIMITED16 апр. 1997 г.16 апр. 1997 г.

    Каковы последние отчеты COACH HOLIDAY GROUP LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2018 г.

    Какие последние документы подавались COACH HOLIDAY GROUP LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации кредиторов

    12 страницыLIQ14

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 21 мая 2021 г.

    10 страницыLIQ03

    Прекращение полномочий a G Secretarial Limited в качестве секретаря 22 мар. 2020 г.

    2 страницыTM02

    Юридический адрес изменен с Waterside House Waterside Drive Wigan Lancashire WN3 5AZ United Kingdom на 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR 22 июл. 2020 г.

    2 страницыAD01

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное внеочередное решение о ликвидации с даты начала дела 22 мая 2020 г.

    LRESEX

    Отчет о состоянии дел

    10 страницыLIQ02

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    7 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 16 апр. 2019 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Прекращение полномочий Gary Speakman в качестве директора 31 дек. 2018 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Paul David Smith на должность директора 01 окт. 2018 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Vincent Flower в качестве директора 01 окт. 2018 г.

    1 страницыTM01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    7 страницыAA

    Изменение данных директора для Graham John Rogers 12 сент. 2018 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных о Shearings Leisure Group Limited как лице, осуществляющем значительный контроль, 05 июн. 2018 г.

    2 страницыPSC05

    Уведомление о подтверждении, составленное 16 апр. 2018 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Меморандум и Устав

    36 страницыMA

    Решения

    Resolutions
    3 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об изменении Устава

    RES01

    Изменение данных директора для Graham John Rogers 13 нояб. 2017 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Mr Gary Speakman 13 нояб. 2017 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Mr Vincent Flower 13 нояб. 2017 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных о Shearings Leisure Group Limited как лице, осуществляющем значительный контроль, 13 нояб. 2017 г.

    2 страницыPSC05

    Изменение данных о Shearings Group Limited как лице, осуществляющем значительный контроль, 13 нояб. 2017 г.

    2 страницыPSC05

    Юридический адрес изменен с Victoria Mill Miry Lane Wigan WN3 4AG на Waterside House Waterside Drive Wigan Lancashire WN3 5AZ 13 нояб. 2017 г.

    1 страницыAD01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    8 страницыAA

    Кто является должностными лицами COACH HOLIDAY GROUP LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    CALVERT, Richard James
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Директор
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    EnglandBritishCeo163434180002
    ROGERS, Graham John
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Директор
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69494710002
    SMITH, Paul David
    Waterside Drive
    Wigan Pier Business Park
    WN3 5AZ Wigan
    C/O Specialist Leisure Group, Waterside House
    United Kingdom
    Директор
    Waterside Drive
    Wigan Pier Business Park
    WN3 5AZ Wigan
    C/O Specialist Leisure Group, Waterside House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant228581750001
    HINSLIFF, Robert
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    Секретарь
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    British51000070001
    MEDDES, Kenneth Sydney
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    Секретарь
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    BritishDirector11486330002
    THOMAS, Joan Valerie
    3 Broom Road
    LS24 9LH Tadcaster
    North Yorkshire
    Секретарь
    3 Broom Road
    LS24 9LH Tadcaster
    North Yorkshire
    British51418740001
    TURNER, Jayne Marie
    33 Dingleway
    Appleton
    WA4 3AB Warrington
    Cheshire
    Секретарь
    33 Dingleway
    Appleton
    WA4 3AB Warrington
    Cheshire
    BritishAccountant117561640001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Номинированный секретарь
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    Секретарь компании
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    90084920001
    BARBER, Stephen Donald
    5 Springbank Close
    Farsley Pudsey
    LS28 5TP Leeds
    West Yorkshire
    Директор
    5 Springbank Close
    Farsley Pudsey
    LS28 5TP Leeds
    West Yorkshire
    BritishOperations Dir11617040001
    BARR, Robert Adam
    Crow House Farm
    Burton Leonard
    HG3 3SX Harrogate
    North Yorkshire
    Директор
    Crow House Farm
    Burton Leonard
    HG3 3SX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDeputy Chairman28813320001
    FLOWER, Vincent
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Директор
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director91542970002
    GILMORE, Nicholas John
    76 Ilsham Road
    TQ1 2HY Torquay
    Devon
    Директор
    76 Ilsham Road
    TQ1 2HY Torquay
    Devon
    BritishDirector53768550001
    MAXWELL, William
    Snelsins House
    Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    West Yorkshire
    Директор
    Snelsins House
    Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector108831380001
    MEDDES, Kenneth Sydney
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    Директор
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    United KingdomBritishManaging Director11486330002
    NEWBOLD, David Robert
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Директор
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director30276880001
    NORMAN, Bernard Robert
    Brackley House
    Marholm Road Ufford
    PE9 3BL Stamford
    Lincolnshire
    Директор
    Brackley House
    Marholm Road Ufford
    PE9 3BL Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCompany Director65467300001
    O'CALLAGHAN, Joseph
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    Директор
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector110216340001
    SLATCHER, David John
    3 Brindle Heights Water Street
    Brindle
    PR6 8YA Chorley
    Lancashire
    Директор
    3 Brindle Heights Water Street
    Brindle
    PR6 8YA Chorley
    Lancashire
    BritishCompany Director104434750001
    SPEAKMAN, Gary
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Директор
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director56066860001
    WORMWELL, Denis
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Директор
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive Officer124681340001
    WORSNUP, Peter Jonathan
    12 Grantley Place
    Bradley
    HD2 1LZ Huddersfield
    West Yorkshire
    Директор
    12 Grantley Place
    Bradley
    HD2 1LZ Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant95865490001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Номинированный директор
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над COACH HOLIDAY GROUP LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииUnited Kingdom
    Юридическое основаниеUnited Kingdom
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер5272464
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 25%, но не более 50% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 25%, но не более 50% голосующих акций компании.
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииEngland And Wales
    Юридическое основаниеUnited Kingdom (England And Wales)
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер09009187
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 50%, но не более 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.

    Есть ли у COACH HOLIDAY GROUP LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Guarantee and set-off agreement
    Создан 20 апр. 2006 г.
    Поставлен 05 мая 2006 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Its credit balances. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 05 мая 2006 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 20 апр. 2006 г.
    Поставлен 05 мая 2006 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 05 мая 2006 г.Регистрация обременения (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 18/04/06 and
    Создан 20 мар. 2006 г.
    Поставлен 22 апр. 2006 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All and whole the claymore hotel (formerly the cobbler hotel) arrochar t/no DMB19886.
    Уполномоченные лица
    • Jewel Hotels Trustee I Limited and Jewel Hotels Trutee Ii Limited as Trustees of the Jewelhotel
    Транзакции
    • 22 апр. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 28 march 2005 and
    Создан 21 мар. 2005 г.
    Поставлен 08 апр. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All and whole the subjects k/a and forming the fife arms hotel, braemar, aberdeenshire (formerly the cobbler hotel) arrochar, t/n DMB19886. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Indigo Capital Limited as Security Trustee for the Finance Parties
    Транзакции
    • 08 апр. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 24 мар. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 28 march 2005 and
    Создан 21 мар. 2005 г.
    Поставлен 08 апр. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All and whole the subjects k/a and forming the fife arms hotel, braemar, aberdeenshire, t/n ABN50574. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Indigo Capital Limited as Security Trustee for the Finance Parties
    Транзакции
    • 08 апр. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 нояб. 2005 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 16 мая 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 28 march 2005 and
    Создан 21 мар. 2005 г.
    Поставлен 08 апр. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All and whole the subjects k/a and forming the fife arms hotel, braemar, aberdeenshire, t/n ABN50574. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    Транзакции
    • 08 апр. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 нояб. 2005 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 24 мар. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 28 march 2005 and
    Создан 21 мар. 2005 г.
    Поставлен 08 апр. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All and whole the subjects k/a and forming the claymore hotel (formerly the cobbler hotel) arrochar, t/n DMB19886. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    Транзакции
    • 08 апр. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 29 мар. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 29 march 2005 and
    Создан 21 мар. 2005 г.
    Поставлен 13 апр. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All and whole the subjects known as and forming the fife arms hotel braemar aberdeenshire t/n ABN50574.
    Уполномоченные лица
    • 3I Investments PLC (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Транзакции
    • 13 апр. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 нояб. 2005 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 24 мар. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 29 march 2005 and
    Создан 21 мар. 2005 г.
    Поставлен 13 апр. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All and whole the subjects forming the claymore hotel (formerly the cobbler hotel) arrochar t/n DMB19886.
    Уполномоченные лица
    • 3I Investments PLC (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Транзакции
    • 13 апр. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 24 мар. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 21 мар. 2005 г.
    Поставлен 31 мар. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Indigo Capital Limited as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Транзакции
    • 31 мар. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 24 мар. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 21 мар. 2005 г.
    Поставлен 31 мар. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Транзакции
    • 31 мар. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 24 мар. 2006 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 04 мая 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 21 мар. 2005 г.
    Поставлен 30 мар. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • 3I Investments PLC (As Security Trustee)
    Транзакции
    • 30 мар. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 24 мар. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 18 september 2003 and
    Создан 03 сент. 2003 г.
    Поставлен 25 сент. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All and whole the property known as and forming the cobbler hotel, arrochar, scotland t/no DMB19886.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 25 сент. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 15 october 2001 and
    Создан 02 окт. 2001 г.
    Поставлен 19 окт. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee and in terms of a facility letter and/or pursuant to any of the other finance documents
    Краткое описание
    The fife arms hotel braemar (ABN50574).
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 19 окт. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 15 october 2001 and
    Создан 02 окт. 2001 г.
    Поставлен 19 окт. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee and in terms of a facility letter and/or pursuant to any of the other finance documents
    Краткое описание
    0.40 acres at broombank terrace braemar (AB50572). See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 19 окт. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 нояб. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Assignment of key-man policies
    Создан 02 окт. 2001 г.
    Поставлен 18 окт. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined)
    Краткое описание
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 18 окт. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Composite cross guarantee and mortgage debenture
    Создан 02 окт. 2001 г.
    Поставлен 18 окт. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined)
    Краткое описание
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 18 окт. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Composite cross guarantee and mortgage debenture
    Создан 02 окт. 2001 г.
    Поставлен 18 окт. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined)
    Краткое описание
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 18 окт. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 мар. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 30 july 2001 and
    Создан 13 июл. 2001 г.
    Поставлен 03 авг. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without prejudice to that generality in terms of a facilities agreement (as defined) dated 15 august 1997 and/or pursuant to any of the other finance documents
    Краткое описание
    0,40 acres at broombank terrace, braemar, aberdeenshire (ABN50572). See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC for Itself and as Trustee for the Beneficiaries
    Транзакции
    • 03 авг. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 окт. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 30 july 2001 and
    Создан 13 июл. 2001 г.
    Поставлен 03 авг. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without prejudice to that generality in terms of a facilities agreement (as defined) dated 15 august 1997 and/or pursuant to any of the other finance documents
    Краткое описание
    The fife arms hotel, braemar, aberdeenshire (ABN50574). See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC for Itself and as Trustee for the Beneficiaries
    Транзакции
    • 03 авг. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 окт. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 26 july 2001 and
    Создан 13 июл. 2001 г.
    Поставлен 03 авг. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without prejudice to that generality in terms of a facility letter (as defined) and/or pursuant to any of the other finance documents
    Краткое описание
    0.40 acres at broombrook terrace, braemar, aberdeenshire. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC for Itself and as Trustee for the Beneficiaries
    Транзакции
    • 03 авг. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 окт. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 26 july 2001 and
    Создан 13 июл. 2001 г.
    Поставлен 03 авг. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without prejudice to that generality in terms of a facility letter (as defined) and/or pursuant to any of the other finance documents
    Краткое описание
    The fife arms hotel, braemar, aberdeenshire. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC for Itself and as Trustee for the Beneficiaries
    Транзакции
    • 03 авг. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 окт. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A charge over shares between the company and barclays bank PLC (the "security trustee")
    Создан 09 февр. 2001 г.
    Поставлен 28 февр. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All moneys, obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by any company in the wallace arnold group to the security trustee and/or the beneficiaries on any account whatsoever
    Краткое описание
    27,000 ordinary shares of £1.00 each in perfect holidays limited and all dividends interest and other distributions.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 28 февр. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 окт. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A charge over shares
    Создан 26 янв. 2001 г.
    Поставлен 07 февр. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee and/or the beneficiaries on any account whatsoever pursuant to the banking agreements (as defined)
    Краткое описание
    All the shares,dividends,and bonus issues. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 07 февр. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 окт. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 18TH march 1999 and
    Создан 05 мар. 1999 г.
    Поставлен 24 мар. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    25 high st,bonnyrigg,county of midlothian with all rights,pertinents,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 24 мар. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 окт. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у COACH HOLIDAY GROUP LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    22 мая 2020 г.Начало ликвидации
    09 мая 2022 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по требованию кредиторов
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0