BEZIER HOLDINGS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Годовая отчетность
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииBEZIER HOLDINGS LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03382134
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель BEZIER HOLDINGS LIMITED?

    • Прочие вспомогательные услуги для бизнеса, не включенные в другие группировки (82990) / Административные и вспомогательные услуги

    Где находится BEZIER HOLDINGS LIMITED?

    Юридический адрес
    Bellway Court
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    West Yorkshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия BEZIER HOLDINGS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    MECHOPORT LIMITED05 июн. 1997 г.05 июн. 1997 г.

    Каковы последние отчеты BEZIER HOLDINGS LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 апр. 2012 г.

    Каков статус последней годовой декларации для BEZIER HOLDINGS LIMITED?

    Годовая отчетность
    Последняя годовая отчетность

    Какие последние документы подавались BEZIER HOLDINGS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Первое уведомление в Вестнике о принудительной ликвидации

    1 страницыGAZ1

    Процедура принудительной ликвидации прекращена

    1 страницыDISS40

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital12 нояб. 2013 г.

    Отчет о капитале на 12 нояб. 2013 г.

    • Капитал: GBP 26,015,020
    SH01

    Адрес для ознакомления с регистрами изменен с Eversheds Llp Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES England

    1 страницыAD02

    Назначение Mr Paul Canning на должность директора

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Andrew Steel в качестве директора

    1 страницыTM01

    Первое уведомление в Вестнике о принудительной ликвидации

    1 страницыGAZ1

    Прекращение полномочий John Stirling в качестве секретаря

    1 страницыTM02

    Годовая бухгалтерская отчетность

    15 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    7 страницыAR01

    Разное

    Section 519
    2 страницыMISC

    Отставка аудитора

    4 страницыAUD

    Назначение John Henry Stirling на должность секретаря

    2 страницыAP03

    legacy

    7 страницыMG01

    Назначение Mr James Joseph Michael Faulds на должность директора

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Richard Barfield в качестве директора

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Andrew David Steel на должность директора

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Richard Barfield в качестве секретаря

    1 страницыTM02

    Консолидированная бухгалтерская отчетность

    29 страницыAA

    Прекращение полномочий Trevor O'reilly в качестве директора

    1 страницыTM01

    legacy

    15 страницыMG01

    legacy

    3 страницыMG02

    Кто является должностными лицами BEZIER HOLDINGS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    CANNING, Paul
    c/o H.I.G. European Capital Partners Llp
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    England
    Директор
    c/o H.I.G. European Capital Partners Llp
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    England
    United KingdomBritishManaging Director165964000001
    FAULDS, James Joseph Michael
    Silkwood Park
    WF5 9TL Ossett
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Директор
    Silkwood Park
    WF5 9TL Ossett
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritishCompany Director571840010
    BARFIELD, Richard Timothy
    Bellway Court
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    West Yorkshire
    Секретарь
    Bellway Court
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    West Yorkshire
    149687240001
    DUDLEY, Brian
    Little Heverswood
    TN16 1LS Brasted Chart
    Kent
    Секретарь
    Little Heverswood
    TN16 1LS Brasted Chart
    Kent
    BritishChief Executive39917050001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    Секретарь
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    BritishChartered Accountant129305300001
    LEIGH, Andrew Nigel
    Catteslip House Crocker End
    Nettlebed
    RG9 5BL Henley On Thames
    Oxfordshire
    Секретарь
    Catteslip House Crocker End
    Nettlebed
    RG9 5BL Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishFinance Director30205620003
    SHAW, Mark
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Sutton-In-Ashfield
    Skegby Lodge
    Nottinghamshire
    Секретарь
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Sutton-In-Ashfield
    Skegby Lodge
    Nottinghamshire
    British146255720001
    SHAW, Mark
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    Секретарь
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    BritishNone107353690001
    STIRLING, John Henry
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    168886450001
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    Leonard Street
    EC2A 4QS London
    83
    Номинированный секретарь
    Leonard Street
    EC2A 4QS London
    83
    900013740001
    BARFIELD, Richard Timothy
    Bellway Court
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    West Yorkshire
    Директор
    Bellway Court
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector123477010001
    CARNAZZA, Ian Medwin
    32 Leyland Road
    HG1 4RT Harrogate
    North Yorkshire
    Директор
    32 Leyland Road
    HG1 4RT Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director107723490001
    COLLINS, Christopher Henry
    Ardenlea
    7 Fort Road
    GU1 3TB Guildford
    Surrey
    Директор
    Ardenlea
    7 Fort Road
    GU1 3TB Guildford
    Surrey
    BritishFund Manager76935620001
    COURTNEY, Richard Howard
    Upper Mill Farm
    Oakridge Heol Hir
    CF14 9LA Cardiff
    Директор
    Upper Mill Farm
    Oakridge Heol Hir
    CF14 9LA Cardiff
    United KingdomBritishNone153848980001
    DUDLEY, Brian
    Little Heverswood
    TN16 1LS Brasted Chart
    Kent
    Директор
    Little Heverswood
    TN16 1LS Brasted Chart
    Kent
    EnglandBritishChief Executive39917050001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    Директор
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant129305300001
    KNIGHTS, Gary
    The Hutleys 59 Church Street
    Coggeshall
    CO6 1TY Colchester
    Essex
    Директор
    The Hutleys 59 Church Street
    Coggeshall
    CO6 1TY Colchester
    Essex
    United KingdomBritishNone45695650002
    LEIGH, Andrew Nigel
    Catteslip House Crocker End
    Nettlebed
    RG9 5BL Henley On Thames
    Oxfordshire
    Директор
    Catteslip House Crocker End
    Nettlebed
    RG9 5BL Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishFinance Director30205620003
    O'REILLY, Trevor John
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Директор
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    IrelandIrishDirector148130760001
    RONALD, William David Gordon
    Aston
    RG9 3DE Henley On Thames
    Highway Cottage
    Oxfordshire
    Директор
    Aston
    RG9 3DE Henley On Thames
    Highway Cottage
    Oxfordshire
    EnglandBritishNone138299060001
    SHAW, Mark
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    Директор
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    EnglandBritishNone107353690001
    ST JOHN, Charles Henry Oliver
    3 Brodrick Road
    SW17 7DZ London
    Директор
    3 Brodrick Road
    SW17 7DZ London
    BritishInvestment Director55581420001
    STEEL, Andrew David
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    Директор
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    EnglandBritishPrivate Equity Partner142266440002
    SYMONDSON, David Warwick
    10 Prebend Gardens
    Chiswick
    W4 1TW London
    Директор
    10 Prebend Gardens
    Chiswick
    W4 1TW London
    BritishInvestment Director6017570001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    Номинированный директор
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003210001

    Есть ли у BEZIER HOLDINGS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 15 мар. 2012 г.
    Поставлен 23 мар. 2012 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Транзакции
    • 23 мар. 2012 г.Регистрация обременения (MG01)
    An amendment and restatement deed
    Создан 21 сент. 2011 г.
    Поставлен 27 сент. 2011 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts and uncalled capital (for details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Grace Bay Holding Ii S.A.R.L
    Транзакции
    • 27 сент. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    A security debenture
    Создан 19 авг. 2011 г.
    Поставлен 06 сент. 2011 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery (for details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Grace Bay Holding Ii S.A.R.L
    Транзакции
    • 06 сент. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    Security confirmation and supplemental deed
    Создан 13 июн. 2011 г.
    Поставлен 17 июн. 2011 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties, the Security Trustee)
    Транзакции
    • 17 июн. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    A security confirmation and supplemental deed
    Создан 24 февр. 2011 г.
    Поставлен 08 мар. 2011 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Charged by way of fixed charge all shares all related distribution rights all investment and all related distribution rights all book debts and all benefits rights and security held in respect of or to secure the payment of the book debts see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties, the Security Trustee)
    Транзакции
    • 08 мар. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 19 сент. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    A confirmatory deed
    Создан 18 дек. 2009 г.
    Поставлен 04 янв. 2010 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    F/H land and buildings lying to the south of church road wick t/no's AV111330,AV111331 and AV128876 and f/h land and builsings on the south side of balne lane wakefield fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Транзакции
    • 04 янв. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 19 сент. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    A confirmatory deed
    Создан 31 июл. 2009 г.
    Поставлен 14 авг. 2009 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 14 авг. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    • 19 сент. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Confirmatory deed supplemental to a debenture originally dated 19 august 2005 and
    Создан 17 мар. 2009 г.
    Поставлен 25 мар. 2009 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    For details of properties charged, please refer to form 395, fixed and floating charge over the undertaking and all land and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Транзакции
    • 25 мар. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 мар. 2009 г.
    • 19 сент. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Supplemental deed
    Создан 20 мар. 2008 г.
    Поставлен 10 апр. 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 10 апр. 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 19 сент. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    A security accession deed
    Создан 06 сент. 2005 г.
    Поставлен 15 сент. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    F/H land and buildings lying to the south of church road wick t/nos AV111330, AV111331 and AV128876 and f/h land and buildings on the south side of balne lane wakefield t/no WYK516231. By way of fixed charge all shares and all related distribution rights. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotalnd PLC as Security Trustee
    Транзакции
    • 15 сент. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 19 сент. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Keyman insurance assignment
    Создан 13 мая 2002 г.
    Поставлен 30 мая 2002 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    By way of assignment the policies and the proceeds and the full benefit thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 30 мая 2002 г.Регистрация обременения (395)
    Keyman insurance assignment
    Создан 01 мая 1998 г.
    Поставлен 20 мая 1998 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company (formerly k/a mechnoport limited) to the chargee under the terms of the financing documents (as defined in the deed)
    Краткое описание
    All the company's right title and interest in and to the policies and allmonies and related rights thereto and full benefit thereof policies charged being 1). in the name of brian dudley dated 14TH april 1998 for the sum of £500,000 for the term of 5 years with standard life with policy number X67235989 2). name;-david simpson date:- 14TH april 1998 sum;- £200,000 term;-5 years with standard life policy number;-X67208452 3). name;-mark carr date;-14TH april 1998, sum;- £200,000 term ;-5 years with standard life, policy number;-X67209637 4). stephen mears.date;-14TH april 1998. sum;-£200,000 term 5 years with standard life policy number;-X67218827 5). name ;-wayne romminger.date;-14TH april 1998, sum;-£200,000 term;-5 years with standard life with policy number X67218216. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 20 мая 1998 г.Регистрация обременения (395)
    Guarantee and debenture
    Создан 01 мая 1998 г.
    Поставлен 20 мая 1998 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company (formerly known as mechnoport limited) to the chargees under the terms of the financing documents (as defined in the deed)
    Краткое описание
    Property charged being f/h land and buildings on the north side of lealand way boston lincolnshire t/no;-LL872275, f/h land and buildings on the south side of church road wick t/no's;-AV111331, AV111330 and AV128876 and f/h land and buildings on the south side of balne lane wakefield t/no;-WYK516231. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 20 мая 1998 г.Регистрация обременения (395)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0