LLNH LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииLLNH LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03429499
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель LLNH LIMITED?

    • Прочие вспомогательные услуги для бизнеса, не включенные в другие группировки (82990) / Административные и вспомогательные услуги

    Где находится LLNH LIMITED?

    Юридический адрес
    Southgate House
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    County Durham
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия LLNH LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    LEND LEASE NH LIMITED07 янв. 1998 г.07 янв. 1998 г.
    LEND LEASE HOMES LIMITED11 сент. 1997 г.11 сент. 1997 г.
    HACKREMCO (NO.1266) LIMITED04 сент. 1997 г.04 сент. 1997 г.

    Каковы последние отчеты LLNH LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 сент. 2020 г.

    Какие последние документы подавались LLNH LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Решения

    Resolutions
    4 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решения

    Situations in which directors have or can have a direct or indirect interest that conflicts with interest of the company authorised, notwithstanding that any such conflict may breach director's duty under S175 of CA2006. 25/08/2021
    RES13

    Уведомление о подтверждении, составленное 28 мая 2021 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    9 страницыAA

    Полное погашение обременения 034294990011

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 034294990013

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 034294990012

    1 страницыMR04

    Регистрация обременения 034294990014, создано 27 апр. 2021 г.

    57 страницыMR01

    Регистрация обременения 034294990016, создано 27 апр. 2021 г.

    90 страницыMR01

    Регистрация обременения 034294990015, создано 27 апр. 2021 г.

    216 страницыMR01

    Назначение Mr James Walter Tugendhat на должность директора 14 сент. 2020 г.

    2 страницыAP01

    Уведомление о подтверждении, составленное 28 мая 2020 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    7 страницыAA

    Прекращение полномочий James Justin Hutchens в качестве директора 05 февр. 2020 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 28 мая 2019 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    7 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 28 мая 2018 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    7 страницыAA

    Изменение данных директора для Mr James Justin Hutchens 08 янв. 2018 г.

    2 страницыCH01

    Прекращение полномочий Chaitanya Bhupendra Patel в качестве директора 22 сент. 2017 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr James Justin Hutchens на должность директора 21 сент. 2017 г.

    2 страницыAP01

    Полное погашение обременения 034294990010

    4 страницыMR04

    Регистрация обременения 034294990013, создано 30 июн. 2017 г.

    47 страницыMR01

    Кто является должностными лицами LLNH LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    England
    Директор
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    England
    United KingdomBritish147997950001
    TUGENDHAT, James Walter
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    Директор
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United KingdomBritish218306870001
    FLETCHER, Rachel Elizabeth
    Flat 1 Basement
    269 Magdalen Road Earlsfield
    SW18 3NZ London
    Секретарь
    Flat 1 Basement
    269 Magdalen Road Earlsfield
    SW18 3NZ London
    British106745220001
    GOUGH, Alison Louise
    12 Redcliffe Mews
    SW10 9JU London
    Секретарь
    12 Redcliffe Mews
    SW10 9JU London
    Australian62074540001
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    Секретарь
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    British108637650001
    KAUL, Sheila
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    Секретарь
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    British70194600001
    KILMARTIN, Adrian Robert
    Church Farm
    Acton Turville
    GL9 1HD Badminton
    South Gloucestershire
    Секретарь
    Church Farm
    Acton Turville
    GL9 1HD Badminton
    South Gloucestershire
    British11660010001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Секретарь
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    British110640170001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Секретарь
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    British110640170001
    MORTIMER, Rachel
    14 Huron Road
    SW17 8RB London
    Секретарь
    14 Huron Road
    SW17 8RB London
    British102674500002
    PANG, Lily
    Calbourne Road
    SW12 8LW London
    9
    United Kingdom
    Секретарь
    Calbourne Road
    SW12 8LW London
    9
    United Kingdom
    Malaysian140239060001
    SUTTON, Penelope Ruth
    32 Saxon Road
    BR1 3RP Bromley
    Kent
    Секретарь
    32 Saxon Road
    BR1 3RP Bromley
    Kent
    British38586070002
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Номинированный секретарь
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    ARTHUR, Derryn Sue
    21 Elsham Road
    W14 8HA London
    Директор
    21 Elsham Road
    W14 8HA London
    New Zealander57726590002
    AUBERY, Paul Richard
    1 Malthouse Drive Regency Quay
    Chiswick
    W4 2NR London
    Директор
    1 Malthouse Drive Regency Quay
    Chiswick
    W4 2NR London
    British78253140001
    BARATTA, Joseph Patrick
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    Директор
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    UsaAmerican94259330002
    BLITZER, David Scott
    5 Priory Walk
    SW10 9SP London
    Директор
    5 Priory Walk
    SW10 9SP London
    EnglandAmerican82685720001
    BURROWS, Roger Leonard
    51 Leyborne Park
    Kew
    TW9 3BH Richmond
    Surrey
    Директор
    51 Leyborne Park
    Kew
    TW9 3BH Richmond
    Surrey
    Australian47271870002
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Директор
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    British98778780002
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Директор
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Директор
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Директор
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    DAVIES, William Jeremy
    The Manor House
    Great Somerford
    SN15 5EH Chippenham
    Wiltshire
    Директор
    The Manor House
    Great Somerford
    SN15 5EH Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritish21505070001
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Директор
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritish76313640003
    ELLERT, Richard John
    Cami Del Padro 10
    Sant Vicenc De Montalt
    Barcelona
    Catalonia 08394
    Spain
    Директор
    Cami Del Padro 10
    Sant Vicenc De Montalt
    Barcelona
    Catalonia 08394
    Spain
    British95944260001
    FARNELL, Adrian Colin
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    Директор
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish43015720002
    FRANCIS, Daniel Fernley
    Bartley Lodge 11 Marlborough Road
    Chandlers Ford
    SO53 5DJ Eastleigh
    Hampshire
    Директор
    Bartley Lodge 11 Marlborough Road
    Chandlers Ford
    SO53 5DJ Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish44830480001
    GOUGH, Alison Louise
    12 Redcliffe Mews
    SW10 9JU London
    Директор
    12 Redcliffe Mews
    SW10 9JU London
    Australian62074540001
    GRANT, Michael John
    Edwill Way
    BR3 6RY Beckenham
    73
    Kent
    Директор
    Edwill Way
    BR3 6RY Beckenham
    73
    Kent
    EnglandBritish141668610001
    HUTCHENS, James Justin
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    Директор
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United KingdomAmerican238334580002
    JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    Директор
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    EnglandBritish108268030003
    MARSHALL, Ian
    43 Belsize Road
    NW6 4RX London
    Директор
    43 Belsize Road
    NW6 4RX London
    British81232950001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Директор
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    EnglandBritish110640170001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Директор
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    EnglandBritish110640170001
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    Директор
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    British98781970001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над LLNH LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Nhp Limited
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    Durham
    England
    01 мая 2017 г.
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    Durham
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited
    Страна регистрацииUnited Kingdom
    Юридическое основаниеCompanies Act 2006
    Место регистрацииEngland & Wales
    Регистрационный номер02798607
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.

    Есть ли у LLNH LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 27 апр. 2021 г.
    Поставлен 29 апр. 2021 г.
    Не погашен
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Транзакции
    • 29 апр. 2021 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 27 апр. 2021 г.
    Поставлен 29 апр. 2021 г.
    Не погашен
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Транзакции
    • 29 апр. 2021 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 27 апр. 2021 г.
    Поставлен 29 апр. 2021 г.
    Не погашен
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Транзакции
    • 29 апр. 2021 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 30 июн. 2017 г.
    Поставлен 10 июл. 2017 г.
    Полностью погашен
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Транзакции
    • 10 июл. 2017 г.Регистрация залога (MR01)
    • 30 апр. 2021 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 30 июн. 2017 г.
    Поставлен 07 июл. 2017 г.
    Полностью погашен
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Транзакции
    • 07 июл. 2017 г.Регистрация залога (MR01)
    • 30 апр. 2021 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 30 июн. 2017 г.
    Поставлен 06 июл. 2017 г.
    Полностью погашен
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Trustee
    Транзакции
    • 06 июл. 2017 г.Регистрация залога (MR01)
    • 30 апр. 2021 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 12 нояб. 2014 г.
    Поставлен 21 нояб. 2014 г.
    Полностью погашен
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Hcp, Inc. (As Security Agent)
    Транзакции
    • 21 нояб. 2014 г.Регистрация залога (MR01)
    • 14 июл. 2017 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A security deed
    Создан 15 янв. 2007 г.
    Поставлен 30 янв. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Credit Suisse, London Branch
    Транзакции
    • 30 янв. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 нояб. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Composite debenture
    Создан 12 дек. 2006 г.
    Поставлен 21 дек. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Транзакции
    • 21 дек. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 янв. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 17 окт. 2005 г.
    Поставлен 20 окт. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Транзакции
    • 20 окт. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 дек. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 11 апр. 2005 г.
    Поставлен 15 апр. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Insurance policies, hedging documents, accounts, occupational leases, all land and proceeds of sale, plant and machinery, rents, specified investments, derivative rights, goodwill & uncalled capital, all receivables, intercompany debt, each account floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Транзакции
    • 15 апр. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 янв. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental debenture
    Создан 11 июн. 1998 г.
    Поставлен 18 июн. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the chargee under or pursuant to the facility documents as defined in the facility agreement (including the facility agreement and the debenture)
    Краткое описание
    By way of first legal mortgage f/h interest in aberford hall nursing home oakwood green roundhay leeds LS8 2QU t/n-WYK510482, ascot lodge nursing home 48A newlands road intake sheffield S12 2FZ t/n-SYK354711, aston house nursing home 26 angel lane hayes middlesex UB3 2QX t/n-NGL47781 (see 395 for other properties charged).. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee
    Транзакции
    • 18 июн. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 июн. 1999 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental debenture
    Создан 03 июн. 1998 г.
    Поставлен 08 июн. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    Each and every liability that the obligors (as therein defined) may have to the chargee under or pursuant to the facility documents (as defined in the facility agreement dated 28 january 1998) (including the facility agreement and the debenture dated 28 january 1998)
    Краткое описание
    The f/h interest in the property k/a ashton grange residential home st lukes road pallion sunderland t/n TY304629, windsor court bartholomew avenue goole east riding of yorkshire t/n HS170159, ashbourne lodge nursing home ryhope road grangetown sunderland t/n TY310171 and victoria house residential home bath lane stockton on tees t/n CE136807 together with all buildings fixtures fixed plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(As Security Trustee for Itself and the Beneficiaries)
    Транзакции
    • 08 июн. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 июн. 1999 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental debenture made between (1) llnhp partnership acting through its partners (2) nhp securities no.4 Limited and (3) lend lease nh limited in favour of the governor and company of the bank of scotland as security trustee
    Создан 06 мая 1998 г.
    Поставлен 11 мая 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the finance documents as defined in the facility agreement (including the facility agreement and the debenture)
    Краткое описание
    All rights and claims to which the company is now or may hereafter become entitled in relation to the property k/a the beeches nursing home 55 furlong road arnold nottingham. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 11 мая 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 июн. 1999 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental debenture
    Создан 10 февр. 1998 г.
    Поставлен 24 февр. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    Each and every liability which the obligors (as therein defined) have to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the facility documents as defined in the facility agreement (including the facility agreement and the debenture dated 28 january 1998) including any liability in respect of any further advances made thereunder and every sum now or hereafter owing due or incurred by the obligors to the security trustee or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities
    Краткое описание
    All rights and claims in relation to the real property being - the f/h ladymead nursing home canal way devizes wiltshire t/n WT133199 avonmead nursing home canal way devises wiltshire t/n's WT132231, WT142939 and WT154929 and kingsmead nursing home prospect place old town swindon wiltshire t/n's WT16064, WT139496 and WT137926. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandthe "Security Trustee"
    Транзакции
    • 24 февр. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 июн. 1999 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 28 янв. 1998 г.
    Поставлен 03 февр. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    Each and every liability which the obligors (as defined) have to the governor and company of the bank of scotland (the security trustee) (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the facility documents (as defined) (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made thereunder and every sum at the date of the debenture or thereafter owing by the obligors to the security trustee or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities
    Краткое описание
    A.the real property other than scottish real property and the northern irish real property;B.all rights and claims to which llnhp and each partner is at the date of the debenture or may thereafter become entitled in relation to all monies at the date of the debenture or at any time standing to the credit of any bank accounts.. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 03 февр. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 июн. 1999 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0