TRIBAL NC LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Годовая отчетность
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииTRIBAL NC LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03442665
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель TRIBAL NC LIMITED?

    • Консультирование по вопросам управления, кроме финансового менеджмента (70229) / Деятельность профессиональная, научная и техническая
    • Спящие компании (99999) / Деятельность экстратерриториальных организаций и органов

    Где находится TRIBAL NC LIMITED?

    Юридический адрес
    Kings Orchard Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия TRIBAL NC LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    NEWCHURCH LIMITED04 окт. 2000 г.04 окт. 2000 г.
    AGORA HEALTHCARE SERVICES LIMITED01 окт. 1997 г.01 окт. 1997 г.

    Каковы последние отчеты TRIBAL NC LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2014 г.

    Каков статус последней годовой декларации для TRIBAL NC LIMITED?

    Годовая отчетность
    Последняя годовая отчетность

    Какие последние документы подавались TRIBAL NC LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Отчет о капитале на 28 янв. 2016 г.

    • Капитал: GBP 0.01
    4 страницыSH19

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Решения

    Resolutions
    3 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06
    capital

    Решения

    Share premium & other reserves reduced 18/12/2015
    RES13

    legacy

    1 страницыSH20

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Назначение Mr Robert Charles Garner на должность директора 01 июл. 2015 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Keith Martin Evans в качестве директора 30 июн. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    5 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital31 мар. 2015 г.

    Отчет о капитале на 31 мар. 2015 г.

    • Капитал: GBP 17,415,052.29212
    SH01

    Изменение данных директора для Mr Stephen Derrick Breach 05 июн. 2014 г.

    2 страницыCH01

    Юридический адрес изменен с 1-4 Portland Square Bristol BS2 8RR на Kings Orchard Queen Street St. Philips Bristol BS2 0HQ 04 авг. 2014 г.

    1 страницыAD01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital31 мар. 2014 г.

    Отчет о капитале на 31 мар. 2014 г.

    • Капитал: GBP 17,415,052.29212
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    7 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    7 страницыAA

    Юридический адрес изменен с * 87-91 Newman Street London W1T 3EY* 09 мар. 2012 г.

    1 страницыAD01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    12 страницыAA

    Прекращение полномочий Lorraine Davis в качестве секретаря

    1 страницыTM02

    Свидетельство об изменении наименования компании

    Company name changed newchurch LIMITED\certificate issued on 24/05/11
    2 страницыCERTNM
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    change-of-name24 мая 2011 г.

    Решение об изменении наименования

    RES15

    Уведомление об изменении наименования"

    2 страницыCONNOT

    Назначение Dr Keith Martin Evans на должность директора

    2 страницыAP01

    Кто является должностными лицами TRIBAL NC LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    BREACH, Stephen Derrick
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    Директор
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    EnglandBritish174695940001
    GARNER, Robert Charles
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    Директор
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    United KingdomBritish53391420003
    ANDO, Daniella
    30 Concord Court
    Winery Lane
    KT1 3GF Kingston Upon Thames
    Surrey
    Секретарь
    30 Concord Court
    Winery Lane
    KT1 3GF Kingston Upon Thames
    Surrey
    British51693570001
    COLLINS, Richard Hawke
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    Секретарь
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    British136546790001
    DAVIS, Lorraine Anne
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    Секретарь
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    150939960001
    GAMBER, Mark Francis
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    Секретарь
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    British51105690002
    HARMES, David Orlando Spencer
    10 Lime Walk
    SL6 6QB Maidenhead
    Berkshire
    Секретарь
    10 Lime Walk
    SL6 6QB Maidenhead
    Berkshire
    British60400060001
    HERCUS, Ivan Lindsay
    6 Beaumont Crescent
    W14 9LX London
    Секретарь
    6 Beaumont Crescent
    W14 9LX London
    British116757120001
    MANNING, Kingsley Guy
    6 Gatcombe Road
    Tufnell Park
    N19 4PT London
    Секретарь
    6 Gatcombe Road
    Tufnell Park
    N19 4PT London
    British15931310001
    MANNING, Kingsley Guy
    6 Gatcombe Road
    Tufnell Park
    N19 4PT London
    Секретарь
    6 Gatcombe Road
    Tufnell Park
    N19 4PT London
    British15931310001
    WARNER, Evelyn Patricia
    Robin Hill Drive
    GU15 1EG Camberley
    23
    Surrey
    United Kingdom
    Секретарь
    Robin Hill Drive
    GU15 1EG Camberley
    23
    Surrey
    United Kingdom
    British129486480001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Номинированный секретарь
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    CONAGHAN, John Edward, Mr.
    11 Danegeld Place
    PE9 2AF Stamford
    Lincolnshire
    Директор
    11 Danegeld Place
    PE9 2AF Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritish97327390002
    DEWEY, Kevin
    Oak Tree Cottage 18 Meadway
    KT10 9HF Esher
    Surrey
    Директор
    Oak Tree Cottage 18 Meadway
    KT10 9HF Esher
    Surrey
    British6631200001
    EVANS, Keith Martin, Dr
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    Директор
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    United KingdomBritish159812510001
    FIELD, Andrew
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    Директор
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    EnglandBritish61471170001
    GAMBER, Mark Francis
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    Директор
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    British51105690002
    GODBER, Stephen Alison
    41-51 Brighton Road
    RH1 6YS Redhill
    Surrey
    Директор
    41-51 Brighton Road
    RH1 6YS Redhill
    Surrey
    United KingdomBritish105071600001
    HARMES, David Orlando Spencer
    10 Lime Walk
    SL6 6QB Maidenhead
    Berkshire
    Директор
    10 Lime Walk
    SL6 6QB Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish60400060001
    HINE, Duncan, Dr
    Glenrue 6 Butt Lane Close
    LE10 1LF Hinckley
    Leicestershire
    Директор
    Glenrue 6 Butt Lane Close
    LE10 1LF Hinckley
    Leicestershire
    British13396990001
    KANTER, Ralph Thomas Ludwig
    Garden Flat
    17 Upper Park Road
    NW3 2UN London
    Директор
    Garden Flat
    17 Upper Park Road
    NW3 2UN London
    United KingdomBritish124153720001
    KEY, Simon Robert
    4 Old Street
    SP4 8JT Salisbury
    Wiltshire
    Директор
    4 Old Street
    SP4 8JT Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish41514390002
    KHAN, Junaid
    33 The Ridings
    KT11 2PU Cobham
    Surrey
    Директор
    33 The Ridings
    KT11 2PU Cobham
    Surrey
    British98917630001
    LAMBERT, Susan
    20 Pinel Close
    Virginia Park
    GU25 4SP Virginia Water
    Surrey
    Директор
    20 Pinel Close
    Virginia Park
    GU25 4SP Virginia Water
    Surrey
    British113974450001
    LAWTON, Simon Marcus
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    Директор
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    EnglandBritish68807890004
    MANNING, Kingsley Guy
    22a Jacobs Well Mews
    W1U 3DR London
    Директор
    22a Jacobs Well Mews
    W1U 3DR London
    United KingdomBritish15931310003
    MARTIN, Nicholas Rupert Zelenka
    123 Mallinson Road
    SW11 1BH London
    Директор
    123 Mallinson Road
    SW11 1BH London
    British23175310002
    MARTIN, Peter John
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    Директор
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    EnglandBritish176044430001
    SALLIS, David
    42 Sheen Park
    TW9 1UW Richmond
    Surrey
    Директор
    42 Sheen Park
    TW9 1UW Richmond
    Surrey
    United KingdomUk44780590002
    SETCHELL, Brenda Carol
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    Директор
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    United KingdomBritish90477860001
    STONE, Lisa Jane
    The Grange
    Sandhill Lane, Crawley Down
    RH10 4LB Crawley
    West Sussex
    Директор
    The Grange
    Sandhill Lane, Crawley Down
    RH10 4LB Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritish69455810002
    TOLLEY, Robyn William
    The Old Barn
    Blithbury
    WS15 3JG Rugeley
    Staffordshire
    Директор
    The Old Barn
    Blithbury
    WS15 3JG Rugeley
    Staffordshire
    British95294050001
    TRICKEY, Philip John
    Ludshott House Seymour Road
    Headley Down
    GU35 8JX Bordon
    Hampshire
    Директор
    Ludshott House Seymour Road
    Headley Down
    GU35 8JX Bordon
    Hampshire
    EnglandBritish72857220001
    WILLIAMS, Richard John
    257 Sheen Lane
    SW14 8RN London
    Директор
    257 Sheen Lane
    SW14 8RN London
    British64882280001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Номинированный директор
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Есть ли у TRIBAL NC LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Deed of rent deposit
    Создан 05 сент. 2007 г.
    Поставлен 11 сент. 2007 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The interest bearing sterling deposit account.
    Уполномоченные лица
    • Laminglade Limited and Laminpark Limited
    Транзакции
    • 11 сент. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    All assets debenture
    Создан 17 сент. 2004 г.
    Поставлен 30 сент. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Транзакции
    • 30 сент. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 янв. 2009 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 13 февр. 2004 г.
    Поставлен 24 февр. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Hg Investment Managers Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    Транзакции
    • 24 февр. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 13 дек. 2002 г.
    Поставлен 18 дек. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Rowan Nominees Limited
    Транзакции
    • 18 дек. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 18 июн. 2002 г.
    Поставлен 02 мая 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All other goodwill in the UK and elsewhere worldwide and the unregistered trade marks and trade names,the core software and the architecture software. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Rowan Nominees Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    Транзакции
    • 02 мая 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 04 мая 2001 г.
    Поставлен 19 мая 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All moneys,obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the beneficiaries under or pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with the financial accommodation from time to time granted
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Rowan Nominees Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    Транзакции
    • 19 мая 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Создан 13 сент. 2000 г.
    Поставлен 22 сент. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Barclays bank PLC re agora healthcare services limited barclays high interest business account number 30648299. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 22 сент. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 авг. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 07 сент. 2000 г.
    Поставлен 14 сент. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with the financial accommodation under the terms of this debenture
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Rowan Nominees Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    Транзакции
    • 14 сент. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0