CAPARO ENGINEERING LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииCAPARO ENGINEERING LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03450375
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    • Литье чугуна (24510) / Обрабатывающая промышленность
    • Литье других цветных металлов (24540) / Обрабатывающая промышленность
    • Производство других металлических изделий (25990) / Обрабатывающая промышленность

    Где находится CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Юридический адрес
    Floor 8 Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Yorkshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    SUPREMO 2000 LIMITED15 окт. 1997 г.15 окт. 1997 г.

    Каковы последние отчеты CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2014 г.

    Какие последние документы подавались CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации кредиторов

    23 страницыLIQ14

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 25 окт. 2023 г.

    23 страницыLIQ03

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 25 окт. 2022 г.

    22 страницыLIQ03

    Регистрация банкротства

    Insolvency:secreatary of state release of liquidator.
    1 страницыLIQ MISC

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 25 окт. 2021 г.

    23 страницыLIQ03

    Назначение ликвидатора

    15 страницы600

    Удаление ликвидатора по судебному приказу

    13 страницыLIQ10

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 25 окт. 2020 г.

    24 страницыLIQ03

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 25 окт. 2019 г.

    25 страницыLIQ03

    Регистрация банкротства

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    4 страницыLIQ MISC

    Удаление ликвидатора по судебному приказу

    17 страницыLIQ10

    Назначение ликвидатора

    3 страницы600

    Назначение ликвидатора

    3 страницы600

    Уведомление о переходе от администрации к добровольной ликвидации кредиторов

    34 страницыAM22

    Отчет о ходе администрации

    32 страницыAM10

    Юридический адрес изменен с 7 More London Riverside London SE1 2RT на Floor 8 Central Square 29 Wellington Street Leeds Yorkshire LS1 4DL 07 окт. 2017 г.

    2 страницыAD01

    Уведомление о продлении срока администрации

    3 страницыAM19

    Отчет о ходе администрации

    29 страницыAM10

    Уведомление об отставке администратора

    11 страницы2.38B

    Отчет о ходе администрации до 18 окт. 2016 г.

    27 страницы2.24B

    Уведомление о продлении срока администрации

    1 страницы2.31B

    Результат собрания кредиторов

    1 страницы2.23B

    Отчет о ходе администрации до 18 апр. 2016 г.

    32 страницы2.24B

    Прекращение полномочий Derek Michael O'reilly в качестве директора 17 дек. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Кто является должностными лицами CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    PAUL, Angad, The Honorable
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    Директор
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    United KingdomUnited Kingdom130813310001
    BENNETT, Paul Richard
    1 Ennerdale Drive
    B63 1HL Halesowen
    West Midlands
    Секретарь
    1 Ennerdale Drive
    B63 1HL Halesowen
    West Midlands
    British76951010001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Номинированный секретарь
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    PAY, Jason Christopher
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    Секретарь
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    British126516810001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Секретарь
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    British56051330001
    BEATON, Kevin
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Директор
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    United KingdomBritish150211630001
    BOTTING, Richard Graham
    7 Bromwich Drive
    WS13 8SD Fradley
    Staffordshire
    Директор
    7 Bromwich Drive
    WS13 8SD Fradley
    Staffordshire
    British85897150001
    BUTLER, Richard Gareth John
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Директор
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish117859680001
    CLIFF, Richard Martyn
    Waterside House
    Church Street Wyre Piddle
    WR10 2JD Pershore
    Worcestershire
    Директор
    Waterside House
    Church Street Wyre Piddle
    WR10 2JD Pershore
    Worcestershire
    United KingdomBritish56113440001
    CURRAN, James Thomas
    The Old Post Office
    10 Hill View Road Strensham
    WR8 9LJ Worcester
    Директор
    The Old Post Office
    10 Hill View Road Strensham
    WR8 9LJ Worcester
    United KingdomBritish56844020001
    DANCASTER, David Patrick
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    Директор
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    EnglandBritish55380530001
    GANE, Christopher Nigel
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Директор
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    ScotlandBritish73268030001
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Номинированный директор
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001
    HAMMOND, Christopher Mark
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Директор
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    United KingdomBritish60992860002
    HARTLAND, Melvyn Edward
    7 Merriemont Drive
    Barnt Green
    B45 8QZ Birmingham
    Директор
    7 Merriemont Drive
    Barnt Green
    B45 8QZ Birmingham
    British8436920002
    O'REILLY, Derek Michael
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Директор
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    EnglandBritish108440160002
    PAUL, Akhil
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Директор
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish199010800001
    PAUL, Ambar, The Honourable
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    Директор
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    United KingdomBritish92729600003
    PAY, Jason Christopher
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Директор
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish126516810001
    PAY, Jason Christopher
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    Директор
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritish126516810001
    PINCHES, Brian Michael
    2 Berkeley Close
    Perton
    WV6 7RX Wolverhampton
    West Midlands
    Директор
    2 Berkeley Close
    Perton
    WV6 7RX Wolverhampton
    West Midlands
    British44065140001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Директор
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritish56051330001
    TAYLOR, Paul
    86 Hyperion Road
    Stourton
    DY7 6SL Stourbridge
    West Midlands
    Директор
    86 Hyperion Road
    Stourton
    DY7 6SL Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritish49786260004
    UNDERHILL, Maurice
    339 Birmingham Road
    WS5 3NU Walsall
    West Midlands
    Директор
    339 Birmingham Road
    WS5 3NU Walsall
    West Midlands
    British12842580001
    WHALE, Ian
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Директор
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish192902390001
    WOOD, John Franklin
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Директор
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish1397720001
    WOOD, John Franklin
    27 Oak Hill Drive
    Edgbaston
    B15 3UG Birmingham
    West Midlands
    Директор
    27 Oak Hill Drive
    Edgbaston
    B15 3UG Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish1397720001

    Есть ли у CAPARO ENGINEERING LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 20 февр. 2014 г.
    Поставлен 13 мар. 2014 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Caparo PLC
    Транзакции
    • 13 мар. 2014 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 27 июн. 2013 г.
    Поставлен 15 июл. 2013 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    F/H property. Caparo testing, brenda road, hartlepool t/no CE52039.. Caparo forgoing, marriott road, dudley t/no WM383778. (For details of patents charged please refer to form MR01) see image for full details. Notification of addition to or amendment of charge.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Caparo Pensions Scheme Trustees Limited
    Транзакции
    • 15 июл. 2013 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 27 июн. 2013 г.
    Поставлен 05 июл. 2013 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    F/H land at caparo testing brenda road hartlepool t/no CE52039. F/h land at caparo forging marriott road dudley t/no WM383778. Patent described as "mounting (cmt own shock absorber)" filed in 1998 with number GB2330642. For details of further intellectual property please refer to deed. Notification of addition to or amendment of charge.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Транзакции
    • 05 июл. 2013 г.Регистрация залога (MR01)
    Polish law registered pledge agreement
    Создан 19 авг. 2011 г.
    Поставлен 25 авг. 2011 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of pln 50,000,000 (say: fifty million zlotys), all the rights. See image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Caparo PLC
    Транзакции
    • 25 авг. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    Polish law registered pledge agreement
    Создан 19 авг. 2011 г.
    Поставлен 25 авг. 2011 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of eur 10,000,000 (say: ten million euro), all the rights. See image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Jalia Holding S.A.
    Транзакции
    • 25 авг. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    Pledge agreement
    Создан 30 нояб. 2010 г.
    Поставлен 10 дек. 2010 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of pln 50,000,000.
    Уполномоченные лица
    • Caparo PLC
    Транзакции
    • 10 дек. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    Pledge agreement
    Создан 26 нояб. 2010 г.
    Поставлен 10 дек. 2010 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of eur 10,000,000.
    Уполномоченные лица
    • Jalia Holding Sa
    Транзакции
    • 10 дек. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    Security agreement
    Создан 30 июл. 2010 г.
    Поставлен 06 авг. 2010 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee and from any pension trustee obligor to the pension trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 06 авг. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 03 июл. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest and on other debts and floating charge on proceeds of other debts
    Создан 31 янв. 2002 г.
    Поставлен 14 февр. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    (I) fixed equitable charge any debt (as defined in the agreement) purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to the agreement including its related rights (purchased debts) both present and future which fail to vest absolutely and effectively in the chargee for any reason and (ii) fixed equitable charge all amounts of indebtedness now or at any time owing or becoming due to the company on any account whatsoever including the related rights, other than any purchased debt (other debts) and (iii) floating charge such monies the company may receive in respect of the other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 14 февр. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 июл. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)

    Есть ли у CAPARO ENGINEERING LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    19 окт. 2015 г.Начало управления
    26 окт. 2018 г.Окончание управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Практик
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Robert Jonathan Hunt
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Практик
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Anthony Steven Barrell
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Практик
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    2
    ДатаТип
    26 окт. 2018 г.Начало ликвидации
    21 мая 2024 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по требованию кредиторов
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Практик
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Anthony Steven Barrell
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire
    Практик
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Практик
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Edward Williams
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Практик
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0