NPS (UK5) LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииNPS (UK5) LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03495019
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель NPS (UK5) LIMITED?

    • Прочие виды деятельности в области информационных технологий (62090) / Информация и связь

    Где находится NPS (UK5) LIMITED?

    Юридический адрес
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия NPS (UK5) LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    NORTHGATE PUBLIC SECTOR LIMITED28 нояб. 2008 г.28 нояб. 2008 г.
    ANITE PUBLIC SECTOR LIMITED02 февр. 2000 г.02 февр. 2000 г.
    IMASYS LIMITED16 февр. 1998 г.16 февр. 1998 г.
    IMASYS (LOCAL GOVERNMENT) LIMITED14 янв. 1998 г.14 янв. 1998 г.

    Каковы последние отчеты NPS (UK5) LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 апр. 2018 г.

    Какие последние документы подавались NPS (UK5) LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    6 страницыLIQ13

    Юридический адрес изменен с Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4NW на 15 Canada Square London E14 5GL 03 июл. 2019 г.

    2 страницыAD01

    Назначение ликвидатора

    3 страницы600

    Заявление о платежеспособности

    5 страницыLIQ01

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 10 июн. 2019 г.

    LRESSP

    Уведомление о подтверждении, составленное 26 нояб. 2018 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Бухгалтерская отчетность для микропредприятия

    2 страницыAA

    Текущий отчетный период сокращен

    1 страницыAA01

    Прекращение полномочий Ian Michael Noble в качестве директора 06 авг. 2018 г.

    1 страницыTM01

    Изменение данных директора для Mr Stephen James Callaghan 06 авг. 2018 г.

    2 страницыCH01

    Укороченная неаудированная финансовая отчетность на 30 апр. 2017 г.

    8 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 26 нояб. 2017 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    5 страницыAA

    Назначение Ian Michael Noble на должность директора 06 дек. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Andrew Coll в качестве директора 06 дек. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 26 нояб. 2016 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Назначение Mr Stephen James Callaghan на должность директора 10 окт. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий David John Meaden в качестве директора 10 окт. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    5 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    7 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital04 янв. 2016 г.

    Отчет о капитале на 04 янв. 2016 г.

    • Капитал: GBP 61,686,134.332
    SH01

    Свидетельство об изменении наименования компании

    Company name changed northgate public sector LIMITED\certificate issued on 16/06/15
    3 страницыCERTNM
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    change-of-name16 июн. 2015 г.

    Изменение наименования" по решению

    NM01
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    change-of-name

    Решение об изменении наименования

    RES15

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    5 страницыAA

    Полное погашение обременения 11

    4 страницыMR04

    legacy

    страницыANNOTATION

    Кто является должностными лицами NPS (UK5) LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Секретарь компании
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Тип идентификацииЕЭЗ
    Регистрационный номер2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector201347710052
    COUTTS, Cheryl Jane
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    Секретарь
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    British12016130002
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Секретарь
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    HEMMING, Vivienne Ruth
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    Секретарь
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    British41962390006
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    Секретарь
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    British32877720003
    RICHARDSON, John David
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    Секретарь
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    British128558470001
    SADLER, John Michael
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Секретарь
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78431540001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    SHAH, Bijal
    24 Dorset Mews
    Finchley
    N3 2BN London
    Секретарь
    24 Dorset Mews
    Finchley
    N3 2BN London
    British116421860001
    TIDSALL, David Peter Charles
    50 Anglesey Avenue
    Cove
    GU14 8SQ Farnborough
    Hampshire
    Секретарь
    50 Anglesey Avenue
    Cove
    GU14 8SQ Farnborough
    Hampshire
    British3854790001
    WENMAN, Nicholas Edward
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    Секретарь
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    BritishCompany Director14373460003
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Номинированный секретарь
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanDirector165900220001
    BASS, Neil Anthony
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    Директор
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    EnglandBritishDirector70199330002
    BEATON, Richard L'Estrange
    Prestbury Hall
    The Village
    SK10 4BN Prestbury
    Cheshire
    Директор
    Prestbury Hall
    The Village
    SK10 4BN Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director97291590001
    BODHA, James Sanjay
    Rook How
    22 Elm Tree Road
    WA13 0NB Lymm
    Cheshire
    Директор
    Rook How
    22 Elm Tree Road
    WA13 0NB Lymm
    Cheshire
    EnglandBritishDirector93657140001
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director237260100001
    GIBSON, John Leonard
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    Директор
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    BritishDirector104554430001
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    Директор
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    United KingdomBritishAccountant32877720003
    HUNT, Simon Anthony
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    Директор
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    BritishDirector Chartered Accountant118771650001
    KINGSWOOD, Michael
    Holm Farm
    Catesby End Hellidon
    NN11 6GB Daventry
    Northamptonshire
    Директор
    Holm Farm
    Catesby End Hellidon
    NN11 6GB Daventry
    Northamptonshire
    BritishManaging Director123863990001
    MARRISON, Michael Anthony
    10 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    Директор
    10 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director67938980003
    MCCANN, James
    32 Carter Close
    SL4 3QX Windsor
    Berkshire
    Директор
    32 Carter Close
    SL4 3QX Windsor
    Berkshire
    BritishChartered Management Accountan69923680001
    MEADEN, David John
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding
    Estate, Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Директор
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding
    Estate, Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director193740420001
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector199843940001
    ROWLEY, Stephen Paul, Mr.
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    Директор
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director93738770001
    SLOGGETT, David Raymond, Dr
    12 Mcnaughton Close
    GU14 0PX Farnborough
    Hampshire
    Директор
    12 Mcnaughton Close
    GU14 0PX Farnborough
    Hampshire
    BritishDirector34112730001
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Директор
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director66955690003
    TAIT, Ian
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    Директор
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector76976490001
    TYRRELL, Simon Robert Edgar
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    Директор
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director77284710002
    WENMAN, Nicholas Edward
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    Директор
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    BritishCompany Director14373460003
    WOOTTON BEARD, Timothy
    Catkins
    Westhill Road North, South Wonston
    SO21 3HJ Winchester
    Hampshire
    Директор
    Catkins
    Westhill Road North, South Wonston
    SO21 3HJ Winchester
    Hampshire
    BritishCompany Director93274500001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Номинированный директор
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над NPS (UK5) LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииEngland And Wales
    Юридическое основаниеUnited Kingdom (England And Wales)
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер06526803
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у NPS (UK5) LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Deed of accession
    Создан 27 февр. 2009 г.
    Поставлен 09 мар. 2009 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Транзакции
    • 09 мар. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 янв. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Создан 16 февр. 2007 г.
    Поставлен 01 мар. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 01 мар. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 окт. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Создан 15 февр. 2007 г.
    Поставлен 01 мар. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 01 мар. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 окт. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Создан 28 нояб. 2006 г.
    Поставлен 30 нояб. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 30 нояб. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 окт. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 9TH december 2002
    Создан 28 февр. 2006 г.
    Поставлен 02 мар. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 02 мар. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 окт. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of deposit
    Создан 18 дек. 2003 г.
    Поставлен 19 дек. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The deposit.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 19 дек. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 23 июл. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    An omnibus letter of set-off
    Создан 09 дек. 2002 г.
    Поставлен 13 дек. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 13 дек. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 окт. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed and floating security document
    Создан 10 мая 2002 г.
    Поставлен 24 мая 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC,as Security Trustee for the Finance Parties
    Транзакции
    • 24 мая 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 июл. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Fixed and floating security document
    Создан 08 дек. 2000 г.
    Поставлен 21 дек. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All present and future moneys debts and liabilities due owing or incurred by the company to any finance party under or in connection with any finance document (in each case whether alone or jointly or jointly or severally with any other person whether actually or contingently and whether as principal surety or otherwise)
    Краткое описание
    The property as described in the schedule attached to the form 395 all other real property all book debts bank accounts investments uncalled capital and goodwill intellectual property plant and machinery insurances please refer to form 395 for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 21 дек. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 23 мая 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of amendment and restatement (for amending and restating a guarantee & debenture dated 6 october 1995)
    Создан 09 апр. 1999 г.
    Поставлен 21 апр. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 21 апр. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 апр. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 30 янв. 1998 г.
    Поставлен 10 февр. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Bank PLC
    Транзакции
    • 10 февр. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 01 мар. 2002 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 04 июл. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у NPS (UK5) LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    10 июн. 2019 г.Начало ликвидации
    02 окт. 2020 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Практик
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Практик
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0