ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03621275
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Прочие вспомогательные услуги для бизнеса, не включенные в другие группировки (82990) / Административные и вспомогательные услуги

    Где находится ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Юридический адрес
    Composites House
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Derbyshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    PINCO 1110 LIMITED25 авг. 1998 г.25 авг. 1998 г.

    Каковы последние отчеты ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2018 г.

    Какие последние документы подавались ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    17 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 25 авг. 2019 г. без изменений

    3 страницыCS01

    legacy

    1 страницыSH20

    Отчет о капитале на 14 дек. 2018 г.

    • Капитал: GBP 1
    5 страницыSH19

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решения

    Cancellation of share premium account 13/12/2018
    RES13
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    Решения

    Resolutions
    17 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение об изменении прав или наименования акций

    RES12
    incorporation

    Решение об утверждении Устава

    RES01

    Изменение наименования или обозначения класса акций

    2 страницыSH08

    Уведомление о подтверждении, составленное 25 авг. 2018 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    3 страницыAA

    Изменение данных секретаря для Alison Murphy 01 нояб. 2017 г.

    1 страницыCH03

    Уведомление о подтверждении, составленное 25 авг. 2017 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Прекращение полномочий Alison Murphy в качестве директора 01 июл. 2017 г.

    1 страницыTM01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    3 страницыAA

    Отставка аудитора

    1 страницыAUD

    Назначение Mrs Alison Murphy на должность директора 01 нояб. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    3 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 25 авг. 2016 г. с изменениями

    6 страницыCS01

    Прекращение полномочий Roy Douglas Smith в качестве директора 12 авг. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Daniel George Darazsdi в качестве директора 12 авг. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Alison Murphy на должность секретаря 12 авг. 2016 г.

    2 страницыAP03

    Прекращение полномочий Roy Douglas Smith в качестве секретаря 12 авг. 2016 г.

    1 страницыTM02

    Кто является должностными лицами ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    MURPHY, Alison
    Clarendon Road
    WD17 1JJ Watford
    34
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Clarendon Road
    WD17 1JJ Watford
    34
    Hertfordshire
    United Kingdom
    214335080001
    CLEARS, David Shaun
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Директор
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    United KingdomBritish214322760001
    GLENNON, Stephen Matthew
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Директор
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish88291900001
    BOWERS, Steven John
    Thornbury Cottage
    Chalkhill Coleshill
    HP7 0LY Amersham
    Buckinghamshire
    Секретарь
    Thornbury Cottage
    Chalkhill Coleshill
    HP7 0LY Amersham
    Buckinghamshire
    British61929330004
    MALITSKIE, Mark
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    Секретарь
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    British68667640001
    MOORE, Alan Brian
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    Секретарь
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    British14081040001
    MOORE, Alan Brian
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    Секретарь
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    British14081040001
    SMITH, Roy Douglas
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Секретарь
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    170871450001
    TRESIDDER, Hereward Tolmie
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    Секретарь
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    British39200370004
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Секретарь компании
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    BEAUMONT, Richard John Kirby
    10 Milverton Terrace
    CV32 5BA Leamington Spa
    Warwickshire
    Директор
    10 Milverton Terrace
    CV32 5BA Leamington Spa
    Warwickshire
    British98953190001
    BLATHERWICK, Nigel Ashley
    7 Queen Marys Close
    NG12 2NR Nottingham
    Nottinghamshire
    Директор
    7 Queen Marys Close
    NG12 2NR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish118979720001
    BOWERS, Steven John
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    Директор
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    United KingdomBritish176189250001
    DARAZSDI, Daniel George
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Директор
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    UsaAmerican195049720001
    DEVAULT, Jon
    18415 Azofar Ct San Diego Ca
    San Diego
    FOREIGN California
    92128
    United States Of America
    Директор
    18415 Azofar Ct San Diego Ca
    San Diego
    FOREIGN California
    92128
    United States Of America
    American63857020001
    DRILLOCK, David M
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Директор
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    United StatesAmerican170878740001
    ENGLISH, Peter David
    76 Woodside
    Wimbledon
    SW19 7QL London
    Директор
    76 Woodside
    Wimbledon
    SW19 7QL London
    British3355360001
    FORD, Richard Guy
    Water Stratford House
    Water Stratford
    MK18 5DS Buckingham
    Директор
    Water Stratford House
    Water Stratford
    MK18 5DS Buckingham
    British1467170002
    GHAVAM SHAHIDI, Ebrahim
    2 St Georges Close
    Allestree
    DE22 1JH Derby
    Derbyshire
    Директор
    2 St Georges Close
    Allestree
    DE22 1JH Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritish117846410001
    MABBITT, Jonathan Peter
    Sunset
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    Директор
    Sunset
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    EnglandBritish83707310002
    MALITSKIE, Mark
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    Директор
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish68667640001
    MOORE, Alan Brian
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    Директор
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    British14081040001
    MOSS, Andrew Brian
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    Директор
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    EnglandBritish161928410001
    MOSS, Andrew Brian
    Saddlebow Cottage
    Saddlebow Lane
    CV35 8PQ Claverdon
    Warwickshire
    Директор
    Saddlebow Cottage
    Saddlebow Lane
    CV35 8PQ Claverdon
    Warwickshire
    EnglandBritish161928410001
    MURPHY, Alison
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Директор
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    United KingdomBritish111169560001
    POTTS, Hugh Adrian
    7921 S Hudson Avenue
    Tuisa
    Oklahoma
    74136
    Usa
    Директор
    7921 S Hudson Avenue
    Tuisa
    Oklahoma
    74136
    Usa
    UsaBritish52210510003
    ROBERTSON, Douglas Grant
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    Директор
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    EnglandBritish123487130001
    SLOMAN, Roger Mark
    13 Woodside
    Morley
    DE7 6DG Ilkeston
    Derbyshire
    Директор
    13 Woodside
    Morley
    DE7 6DG Ilkeston
    Derbyshire
    British8257720002
    SMITH, Roy Douglas
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Директор
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    UsaUsa170877010001
    SNOWDON, Clive John
    New End Barn
    Spernall Lane Great Alne
    B49 6JD Alcester
    Warwickshire
    Директор
    New End Barn
    Spernall Lane Great Alne
    B49 6JD Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritish32242700001
    STREET, Andrew John
    Fountain House 13 Main Street
    Middleton
    DE4 4LQ Matlock
    Derbyshire
    Директор
    Fountain House 13 Main Street
    Middleton
    DE4 4LQ Matlock
    Derbyshire
    United KingdomBritish36056510008
    TRESIDDER, Hereward Tolmie
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    Директор
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    EnglandBritish39200370004
    WEIDNER, John Charles
    53505 129th East Avenue
    Tulsa
    Oklahoma 74134
    Usa
    Директор
    53505 129th East Avenue
    Tulsa
    Oklahoma 74134
    Usa
    Usa74299320001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Директор компании
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Umeco Limited
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    England
    06 апр. 2016 г.
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited Company
    Юридическое основаниеCompanies Act
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.

    Есть ли у ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Создан 11 дек. 2009 г.
    Поставлен 30 дек. 2009 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 30 дек. 2009 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 19 апр. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement 27TH october 1997,
    Создан 23 нояб. 2006 г.
    Поставлен 29 нояб. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 29 нояб. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 19 апр. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/10/1997
    Создан 16 июл. 2004 г.
    Поставлен 22 июл. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 22 июл. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 19 апр. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Debenture
    Создан 31 мар. 1999 г.
    Поставлен 15 апр. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to the debenture
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Derbyshire Enterprise Board (Investments) Limited
    Транзакции
    • 15 апр. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 мая 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 31 мар. 1999 г.
    Поставлен 15 апр. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to the debenture
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Derbyshire County Council
    Транзакции
    • 15 апр. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 мая 2000 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 31 мар. 1999 г.
    Поставлен 08 апр. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 08 апр. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 22 февр. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0