OPAL HULME LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииOPAL HULME LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03636374
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель OPAL HULME LIMITED?

    • Аренда и эксплуатация недвижимости жилищных ассоциаций (68201) / Операции с недвижимым имуществом

    Где находится OPAL HULME LIMITED?

    Юридический адрес
    2 St Peter's Square
    M2 3EY Manchester
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия OPAL HULME LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    SAVELINE LIMITED22 сент. 1998 г.22 сент. 1998 г.

    Каковы последние отчеты OPAL HULME LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 сент. 2012 г.

    Какие последние документы подавались OPAL HULME LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Уведомление об окончательном счете перед роспуском

    47 страницыWU15

    Отчет о ходе ликвидации от суда

    47 страницыWU07

    Отчет о ходе ликвидации от суда

    45 страницыWU07

    Отчет о ходе ликвидации от суда

    44 страницыWU07

    Юридический адрес изменен с C/O Ernst & Young Llp 100 Barbirolli Square Manchester M2 3EY на 2 st Peter's Square Manchester M2 3EY 11 авг. 2017 г.

    2 страницыAD01

    Регистрация банкротства

    Insolvency:progress report brought down to 24/06/16 resignation of t a jack
    42 страницыLIQ MISC

    Регистрация банкротства

    Insolvency:liquidators annual progress report to 24/02/2016
    41 страницыLIQ MISC

    Регистрация банкротства

    Insolvency:liquidator's annual progress report - compulsory liquidation - b/d date - 24/02/2015
    42 страницыLIQ MISC

    Назначение ликвидатора

    1 страницы4.31

    Приказ суда о ликвидации

    3 страницыCOCOMP

    Приказ суда о ликвидации

    4 страницыCOCOMP

    Уведомление о судебном приказе о завершении администрации

    54 страницы2.33B

    Отчет о ходе администрации до 31 янв. 2014 г.

    46 страницы2.24B

    Отчет о ходе администрации до 11 сент. 2013 г.

    62 страницы2.24B

    Уведомление о предполагаемом одобрении предложений

    1 страницыF2.18

    Заявление о предложениях администратора

    117 страницы2.17B

    Заявление о состоянии дел с приложенной формой 2.14B

    5 страницы2.16B

    Юридический адрес изменен с * C/O Opal Property Group the Place Ducie Street Manchester M1 2TP* 18 мар. 2013 г.

    2 страницыAD01

    Назначение администратора

    1 страницы2.12B

    Годовая бухгалтерская отчетность

    18 страницыAA

    Годовая бухгалтерская отчетность

    18 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital10 окт. 2012 г.

    Отчет о капитале на 10 окт. 2012 г.

    • Капитал: GBP 2
    SH01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    15 страницыAA

    Кто является должностными лицами OPAL HULME LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    MELLOR, Craig Allan
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    Секретарь
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    British60906780002
    DUNCAN, Gavin Robert
    St Peter's Square
    M2 3EY Manchester
    2
    Директор
    St Peter's Square
    M2 3EY Manchester
    2
    EnglandBritish151512820001
    MELLOR, Craig Allan
    St Peter's Square
    M2 3EY Manchester
    2
    Директор
    St Peter's Square
    M2 3EY Manchester
    2
    EnglandBritish60906780002
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Директор
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95010340001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Номинированный секретарь
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Директор
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British87259480001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Номинированный директор
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Есть ли у OPAL HULME LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Composite guarantee and debenture
    Создан 23 мая 2005 г.
    Поставлен 28 мая 2005 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any obligor to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Oxford court stertford road hulme manchester t/no gm 801268. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 28 мая 2005 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 04 июл. 2002 г.
    Поставлен 17 июл. 2002 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    L/H land on the south side of stretford road, hulme (k/a oxford court) t/no. GM801268 and l/h land being briarfields boundary lane, hulme t/no. GM826100. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Securitytrustee)
    Транзакции
    • 17 июл. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 08 февр. 2002 г.
    Поставлен 26 февр. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Транзакции
    • 26 февр. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 20 авг. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 08 февр. 2002 г.
    Поставлен 26 февр. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Leasehold property k/a site 9 stretford road hulme manchester t/n GM801268 and leasehold property k/a briarfields boundary lane hulme manchester t/n GM826400 together with the gross rents licence fees and other monies the benefit of all guarantees and any agreements any and all insurance policies and the goodwill of any business. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Транзакции
    • 26 февр. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 20 авг. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 31 окт. 2001 г.
    Поставлен 02 нояб. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Транзакции
    • 02 нояб. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 20 авг. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 27 июл. 2000 г.
    Поставлен 28 июл. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Краткое описание
    All estate interest or right whatsoever of the mortgagor in an agreement dated 10TH december 1999 between the company and watkin jones & sons limited by whichg the contractor agreed to carry out consytruct and complete certain works at the site at briarfield boundary lane hulme.
    Уполномоченные лица
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Транзакции
    • 28 июл. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 20 авг. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 10 авг. 1999 г.
    Поставлен 17 авг. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    L/Hold property known as briarfields boundary lane hulme city of manchester; the goodwill of business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Уполномоченные лица
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Транзакции
    • 17 авг. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 20 авг. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 11 мар. 1999 г.
    Поставлен 26 мар. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Краткое описание
    L/H property site 9 stretford road hulme manchester together with goodwill of any business at the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Уполномоченные лица
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Транзакции
    • 26 мар. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 20 авг. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 11 мар. 1999 г.
    Поставлен 24 мар. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Транзакции
    • 24 мар. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 20 авг. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у OPAL HULME LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    12 мар. 2013 г.Начало управления
    25 февр. 2014 г.Окончание управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Практик
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Практик
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Samuel James Woodward
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Практик
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    2
    ДатаТип
    13 сент. 2019 г.Завершение ликвидации
    10 февр. 2014 г.Дата подачи заявления
    25 февр. 2014 г.Начало ликвидации
    19 февр. 2020 г.Дата ликвидации
    Принудительная ликвидация
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Практик
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Практик
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samuel James Woodward
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Практик
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    The Official Receiver Or Manchester
    2nd Floor, 3 Piccadilly Place
    London Road
    M1 3BN Manchester
    Практик
    2nd Floor, 3 Piccadilly Place
    London Road
    M1 3BN Manchester

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0