IGROUP BDA LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииIGROUP BDA LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03675910
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель IGROUP BDA LIMITED?

    • Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки (64999) / Финансовая и страховая деятельность

    Где находится IGROUP BDA LIMITED?

    Юридический адрес
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия IGROUP BDA LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    OCWEN BDA LIMITED24 нояб. 1998 г.24 нояб. 1998 г.

    Каковы последние отчеты IGROUP BDA LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 нояб. 2015 г.

    Какие последние документы подавались IGROUP BDA LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    8 страницыLIQ13

    Прекращение полномочий Kalpna Shah в качестве секретаря 28 февр. 2018 г.

    2 страницыTM02

    Юридический адрес изменен с PO Box 2497 Building 4 Hatters Lane Watford WD18 1YY United Kingdom на 30 Finsbury Square London EC2P 2YU 07 мар. 2018 г.

    2 страницыAD01

    Назначение ликвидатора

    3 страницы600

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 20 февр. 2018 г.

    LRESSP

    Заявление о платежеспособности

    5 страницыLIQ01

    Уведомление о подтверждении, составленное 24 нояб. 2017 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Прекращение полномочий Richard William Bird в качестве директора 29 сент. 2017 г.

    1 страницыTM01

    Предыдущий отчетный период продлен

    1 страницыAA01

    Прекращение полномочий Laurence Anne Renee Perrin в качестве директора 30 дек. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 24 нояб. 2016 г. с изменениями

    10 страницыCS01

    legacy

    1 страницыSH20

    Отчет о капитале на 16 нояб. 2016 г.

    • Капитал: GBP 1
    3 страницыSH19

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06

    Назначение Miss Samantha Jones на должность директора 10 окт. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Bernardus Petrus Maria Van Bunnik в качестве директора 01 окт. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Юридический адрес изменен с Building 4 Hatters Lane Croxley Green Business Park Watford Hertfordshire WD18 8YF на PO Box 2497 Building 4 Hatters Lane Watford WD18 1YY 23 авг. 2016 г.

    1 страницыAD01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    23 страницыAA

    Прекращение полномочий Manuel Uria-Fernandez в качестве директора 14 июн. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Richard William Bird на должность директора 14 июн. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Изменение данных директора для Mr Manuel Uria-Fernandez 17 дек. 2015 г.

    2 страницыCH01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital27 нояб. 2015 г.

    Отчет о капитале на 27 нояб. 2015 г.

    • Капитал: GBP 10,000,001
    SH01

    Отчет о капитале после размещения акций 15 сент. 2015 г.

    • Капитал: GBP 10,000,001
    3 страницыSH01

    Кто является должностными лицами IGROUP BDA LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    JONES, Samantha
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Директор
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    United KingdomBritish216074420001
    SHAH, Kalpna
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Секретарь
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    199403700001
    SHAH, Kalpna
    18 Vicarage Road
    WD18 0EH Watford
    Hertfordshire
    Секретарь
    18 Vicarage Road
    WD18 0EH Watford
    Hertfordshire
    British80753870001
    FN SECRETARY LIMITED
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Секретарь компании
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    88740300002
    RUTLAND SECRETARIES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Номинированный секретарь
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005290001
    AINSWORTH, Keith
    76 Howes Lane
    Finham
    CV3 6PJ Coventry
    Warwickshire
    Директор
    76 Howes Lane
    Finham
    CV3 6PJ Coventry
    Warwickshire
    EnglandBritish46161840001
    BELLORA, Michael Richard
    Russet House
    1a Latchmoor Avenue
    SL9 8LL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Директор
    Russet House
    1a Latchmoor Avenue
    SL9 8LL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    American98453650001
    BERRY, Duncan Gee
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    Директор
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    EnglandBritish107695600022
    BIRD, Richard William
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    Директор
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    United KingdomBritish209298590001
    BOAKES, Jeremy Edward
    41 Sherrards Park Road
    AL8 7LD Welwyn Garden City
    Herts
    Директор
    41 Sherrards Park Road
    AL8 7LD Welwyn Garden City
    Herts
    British106122240001
    BRENNAN, Peter
    10 Ardross Avenue
    HA6 3DS Northwood
    Middlesex
    Директор
    10 Ardross Avenue
    HA6 3DS Northwood
    Middlesex
    British84912240001
    CAMERON, Ewan Douglas
    13 Heathfield Gardens
    W4 4JU London
    Директор
    13 Heathfield Gardens
    W4 4JU London
    British122900270001
    CARSON, David Richard
    26 Loynells Road
    Rednal
    B45 9NP Birmingham
    Директор
    26 Loynells Road
    Rednal
    B45 9NP Birmingham
    British73271960002
    CRICHTON, Susan Elizabeth
    The Pheasantries
    Ley Hill
    HP5 3QR Chesham
    Buckinghamshire
    Директор
    The Pheasantries
    Ley Hill
    HP5 3QR Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish69358970001
    DE RIDDER, Kimon Celicourt Macris, Dr
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131081660001
    DEANE JOHNS, Simon Joshua
    61 Stanlake Road
    W12 7HG London
    Директор
    61 Stanlake Road
    W12 7HG London
    Australian80748330001
    DLUTOWSKI, Joseph Arthur
    13127 Silver Fox Lane
    Palm Beach Gardens
    Palm Beach County 33418
    United States Of America
    Директор
    13127 Silver Fox Lane
    Palm Beach Gardens
    Palm Beach County 33418
    United States Of America
    American66506120001
    ERBEY, William Charles
    110 Sunset Avenue Apartment 2b
    3947 Palm Beach
    Florida 33480-3947
    United Statesof America
    Директор
    110 Sunset Avenue Apartment 2b
    3947 Palm Beach
    Florida 33480-3947
    United Statesof America
    American58072470001
    EVANS, Kellie Victoria
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish167417000001
    FERGUSON, Ian George
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish133318850001
    FLYNN, William John
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British99330320002
    GARDEN, Robert James
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152764360001
    GUNNIGLE, Clodagh
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish138244630002
    HARRIS, Jeffrey
    9 Northaw Place
    Coopers Lane
    EN6 4NQ Northaw
    Hertfordshire
    Директор
    9 Northaw Place
    Coopers Lane
    EN6 4NQ Northaw
    Hertfordshire
    American98233530002
    HARVEY, David
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish97086950001
    HARVEY, Richard John
    6 Heronsford
    West Hunsbury
    NN4 9XG Northampton
    Northamptonshire
    Директор
    6 Heronsford
    West Hunsbury
    NN4 9XG Northampton
    Northamptonshire
    British122892160001
    HUNKIN, Ricky David
    2 Hockeridge View
    Oakwood
    HP4 3NB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Директор
    2 Hockeridge View
    Oakwood
    HP4 3NB Berkhamsted
    Hertfordshire
    British115390900001
    JOHAR, Mandeep Singh
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIndian127046380002
    JOHNSON, Alec David
    12 The Witherings, Emerson Park
    RM11 2RA Hornchurch
    Essex
    Директор
    12 The Witherings, Emerson Park
    RM11 2RA Hornchurch
    Essex
    United KingdomBritish103446140001
    KAGAN, Jeffrey Allan
    14 Norrice Lea
    N2 0RE London
    Директор
    14 Norrice Lea
    N2 0RE London
    Australian78535300001
    MILLWARD, Keith Roger
    Le Marque Manor Close
    Penn
    HP10 8HZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Директор
    Le Marque Manor Close
    Penn
    HP10 8HZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish80388420001
    PERRIN, Laurence Anne Renee
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    Директор
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    United KingdomFrench183220720001
    PICKERING, Steven Mark
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    Директор
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United KingdomBritish164833430002
    PUNCH, Andrew Robert
    Pepys Way
    6 Ford Road
    GU24 9EJ Bisley
    Surrey
    Директор
    Pepys Way
    6 Ford Road
    GU24 9EJ Bisley
    Surrey
    United KingdomBritish147703850001
    SANDERS, Colin George
    Burleigh Grange
    Nightingales Lane
    HP8 4SR Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Директор
    Burleigh Grange
    Nightingales Lane
    HP8 4SR Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British81421480002

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над IGROUP BDA LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    08 сент. 2016 г.
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииEngland And Wales
    Юридическое основаниеUnited Kingdom (England And Wales)
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер5128935
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.
    Hatters Lane
    2497
    WD18 1YY Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    Hatters Lane
    2497
    WD18 1YY Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Да
    Организационно-правовая формаUnlimited With Shares
    Страна регистрацииEngland
    Юридическое основаниеUnited Kingdom (England)
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер06440028
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у IGROUP BDA LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Deed of charge
    Создан 06 апр. 2001 г.
    Поставлен 20 апр. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All obligations (whether actual or contingent, present and future) of the company owing or owed to the chargee under the terms loan facility dated 1ST october 1999, the coupon facility dated 12TH january 2000, the coupon facility dated 26TH april 2000, the coupon facility dated 15TH august 2000, the coupon facility dated 20TH november 2000 and the finance documents
    Краткое описание
    By way of first fixed security all of the borrower's rights and benefits under the custody agreement; all of the borrower's rights title and interest in and to the coupon securities and all sums payable or which become payable in respect of the coupon securities;. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 20 апр. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Pledge agreement
    Создан 06 апр. 2001 г.
    Поставлен 20 апр. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All obligations (whether actual or contingent, present and future) of the company owing or owed to the chargee under the terms loan facility dated 1ST october 1999, the coupon facility dated 12TH january 2000, the coupon facility dated 26TH april 2000, the coupon facility dated 15TH august 2000, the coupon facility dated 20TH november 2000 and the finance documents
    Краткое описание
    The coupon securities and any cash balances standing from time to time to the credit of the collateral account (as more particularly defined in the pledge).
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 20 апр. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of charge
    Создан 20 нояб. 2000 г.
    Поставлен 30 нояб. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the term loan facility dated 1ST october 1999 and a deed of charge dated 1ST october 1999 and/or the coupon facility dated 12TH january 2000 and a deed of charge dated 12TH january 2000 and/or the coupon facility dated 26TH april 2000 and the deed of charge dated 26TH april 2000 and/or the coupon facility dated 15TH august 2000 and the deed of charge dated 15TH august 2000 and/or the finance documents (as defined) as such documents may be amended from time to time
    Краткое описание
    All of the borrower's rights and benefits under the custody agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 30 нояб. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Pledge agreement
    Создан 20 нояб. 2000 г.
    Поставлен 30 нояб. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the term loan facility dated 1 october 1999 and a deed of charge of the same date and/or the coupon facility dated 12 january 2000 and a deed of charge of the same date and/or the coupon facility dated 26 april 2000 and a deed of charge of the same date and/or the coupon facility dated 15 august 2000 and a deed of charge of the same date and/or the finance documents (all as defined therein)
    Краткое описание
    The pledgor pledged the charged assets (as defined therein). See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 30 нояб. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of charge
    Создан 06 сент. 2000 г.
    Поставлен 16 сент. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the term loan facility dated 1 october 1999 and deed of charge dated 1 october 1999 and/or the coupon facility dated 12 january 2000 and a deed of charge dated 12 january 2000 and/or the finance documents
    Краткое описание
    By way of first fixed security all rights and benefits under the custody agreement and to the coupon securities and all sums payable in respect of the coupon securities and all rights title and interest in and to the coupon account. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 16 сент. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Pledge agreement
    Создан 06 сент. 2000 г.
    Поставлен 16 сент. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the term loan facility dated 1 october 1999 and deed of charge dated 1 october 1999 and/or the coupon facility dated 12 january 2000 and deed of charge dated 12 january 2000 and/or the finance documents
    Краткое описание
    The charged assets meaning the coupon securities and any cash balances standing from time to time to the credit of the collateral account. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 16 сент. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Pledge agreement
    Создан 15 авг. 2000 г.
    Поставлен 24 авг. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under (a) the term loan facility dated 1 october 1999 and a deed of charge dated 1 october 1999,(b) the coupon facility dated 12 january 2000 and a deed of charge dated 12 january 2000 and/or (c) the coupon facility dated 26 april 2000 and the deed of charge dated 26 april 2000 and/or (d) the finance documents (all terms as defined)
    Краткое описание
    The charged assets,as defined, and any cash balances from time to time standing to the credit of the collateral account. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 24 авг. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of charge
    Создан 15 авг. 2000 г.
    Поставлен 24 авг. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the term loan facility dated 01/10/99, the coupon facility dated 12/01/00 and 26/04/00 and the finance documents
    Краткое описание
    All of the borrowers rights and benefits under the custody agreement and other agreements and accounts the details of which are listed on the form 395.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 24 авг. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Pledge agreement
    Создан 12 янв. 2000 г.
    Поставлен 20 янв. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a term loan facility dated 1 october 1999
    Краткое описание
    The pledgor pledged the charged assets to the pledgee as security for the due perfrmance of the secured liabilities. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 20 янв. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of charge
    Создан 12 янв. 2000 г.
    Поставлен 20 янв. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a term loan facility dated 1 october 1999
    Краткое описание
    The borrower with full title guarantee and as continuing security for the secured liabilities by way of first fixed security all the rights and benefits under the custody agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 20 янв. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of charge
    Создан 01 окт. 1999 г.
    Поставлен 12 окт. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the term loan facility the guarantee the pledge agreement an any other document pursuant to which the company owes any obligation to the chargee from time to time
    Краткое описание
    All the company's rights and benefits under the custody agreement, all right title and interest in and to the charged securities and all monies derived therefrom and all of the company's right title benefit and interest in and to the ocwen bda limited account together with floating charge all present and future undertakings assets and rights not charged by way of fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 12 окт. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Pledge agreement
    Создан 01 окт. 1999 г.
    Поставлен 12 окт. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies and obligations (whether actual or contingent, present or future) of the company to the chargee under the term loan facility, the guarantee and the deed of charge.
    Краткое описание
    The pledgor pledged the charged securities and any cash balances standing from time to time to the credit of the collateral account.. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 12 окт. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of charge
    Создан 11 июн. 1999 г.
    Поставлен 25 июн. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All obligations of the company to the chargee under the secured term loan facility dated 4TH december 1998 and the finance documents
    Краткое описание
    All the borrowers rights and benefits under the custody agreement, the coupon securities and all sums payable in respect of the coupon securities. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 25 июн. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Pledge agreement
    Создан 11 июн. 1999 г.
    Поставлен 25 июн. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All obligations (whether actual or contingent, present or future) of the company to the chargee under (a) a secured term loan facility dated 4TH december 1998 and a deed of charge dated 4TH december 1998; and (b) the finance documents
    Краткое описание
    The pldgor pledged the charged assets to the pledgee,. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 25 июн. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of charge
    Создан 04 дек. 1998 г.
    Поставлен 18 дек. 1998 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All obligations of the company to the chargee under the secured term loan facility dated 4TH december 1998
    Краткое описание
    All the borrowers rights and benefits under the custody agreement, the charged securities and all sums payable in respect of the charged securities. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 18 дек. 1998 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 янв. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у IGROUP BDA LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    20 февр. 2018 г.Начало ликвидации
    23 нояб. 2018 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Практик
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0