CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииCBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03712018
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED?

    • (6603) /

    Где находится CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED?

    Юридический адрес
    Yorkshire House
    18 Chapel Street
    L3 9AG Liverpool
    Merseyside
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    CBS INSURANCE HOLDINGS PLC24 мар. 1999 г.24 мар. 1999 г.
    FORECASTWIN PUBLIC LIMITED COMPANY11 февр. 1999 г.11 февр. 1999 г.

    Каковы последние отчеты CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2010 г.

    Какие последние документы подавались CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    7 страницы4.71

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 15 февр. 2012 г.

    LRESSP

    Заявление о платежеспособности

    3 страницы4.70

    Решения

    Resolutions
    3 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 15 февр. 2012 г.

    LRESSP

    Юридический адрес изменен с Unit C25 Jacks Place 6 Corbet Place London E1 6NN 21 февр. 2012 г.

    2 страницыAD01

    Консолидированная бухгалтерская отчетность

    32 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    18 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital03 мар. 2011 г.

    Отчет о капитале на 03 мар. 2011 г.

    • Капитал: GBP 4,593.86
    SH01

    Консолидированная бухгалтерская отчетность

    36 страницыAA

    Отчет о капитале на 18 авг. 2010 г.

    • Капитал: GBP 4,559.3855
    4 страницыSH19

    legacy

    1 страницыSH20

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об изменении Устава

    RES01
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06
    capital

    Решения

    Reduce share prem 14/07/2010
    RES13

    Годовой отчет. Список акционеров изменен

    22 страницыAR01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    22 страницыAR01

    Консолидированная бухгалтерская отчетность

    35 страницыAA

    legacy

    13 страницы363a

    legacy

    1 страницы353

    legacy

    1 страницыSH20

    legacy

    1 страницыCAP-MDSC

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решения

    Reduction of share premium account 17/12/2008
    RES13

    Свидетельство о перерегистрации с акционерного общества на общество с ограниченной ответственностью

    1 страницыCERT10

    Перерегистрация Меморандума и Устава

    48 страницыMAR

    Кто является должностными лицами CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    FOX, Andrew Staley
    4 Dukes Road
    RH16 2JH Haywards Heath
    West Sussex
    Секретарь
    4 Dukes Road
    RH16 2JH Haywards Heath
    West Sussex
    British43073160004
    EWART, David John
    Courthill House
    Potterne
    SN10 5PN Devizes
    Wiltshire
    Директор
    Courthill House
    Potterne
    SN10 5PN Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish23635320001
    HARBORD-HAMOND, Charles Anthony Assheton
    45 Alderbrook Road
    SW12 8AD London
    Директор
    45 Alderbrook Road
    SW12 8AD London
    United KingdomBritish56874210004
    CRAWFORD SMITH, Neil Leslie
    11 Manor Rise
    ME14 4DB Bearsted
    Kent
    Секретарь
    11 Manor Rise
    ME14 4DB Bearsted
    Kent
    British97197960001
    HILL, Jeremy Grahame
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    Секретарь
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    British69062000004
    MCMULLEN, Gerald Phipps
    Little Broomhall Warnham
    RH12 3PA Horsham
    West Sussex
    Секретарь
    Little Broomhall Warnham
    RH12 3PA Horsham
    West Sussex
    British19668600001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Номинированный секретарь
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CASTELL, Andrew Sean
    13 Chantry Street
    N1 8NR London
    Директор
    13 Chantry Street
    N1 8NR London
    British85990150001
    FABER, Robin Henry Grey
    Kingsmead House
    Didmarton
    GL9 1DT Badminton
    South Gloucestershire
    Директор
    Kingsmead House
    Didmarton
    GL9 1DT Badminton
    South Gloucestershire
    EnglandBritish104985010001
    HILL, Jeremy Grahame
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    Директор
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    British69062000004
    HOLBECH, Timothy Hugh
    64 Geraldine Road
    SW18 2NL London
    Директор
    64 Geraldine Road
    SW18 2NL London
    British19390190001
    LEE, Michael Alan
    4 Wilona Avenue
    North Sydney
    FOREIGN Nsw
    2060
    Australia
    Директор
    4 Wilona Avenue
    North Sydney
    FOREIGN Nsw
    2060
    Australia
    Australian92794500001
    MCCLEAN, Michael Hugh Patrick
    33b Cornwall Crescent
    W11 1PJ London
    Директор
    33b Cornwall Crescent
    W11 1PJ London
    British57912890001
    ROYDS, Emma Louise
    4 Lysias Road
    SW12 8BP London
    Директор
    4 Lysias Road
    SW12 8BP London
    British30320080003
    SPARROW, Andrew James
    Eye Kettleby Hall
    LE14 2TS Melton Mowbray
    Leicestershire
    Директор
    Eye Kettleby Hall
    LE14 2TS Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritish19390170004
    WATSON, Michael John Bannatyne
    3 Edenhurst Avenue
    SW6 3PD London
    Директор
    3 Edenhurst Avenue
    SW6 3PD London
    British64292610002
    WHITE, Graham John
    Toad Hall Glebe House
    38 High Street Melbourn
    SG8 6DZ Royston
    Hertfordshire
    Директор
    Toad Hall Glebe House
    38 High Street Melbourn
    SG8 6DZ Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish116735630001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Номинированный директор
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Номинированный директор
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    Есть ли у CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 14 окт. 2004 г.
    Поставлен 25 окт. 2004 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the trustee or any of the other beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of first fixed charge the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares, all dividends, interest and other moneys payable in respect of the shares; and all monetary claims and all related rights. Assignment of the proceeds of any insurance policy and all related rights; and all rights and claims in relation to any assigned account. First floating charge over the whole of the company's undertaking and assets, both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee for the Beneficiaries
    Транзакции
    • 25 окт. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    Share charge
    Создан 11 окт. 2004 г.
    Поставлен 25 окт. 2004 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of first fixed charge all right title and interest in and to the shares all dividends interest and other monies payable in respect of the shares and all other related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 25 окт. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 11 окт. 2004 г.
    Поставлен 25 окт. 2004 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of fixed charge the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares, all dividends, interest and other moneys payable in respect of the shares; and all monetary claims and all related rights. Assignment of the proceeds of any insurance policy and all related rights; and all rights and claims in relation to any assigned account. First floating charge over the whole of the company's undertaking and assets, both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 25 окт. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 нояб. 2004 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    Floating charge
    Создан 21 февр. 2002 г.
    Поставлен 07 мар. 2002 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Floating charge. Undertaking and all property and assets.
    Уполномоченные лица
    • The Society Incorporated by Lloyd's Act 1871
    Транзакции
    • 07 мар. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 15 янв. 2002 г.
    Поставлен 16 янв. 2002 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 16 янв. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 нояб. 2004 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    Debenture
    Создан 26 нояб. 1999 г.
    Поставлен 03 дек. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the finance documents (as defined)
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 03 дек. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 нояб. 2004 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 18 окт. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    04 мар. 2013 г.Дата ликвидации
    15 февр. 2012 г.Начало ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Paul J Fleming
    Yorkshire House 18 Chapel Street
    L3 9AG Liverpool
    Практик
    Yorkshire House 18 Chapel Street
    L3 9AG Liverpool

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0