SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииSELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03762419
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED?

    • Прочая деятельность в области здравоохранения (86900) / Здравоохранение и социальные услуги

    Где находится SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Юридический адрес
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United Kingdom
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Каковы последние отчеты SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 сент. 2011 г.

    Какие последние документы подавались SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Прекращение полномочий Angela Culhane в качестве директора 25 июн. 2012 г.

    1 страницыTM01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    17 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital19 апр. 2012 г.

    Отчет о капитале на 19 апр. 2012 г.

    • Капитал: GBP 1,350
    SH01

    Назначение Jonathan David Calow на должность секретаря 08 дек. 2011 г.

    1 страницыAP03

    Прекращение полномочий Care Uk Services Ltd в качестве секретаря 08 дек. 2011 г.

    1 страницыTM02

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    Юридический адрес изменен с Connaught House the Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9QB 03 мая 2011 г.

    1 страницыAD01

    Изменение данных директора для Paul Justin Humphreys 01 апр. 2011 г.

    2 страницыCH01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    17 страницыAA

    Назначение Paul John Watson на должность директора

    2 страницыAP01

    Изменение данных директора для Michael Robert Parish 10 авг. 2010 г.

    2 страницыCH01

    legacy

    3 страницыMG02

    legacy

    3 страницыMG02

    Решения

    Resolutions
    12 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об изменении Устава

    RES01

    legacy

    28 страницыMG01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    17 страницыAA

    Назначение Deborah Jane Marriott-Boam на должность директора

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Geoffrey Benn в качестве директора

    1 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01
    Аннотации
    ДатаАннотация
    31 окт. 2025 г.Other Any information marked (#) was made unavailable on 31/10/2025 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Изменение данных секретаря для Care Uk Services Ltd 01 апр. 2010 г.

    2 страницыCH04

    Прекращение полномочий Douglas Umbers в качестве директора

    1 страницыTM01

    Назначение Angela Hector Culhane на должность директора

    2 страницыAP01

    Кто является должностными лицами SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    CALOW, Jonathan David
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Секретарь
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    165633600001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Директор
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish33223550003
    MARRIOTT-BOAM, Deborah Jane
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Директор
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish151689670001
    PARISH, Michael Robert
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Директор
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish78828750003
    WATSON, Paul John
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Директор
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish82460360003
    BURKE, Michael Anthony
    1446 Stratford Road
    B28 9ES Birmingham
    West Midlands
    Секретарь
    1446 Stratford Road
    B28 9ES Birmingham
    West Midlands
    British101343700001
    GEORGE, Valerie Grace
    1446 Stratford Road
    Hall Green
    B28 9ES Birmingham
    Секретарь
    1446 Stratford Road
    Hall Green
    B28 9ES Birmingham
    British66299990002
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    Секретарь
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    British33223550003
    CARE UK SERVICES LTD
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Секретарь компании
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Тип идентификацииЕЭЗ
    Регистрационный номер2482660
    125241530002
    JPCORS LIMITED
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    Номинированный секретарь
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    900001430001
    BENN, Geoffrey Richard
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    Директор
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    EnglandBritish73786580001
    BOOKER, Roger Ian
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    Директор
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish14044530003
    BURKE, Michael Anthony
    1446 Stratford Road
    B28 9ES Birmingham
    West Midlands
    Директор
    1446 Stratford Road
    B28 9ES Birmingham
    West Midlands
    British101343700001
    BURKE, Michelle Deborah
    1446 Stratford Road
    Hall Green
    B28 9ES Birmingham
    West Midlands
    Директор
    1446 Stratford Road
    Hall Green
    B28 9ES Birmingham
    West Midlands
    British66299740002
    CULHANE, Angela
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Директор
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish68602910001
    GEORGE, Valerie Grace
    1446 Stratford Road
    Hall Green
    B28 9ES Birmingham
    Директор
    1446 Stratford Road
    Hall Green
    B28 9ES Birmingham
    British66299990002
    HASTINGS, Roy
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    Директор
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    United KingdomBritish130098430001
    QUINN, David Laurence, Mr.
    6 Whitecross Road
    HP17 8BA Haddenham
    Buckinghamshire
    Директор
    6 Whitecross Road
    HP17 8BA Haddenham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish123356660001
    UMBERS, Douglas
    SO53
    Директор
    SO53
    United KingdomBritish90541690001
    VOCKINS, Anthony Frederick
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    Директор
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    EnglandBritish130512090002
    JPCORD LIMITED
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    Номинированный директор
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    900001420001

    Есть ли у SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 21 июл. 2010 г.
    Поставлен 26 июл. 2010 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Ing Bank Nv, London Branch (As Security Agent)
    Транзакции
    • 26 июл. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    Debenture
    Создан 16 мар. 2007 г.
    Поставлен 04 апр. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 04 апр. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 июл. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Debenture
    Создан 22 сент. 2006 г.
    Поставлен 29 сент. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Транзакции
    • 29 сент. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 июл. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Legal charge
    Создан 24 окт. 2003 г.
    Поставлен 12 нояб. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The property known as maple leaf lodge redhill road forhill. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 12 нояб. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 мая 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 12 июл. 1999 г.
    Поставлен 13 июл. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Midland Bank PLC
    Транзакции
    • 13 июл. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 янв. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0