FOOD PARTNERS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииFOOD PARTNERS LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03804549
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель FOOD PARTNERS LIMITED?

    • Спящие компании (99999) / Деятельность экстратерриториальных организаций и органов

    Где находится FOOD PARTNERS LIMITED?

    Юридический адрес
    2 The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия FOOD PARTNERS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    DMWSL 270 LIMITED09 июл. 1999 г.09 июл. 1999 г.

    Каковы последние отчеты FOOD PARTNERS LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 сент. 2018 г.

    Какие последние документы подавались FOOD PARTNERS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем принудительной ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Действие по принудительной ликвидации приостановлено

    1 страницыDISS16(SOAS)

    Первое уведомление в Вестнике о принудительной ликвидации

    1 страницыGAZ1

    Прекращение полномочий Martin Johnson в качестве директора 03 июн. 2020 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Diarmuid Brendan Conifrey в качестве директора 24 июн. 2020 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Diarmuid Brendan Conifrey на должность директора 08 апр. 2020 г.

    2 страницыAP01

    Судебное постановление

    S1096 Court Order to Rectify
    6 страницыOC

    Уведомление о подтверждении, составленное 30 авг. 2019 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    22 страницыAA

    Полное погашение обременения 11

    4 страницыMR04

    legacy

    страницыANNOTATION

    Уведомление о подтверждении, составленное 30 авг. 2018 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерская отчетность дочерней компании с освобождением от аудита

    23 страницыAA

    legacy

    2 страницыAGREEMENT2

    legacy

    47 страницыPARENT_ACC

    legacy

    3 страницыGUARANTEE2

    Предыдущий отчетный период продлен

    1 страницыAA01

    Уведомление о подтверждении, составленное 30 авг. 2017 г. с изменениями

    3 страницыCS01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    31 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 30 авг. 2016 г. с изменениями

    6 страницыCS01

    Прекращение полномочий Mark Ian Tentori в качестве директора 27 апр. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Gavin Cox в качестве секретаря 08 мар. 2016 г.

    1 страницыTM02

    Прекращение полномочий Gavin Eliot Cox в качестве директора 07 мар. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Martin Johnson на должность директора 25 февр. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Назначение Mr Mark Ian Tentori на должность директора 06 окт. 2015 г.

    2 страницыAP01

    Кто является должностными лицами FOOD PARTNERS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    COX, Gavin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Секретарь
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    165756650001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    Секретарь
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    British150500050001
    ROBERTSON, Neil Charles
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    Секретарь
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    BritishChartered Accountant48323870001
    THORNE, Michael
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Секретарь
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British71735980002
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Номинированный секретарь
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Номинированный секретарь
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    CHREE, Ian Charles Gordon
    6 The Grange
    Perceton
    KA11 2EU Irvine
    Ayrshire
    Директор
    6 The Grange
    Perceton
    KA11 2EU Irvine
    Ayrshire
    ScotlandBritishCompany Director65127980003
    CONIFREY, Diarmuid Brendan
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Директор
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandIrishChief Finance Officer268799160001
    COX, Gavin Eliot
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Директор
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    United KingdomBritishDirector153840250001
    EARL, Elizabeth Jane
    Waverley
    Burners Heath
    GU24 0DJ Pirbright Woking
    Surrey
    Директор
    Waverley
    Burners Heath
    GU24 0DJ Pirbright Woking
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director202375770001
    HAZELDEAN, William James
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    Директор
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritishCompany Director83660790002
    HULBERT, David John
    St Michaels Way
    Steeple Claydon
    MK18 2QD Buckingham
    53
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Директор
    St Michaels Way
    Steeple Claydon
    MK18 2QD Buckingham
    53
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishOperational And Technical Dire136463020001
    JOHNSON, Martin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Директор
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritishDirector140167360001
    KILSHAW, David Charles
    Drumallan
    283 North Deeside Road, Cults
    AB15 9PA Aberdeen
    Директор
    Drumallan
    283 North Deeside Road, Cults
    AB15 9PA Aberdeen
    United KingdomBritishIndustrial Manager18455470002
    KINGSLEY BATES, Paul
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Директор
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director132962170001
    MCLELLAND, Stewart
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    Директор
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishDirector157009150001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Директор
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector51784930002
    POCOCK, Patrick William
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    Директор
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    BritishCompany Director96978470001
    ROBERTSON, Neil Charles
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    Директор
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    United KingdomBritishChartered Accountant48323870001
    ROBINSON, Stuart John
    Westfield House
    Harburn
    EH55 8RB West Calder
    West Lothian
    Директор
    Westfield House
    Harburn
    EH55 8RB West Calder
    West Lothian
    BritishCompany Director63448390001
    TENTORI, Mark Ian
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Директор
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritishChief Finance Officer119564310001
    THOMAS, Christopher
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Директор
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritishDirector63844650001
    THORNE, Michael
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Директор
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director71735980002
    THORPE, Alan
    7 Oak Wynd
    Cambuslang
    G72 7GS Glasgow
    Директор
    7 Oak Wynd
    Cambuslang
    G72 7GS Glasgow
    BritishDistribution Manager81775420001
    TRUELOVE, Amelia Anne
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Директор
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    BritishDirector37845970003
    WOOD, Steven John
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Директор
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritishDirector232132390001
    25 NOMINEES LIMITED
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    Директор компании
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    42409900001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над FOOD PARTNERS LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Adelie Foods Group Limited
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    06 апр. 2016 г.
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаAdelie Foods Group Limited
    Страна регистрацииEngalnd & Wales
    Юридическое основаниеCompanies Act 2006
    Место регистрацииRegistrar Of Companies
    Регистрационный номер07964277
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.

    Есть ли у FOOD PARTNERS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 05 мар. 2015 г.
    Поставлен 11 мар. 2015 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    None.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Транзакции
    • 11 мар. 2015 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 31 мая 2013 г.
    Поставлен 07 июн. 2013 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    A fixed charge over all land (I.E. any interest in heritable, freehold or leasehold land) vested in or charged to food partners limited, owned now or in the future. This includes all fixtures and fittings attached to the land and all rents receivable from any lease granted out of the land.. A fixed charge, subject to third party consents, over all intellectual property of food partners limited, owned now or in the future.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Транзакции
    • 07 июн. 2013 г.Регистрация залога (MR01)
    • 10 мар. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 31 мая 2013 г.
    Поставлен 05 июн. 2013 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Punjab National Bank (International) Limited
    Транзакции
    • 05 июн. 2013 г.Регистрация залога (MR01)
    • 06 февр. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Debenture
    Создан 11 апр. 2012 г.
    Поставлен 14 апр. 2012 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor or any future obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 14 апр. 2012 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 07 июн. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Создан 11 апр. 2012 г.
    Поставлен 14 апр. 2012 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Pnc Business Credit, a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Транзакции
    • 14 апр. 2012 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 07 июн. 2013 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Rent deposit deed
    Создан 20 окт. 2011 г.
    Поставлен 01 нояб. 2011 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    £56,000 due or to become due
    Краткое описание
    The deposit amount see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Trw Pensions Trust Limited
    Транзакции
    • 01 нояб. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    Rent deposit deed
    Создан 20 окт. 2011 г.
    Поставлен 01 нояб. 2011 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    £18,066.80 due or to become due
    Краткое описание
    The deposit amount see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Trw Pensions Trust Limited
    Транзакции
    • 01 нояб. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    Rent deposit deed
    Создан 23 февр. 2009 г.
    Поставлен 04 мар. 2009 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All monies standing to the credit of the deposit account see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Brixton (Unit 6 Horton Road Poyle) Limited
    Транзакции
    • 04 мар. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    Rent deposit deed
    Создан 24 апр. 2008 г.
    Поставлен 10 мая 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    £43,505.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    £43,505.00 or the amount of the credit in the account from time to time.
    Уполномоченные лица
    • Microsoft Limited
    Транзакции
    • 10 мая 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 22 мар. 2019 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Debenture
    Создан 21 апр. 2008 г.
    Поставлен 02 мая 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Duke Street Capital General Partner Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Транзакции
    • 02 мая 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 15 июн. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Rent deposit deed
    Создан 01 мар. 2007 г.
    Поставлен 10 мар. 2007 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Premium of £56,000 plus vat deposited by the company with the chargee and all other sums from time to time.
    Уполномоченные лица
    • Trw Pensions Trust Limited
    Транзакции
    • 10 мар. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture accession deed
    Создан 04 апр. 2006 г.
    Поставлен 13 апр. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each member of the group to the security agent and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Parties)
    Транзакции
    • 13 апр. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 15 июн. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 8 may 2006 and
    Создан 02 апр. 2006 г.
    Поставлен 27 мая 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the security agent and/or the other security parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Rowallan business park, southcraig avenue, kilmarnock t/no. AYR3588.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Security Parties)
    Транзакции
    • 27 мая 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 15 июн. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Share pledge
    Создан 02 апр. 2006 г.
    Поставлен 20 апр. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Any additional shares and related rights, additional shares means any shares in the company including any such shares comprised in related rights meaning all dividends, interest. The comapany and the existing shares being food partners kilmarnock limited reg no:SC140577, ordinary shares of £1. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland 'Security Agent'
    Транзакции
    • 20 апр. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 15 июн. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 26TH september 2005 and
    Создан 31 мая 2005 г.
    Поставлен 07 окт. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    The property k/a rowallan business park, kilmarnock.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 07 окт. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 апр. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Rent deposit deed
    Создан 07 авг. 2003 г.
    Поставлен 13 авг. 2003 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The sum of £62,500 or such greater sum as is equal to one half of the current annual rental as defined in the lease.
    Уполномоченные лица
    • Cockspur Property (General Partner) Limited and Cockspur Property (Nominee No.1) Limited
    Транзакции
    • 13 авг. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    Composite corporate guarantee
    Создан 31 окт. 2001 г.
    Поставлен 17 нояб. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    To exercise a right of set-off or retention in respect of all money at any time standing to the credit of the guarantor's accounts whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 17 нояб. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 апр. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 31 окт. 2001 г.
    Поставлен 14 нояб. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 14 нояб. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 26 апр. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 09 окт. 2000 г.
    Поставлен 19 окт. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 19 окт. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 нояб. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0