SURCULUS PROPERTIES LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Годовая отчетность
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииSURCULUS PROPERTIES LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03861573
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель SURCULUS PROPERTIES LIMITED?

    • Прочая аренда и эксплуатация собственной или арендованной недвижимости (68209) / Операции с недвижимым имуществом

    Где находится SURCULUS PROPERTIES LIMITED?

    Юридический адрес
    2 Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    Northamptonshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия SURCULUS PROPERTIES LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    EASTDRILL LIMITED19 окт. 1999 г.19 окт. 1999 г.

    Каковы последние отчеты SURCULUS PROPERTIES LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2014 г.

    Каков статус последней годовой декларации для SURCULUS PROPERTIES LIMITED?

    Годовая отчетность
    Последняя годовая отчетность

    Какие последние документы подавались SURCULUS PROPERTIES LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    legacy

    1 страницыSH20

    Отчет о капитале на 18 нояб. 2015 г.

    • Капитал: GBP 100
    4 страницыSH19

    legacy

    1 страницыCAP-SS

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решение о сокращении выпущенного акционерного капитала

    RES06
    capital

    Решения

    Share premium account be cancelled 03/11/2015
    RES13

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital02 нояб. 2015 г.

    Отчет о капитале на 02 нояб. 2015 г.

    • Капитал: GBP 101
    SH01

    Прекращение полномочий Mary Ann Tocio в качестве директора 01 июн. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    6 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital22 окт. 2014 г.

    Отчет о капитале на 22 окт. 2014 г.

    • Капитал: GBP 101
    SH01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    10 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital18 нояб. 2013 г.

    Отчет о капитале на 18 нояб. 2013 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    9 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    Юридический адрес изменен с * 2 Crown Way Rushden Northamptonshire NN10 6BS United Kingdom* 15 авг. 2012 г.

    1 страницыAD01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    11 страницыAA

    Назначение Mr Stephen Kramer на должность секретаря

    1 страницыAP03

    Назначение Stephen Dreier на должность директора

    2 страницыAP01

    Назначение Elizabeth Boland на должность директора

    2 страницыAP01

    Назначение Mary Ann Tocio на должность директора

    2 страницыAP01

    Назначение David Lissy на должность директора

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Matthew Moore в качестве директора

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Anthony Hurran в качестве директора

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Paul Brosnan в качестве директора

    1 страницыTM01

    Кто является должностными лицами SURCULUS PROPERTIES LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    170449870001
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Директор
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanChief Financial Officer70853820001
    DREIER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Директор
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanChief Administrative Officer170443250001
    LISSY, Dave
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Директор
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanManager218331690001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Секретарь
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    BritishCompany Secretary68848420004
    HURRAN, Anthony Robert
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    Секретарь
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    British104970440001
    LAWRENCE, Peter Jessel Levay
    1 Lancaster Place
    Strand
    WC2E 7EB London
    Секретарь
    1 Lancaster Place
    Strand
    WC2E 7EB London
    BritishCompany Director47474380001
    MOORE, Matthew Jon
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    British134350220001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Номинированный секретарь
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BROSNAN, Paul
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Директор
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    United KingdomIrishDirector102089360002
    CARNEY, Joseph Gerard
    Great Portland Street
    W1W 5DD London
    305
    England
    England
    Директор
    Great Portland Street
    W1W 5DD London
    305
    England
    England
    United KingdomIrishDirector89273480001
    HURRAN, Anthony Robert
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Директор
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director184743670001
    MOORE, Matthew Jon
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Директор
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director115340530001
    TOCIO, Mary Ann
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Директор
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    UsaUsaChief Operations Officer177507090001
    WALSH, Stephen Richard
    6 Star & Garter Mansions
    Putney Bridge
    SW15 1JW London
    Директор
    6 Star & Garter Mansions
    Putney Bridge
    SW15 1JW London
    EnglandBritishCompany Director47800650001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Номинированный директор
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Есть ли у SURCULUS PROPERTIES LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Accession deed
    Создан 31 янв. 2006 г.
    Поставлен 08 февр. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All and any monies received by it in breach of the subordination arrangements constituted by the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Thefinance Parties (The Security Trustee)
    Транзакции
    • 08 февр. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 08 июн. 2012 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Legal charge
    Создан 07 янв. 2000 г.
    Поставлен 08 янв. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H 233 new king's road fulham london t/no.LN126289. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 08 янв. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 февр. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 07 янв. 2000 г.
    Поставлен 08 янв. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    F/H 219 new king's road fulham london t/no.LN199429. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 08 янв. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 февр. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 07 янв. 2000 г.
    Поставлен 08 янв. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Site of shortlands united reformed church 84-90 martin's road shortlands t/no.SGL584373. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 08 янв. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 февр. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 07 янв. 2000 г.
    Поставлен 08 янв. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    48 sydenham road croydon CR0 2EF t/nos.SY51018 and SY67921. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 08 янв. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 февр. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 07 янв. 2000 г.
    Поставлен 08 янв. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 08 янв. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 февр. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0