GORDON'S CHEMIST LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииGORDON'S CHEMIST LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 03865851
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель GORDON'S CHEMIST LIMITED?

    • Спящие компании (99999) / Деятельность экстратерриториальных организаций и органов

    Где находится GORDON'S CHEMIST LIMITED?

    Юридический адрес
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия GORDON'S CHEMIST LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    LEADINGTALK LIMITED26 окт. 1999 г.26 окт. 1999 г.

    Каковы последние отчеты GORDON'S CHEMIST LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 авг. 2015 г.

    Какие последние документы подавались GORDON'S CHEMIST LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Добровольное исключение приостановлено

    1 страницыSOAS(A)

    Добровольное исключение приостановлено

    1 страницыSOAS(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Прекращение полномочий Mark Francis Muller в качестве директора 24 июн. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Jonathan Paul Wass на должность директора 24 июн. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    3 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital07 июн. 2016 г.

    Отчет о капитале на 07 июн. 2016 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital28 окт. 2015 г.

    Отчет о капитале на 28 окт. 2015 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Назначение Mr Andrew Richard Thompson на должность секретаря 02 окт. 2015 г.

    2 страницыAP03

    Назначение Mr Andrew Richard Thompson на должность директора 02 окт. 2015 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий David Charles Geoffrey Foster в качестве директора 02 окт. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий David Charles Geoffrey Foster в качестве секретаря 02 окт. 2015 г.

    1 страницыTM02

    Текущий отчетный период продлен

    1 страницыAA01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    3 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital04 нояб. 2014 г.

    Отчет о капитале на 04 нояб. 2014 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    3 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital04 нояб. 2013 г.

    Отчет о капитале на 04 нояб. 2013 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    3 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    3 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01

    Прекращение полномочий Christopher Giles в качестве директора

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Mark Francis Muller на должность директора

    3 страницыAP01

    Кто является должностными лицами GORDON'S CHEMIST LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    THOMPSON, Andrew Richard
    The Heights
    Brooklands
    KT13 0NY Weybridge
    2
    Surrey
    England
    Секретарь
    The Heights
    Brooklands
    KT13 0NY Weybridge
    2
    Surrey
    England
    201554790001
    THOMPSON, Andrew Richard
    The Heights
    Brooklands
    KT13 0NY Weybridge
    2
    Surrey
    England
    Директор
    The Heights
    Brooklands
    KT13 0NY Weybridge
    2
    Surrey
    England
    EnglandBritish156945340001
    WASS, Jonathan Paul
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    England
    Директор
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    England
    EnglandBritish209546930001
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Секретарь
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    British150401600001
    GORDON, Joanne Helen
    19 Creskeld Drive
    LS16 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    Секретарь
    19 Creskeld Drive
    LS16 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    British67149540002
    HOLLIDAY, Alexander
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Секретарь
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    British40938150003
    HOLLIDAY, Anne Elizabeth
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Секретарь
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British40938220004
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    Секретарь
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    British63620010002
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Номинированный секретарь
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    AYLWARD, Christopher David
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    Директор
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    United KingdomBritish59741430002
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Директор
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritish52040210004
    GILES, Christopher James
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Директор
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritish149729660001
    GORDON, Joanne Helen
    19 Creskeld Drive
    LS16 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    Директор
    19 Creskeld Drive
    LS16 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    British67149540002
    GORDON, Richard Michael
    19 Creskeld Drive
    LS19 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    Директор
    19 Creskeld Drive
    LS19 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish67149480002
    HOLLIDAY, Alexander
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Директор
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    British40938150003
    HOLLIDAY, Anne Elizabeth
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Директор
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British40938220004
    KENNERLEY, Patricia Diane
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Директор
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Great BritainBritish110727230002
    MCCLINGTOCK, Jonathan Philip
    10 The Fellside
    NE3 4LJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Директор
    10 The Fellside
    NE3 4LJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British124559980001
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    D90
    Директор
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    D90
    United KingdomBritish63620010002
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    Директор
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    United KingdomBritish63620010002
    PATEL, Anant Vinod
    264 Burley Road
    LS4 2NY Leeds
    West Yorkshire
    Директор
    264 Burley Road
    LS4 2NY Leeds
    West Yorkshire
    British126533340001
    PILSBURY, Roger Graham
    222 Western Way
    NE20 9ND Ponteland
    Northumberland
    Директор
    222 Western Way
    NE20 9ND Ponteland
    Northumberland
    United KingdomBritish181627090001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Номинированный директор
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    Есть ли у GORDON'S CHEMIST LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 22 авг. 2007 г.
    Поставлен 08 сент. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    By way of floating charge the undertaking and all property and assets including l/h properties k/a 7 quarry hill oulton leeds west yorkshire, 49 selby road leeds west yorkshire, rothwell health centre stonebridge lane rothwell leeds west yorkshire and 91 moresdale lane leeds west yorkshire. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Medical Finance (Bristol) Limited
    Транзакции
    • 08 сент. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 сент. 2009 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 22 авг. 2007 г.
    Поставлен 03 сент. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargees on any account whatsoever
    Краткое описание
    Stonebrig lane leeds,91 moorsdale lane leeds,7 quarry hill leeds,49 selby road leeds and all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time on such property and or the proceeds of sale thereof a floating equitable charge on all future f/h and l/h property a fixed charge on the goodwill and uncalled capital all book and other debts floating charge on the undertaking and all property and assets of the company both present and future.
    Уполномоченные лица
    • Aah Pharmaceuticals Limited and Barclay Pharmaceutical Limited
    Транзакции
    • 03 сент. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 сент. 2009 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 19 дек. 2006 г.
    Поставлен 20 дек. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    L/H property k/a 49 selby road leeds. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 20 дек. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 сент. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 31 мая 2002 г.
    Поставлен 06 июн. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    L/Hold property known as 7 quarry hill oulton leeds west yorkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 06 июн. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 сент. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 31 мая 2002 г.
    Поставлен 06 июн. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    L/Hold property forming the pharmacy at rothwell health centre stone brig lane rothwell leeds. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 06 июн. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 сент. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 02 июн. 2000 г.
    Поставлен 08 июн. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 08 июн. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 сент. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 02 июн. 2000 г.
    Поставлен 08 июн. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Leasehold property k/a 91 moredale lane leeds (k/a chemist shop seacroft south one stop centre foundry lane leeds west yorkshire t/n WYK670268. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 08 июн. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 сент. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 02 июн. 2000 г.
    Поставлен 08 июн. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Leasehold property k/a 49 selby road leeds west yorkshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 08 июн. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 13 сент. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 25 апр. 2000 г.
    Поставлен 29 апр. 2000 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 29 апр. 2000 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 янв. 2001 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0