SERVICED OFFICES UK GP LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииSERVICED OFFICES UK GP LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 04063878
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    • Спящие компании (99999) / Деятельность экстратерриториальных организаций и органов

    Где находится SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Юридический адрес
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    CORPORATE CENTRES GP LIMITED15 мар. 2001 г.15 мар. 2001 г.
    STONEMARTIN (GP) LIMITED29 авг. 2000 г.29 авг. 2000 г.

    Каковы последние отчеты SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 июн. 2018 г.

    Какие последние документы подавались SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    8 страницыLIQ13

    Уведомление о подтверждении, составленное 01 окт. 2020 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Юридический адрес изменен с St Helen's 1 Undershaft London EC3P 3DQ United Kingdom на 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS 27 дек. 2019 г.

    1 страницыAD01

    Заявление о платежеспособности

    4 страницыLIQ01

    Назначение ликвидатора

    2 страницы600

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 10 дек. 2019 г.

    LRESSP

    Прекращение полномочий Kirsty Ann-Marie Wilman в качестве директора 02 дек. 2019 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mrs Karina Jane Bye на должность директора 02 дек. 2019 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Nicholas Tebbutt в качестве директора 02 дек. 2019 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr David Rowley Rose на должность директора 02 дек. 2019 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Julian Miles Cobourne в качестве директора 02 дек. 2019 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Jennifer Anne Lisbey в качестве директора 02 дек. 2019 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Ms Jennifer Anne Lisbey на должность директора 15 окт. 2019 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Matthew James Torode в качестве директора 23 авг. 2019 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 01 окт. 2019 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    2 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 18 сент. 2018 г. с изменениями

    6 страницыCS01

    Назначение Mr Matthew Torode на должность директора 13 мар. 2018 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий David Leonard Grose в качестве директора 13 мар. 2018 г.

    1 страницыTM01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    2 страницыAA

    Изменение данных директора для Mr Nicholas Tebbutt 19 мар. 2018 г.

    2 страницыCH01

    Уведомление о подтверждении, составленное 18 сент. 2017 г. с изменениями

    6 страницыCS01

    Назначение Mr. Nicholas Tebbutt на должность директора 28 июл. 2017 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Catherine Jane Mccall в качестве директора 28 июл. 2017 г.

    1 страницыTM01

    Кто является должностными лицами SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Секретарь компании
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Тип идентификацииБританское общество с ограниченной ответственностью
    Регистрационный номер2084205
    1278390004
    BYE, Karina Jane
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Директор
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritish239237640001
    ROSE, David Rowley
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Директор
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritish89567200001
    LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    Секретарь
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    British62939740001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Номинированный секретарь
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ASHCROFT, Jonathan Edwin
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Директор
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritish131434980001
    BURGESS, Quentin James Neilson
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    Директор
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    EnglandBritish42896080002
    BURGESS, Quentin James Neilson
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    Директор
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    EnglandBritish42896080002
    CLARK, Philip John
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    Директор
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    United KingdomBritish101932350001
    COBOURNE, Julian Miles
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Директор
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    EnglandBritish198725060001
    DAWSON, Robert George Maxwell
    Worrin Road
    Shenfield
    CM15 8DH Brentwood
    64
    Essex
    Директор
    Worrin Road
    Shenfield
    CM15 8DH Brentwood
    64
    Essex
    EnglandBritish77316930001
    DRYSDALE, James Ferguson
    Flat 5
    2 Fair Street
    SE1 2XT London
    Директор
    Flat 5
    2 Fair Street
    SE1 2XT London
    British61174240003
    ELLIS, Philip Frederick
    Piglet Manner
    Bramerton Road, Burlingham
    NR14 7DE Norwich
    Norfolk
    Директор
    Piglet Manner
    Bramerton Road, Burlingham
    NR14 7DE Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish75296640001
    GOTTLIEB, Julius
    8 Southway
    Totteridge
    N20 8EA London
    Директор
    8 Southway
    Totteridge
    N20 8EA London
    EnglandBritish32807790002
    GROSE, David Leonard
    c/o Hermes
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    United Kingdom
    Директор
    c/o Hermes
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    United Kingdom
    United KingdomAustralian120479020001
    JONES, Richard Peter
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    Директор
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    EnglandBritish76584200002
    LAXTON, Chris James Wentworth
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Директор
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritish198871760001
    LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    Директор
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish62939740001
    LINDSEY, Joel Mark Woodliffe
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Директор
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomNew Zealand140768720001
    LINEHAM, Timothy Mark Vaughan
    Eastgate House
    Park Lane
    TN15 0JD Sevenoaks
    Kent
    Директор
    Eastgate House
    Park Lane
    TN15 0JD Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish66505360002
    LISBEY, Jennifer Anne
    150 Cheapside
    EC2V 6ET London
    Hermes Investment Management
    United Kingdom
    Директор
    150 Cheapside
    EC2V 6ET London
    Hermes Investment Management
    United Kingdom
    United KingdomBritish259968930001
    MANSLEY, Nicholas John Fermor
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    Директор
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    EnglandBritish73817060002
    MCCALL, Catherine Jane
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Директор
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritish204318160001
    MCKEOWN, Audrey
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Директор
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomIrish124787300002
    SHAH, Nikunj Nalin
    Norval Road
    HA0 3TE Wembley
    16
    Middlesex
    Uk
    Директор
    Norval Road
    HA0 3TE Wembley
    16
    Middlesex
    Uk
    United KingdomBritish131325870001
    TEBBUTT, Nicholas, Mr.
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helens
    United Kingdom
    Директор
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helens
    United Kingdom
    United KingdomBritish228645590002
    THODAY, Corin Leonard
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Директор
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritish138095630001
    TORODE, Matthew James
    Cheapside
    EC2U 6ET London
    150
    United Kingdom
    Директор
    Cheapside
    EC2U 6ET London
    150
    United Kingdom
    United KingdomBritish196412900002
    TURNER, Alex James
    Priory Way
    SG4 9BH Hitchin
    12
    Hertfordshire
    Директор
    Priory Way
    SG4 9BH Hitchin
    12
    Hertfordshire
    United KingdomBritish110252440002
    WILMAN, Kirsty Ann-Marie
    c/o Hermes Fund Managers Limited
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    England
    Директор
    c/o Hermes Fund Managers Limited
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    England
    EnglandBritish155163600002
    WISE, David Andrew John
    20 Parkway
    Southgate
    N14 6QU London
    Директор
    20 Parkway
    Southgate
    N14 6QU London
    United KingdomBritish74016310001
    WOMACK, Ian Bryan
    116 Union Street
    NR1 2TG Norwich
    Директор
    116 Union Street
    NR1 2TG Norwich
    United KingdomBritish33902000002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Номинированный директор
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Norwich Union (Shareholder Gp) Limited
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No. 1
    England
    06 апр. 2016 г.
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No. 1
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаPrivate Company Limited By Shares
    Страна регистрацииEngland
    Юридическое основаниеCompanies Act 2006
    Место регистрацииRegister Of Companies
    Регистрационный номер03783750
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 25%, но не более 50% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 25%, но не более 50% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у SERVICED OFFICES UK GP LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Legal charge
    Создан 08 дек. 2008 г.
    Поставлен 16 дек. 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company as general partner on behalf of the partnership and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    L/H property k/a temple circus temple way bristol t/no. BL97044 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 16 дек. 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 июл. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 21 июл. 2008 г.
    Поставлен 22 июл. 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The property k/a peter house st peter's square manchester t/no GM597635 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 22 июл. 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 июл. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 21 июл. 2008 г.
    Поставлен 22 июл. 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The property k/a 1 victoria square birmingham t/no WM172095 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 22 июл. 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 июл. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 21 июл. 2008 г.
    Поставлен 22 июл. 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The property k/a 45-48 (inclusive) swallow street birmingham T.no WM367351 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • Bank of Sscotland PLC
    Транзакции
    • 22 июл. 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 июл. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 21 июл. 2008 г.
    Поставлен 22 июл. 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The property k/a land on the south side of swallow street birmingham t/no WM368514 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 22 июл. 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 июл. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 21 июл. 2008 г.
    Поставлен 22 июл. 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The propert k/a the golden eagle corner of hill street and swallow street birmingham t/no WM389526.
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 22 июл. 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 июл. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Legal charge
    Создан 11 июн. 2004 г.
    Поставлен 19 июн. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The l/h property known as forbury square reading. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 19 июн. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 июл. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Создан 25 янв. 2002 г.
    Поставлен 29 янв. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    All undertaking property and assets of the partnership whatsoever and wheresoever. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 29 янв. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 05 июл. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)

    Есть ли у SERVICED OFFICES UK GP LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    10 дек. 2019 г.Начало ликвидации
    18 февр. 2021 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Практик
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0