BLSSP (PHC 19) LIMITED
Обзор
Название компании | BLSSP (PHC 19) LIMITED |
---|---|
Статус компании | Ликвидирована |
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Номер компании | 04104021 |
Юрисдикция | Англия/Уэльс |
Дата создания | |
Дата прекращения деятельности |
Резюме
Имеет суперзащищенные PSCs | Нет |
---|---|
Имеет залоги | Да |
Имеет историю несостоятельности | Нет |
Юридический адрес оспаривается | Нет |
Какова цель BLSSP (PHC 19) LIMITED?
- Разработка строительных проектов (41100) / Строительство
Где находится BLSSP (PHC 19) LIMITED?
Юридический адрес | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
---|---|
Юридический адрес недоступен для доставки | Нет |
Каковы последние отчеты BLSSP (PHC 19) LIMITED?
Последние отчеты | |
---|---|
Последние отчеты составлены по состоянию на | 31 мар. 2019 г. |
Какие последние документы подавались BLSSP (PHC 19) LIMITED?
Дата | Описание | Документ | Тип | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации | 1 страницы | GAZ2(A) | ||||||||||
Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации | 1 страницы | GAZ1(A) | ||||||||||
Заявление о снятии компании с учета | 3 страницы | DS01 | ||||||||||
Решения Resolutions | 2 страницы | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Уведомление о подтверждении, составленное 03 нояб. 2019 г. без изменений | 3 страницы | CS01 | ||||||||||
Прекращение полномочий James Watson в качестве директора 23 окт. 2019 г. | 1 страницы | TM01 | ||||||||||
Прекращение полномочий Hursh Shah в качестве директора 23 окт. 2019 г. | 1 страницы | TM01 | ||||||||||
Прекращение полномочий Bruce Richardson в качестве директора 23 окт. 2019 г. | 1 страницы | TM01 | ||||||||||
Прекращение полномочий James Andrew Honeyman в качестве директора 23 окт. 2019 г. | 1 страницы | TM01 | ||||||||||
Прекращение полномочий Dean Clegg в качестве директора 23 окт. 2019 г. | 1 страницы | TM01 | ||||||||||
Прекращение полномочий Martyn Stephen Burke в качестве директора 23 окт. 2019 г. | 1 страницы | TM01 | ||||||||||
Годовая бухгалтерская отчетность | 18 страницы | AA | ||||||||||
Прекращение полномочий David Clifford Wheeler в качестве директора 14 июн. 2019 г. | 1 страницы | TM01 | ||||||||||
Назначение Mr Bruce Richardson на должность директора 14 июн. 2019 г. | 2 страницы | AP01 | ||||||||||
Отчет о капитале на 20 июн. 2019 г.
| 5 страницы | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 страницы | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 страницы | CAP-SS | ||||||||||
Решения Resolutions | 2 страницы | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Полное погашение обременения 2 | 4 страницы | MR04 | ||||||||||
Полное погашение обременения 3 | 4 страницы | MR04 | ||||||||||
Полное погашение обременения 4 | 4 страницы | MR04 | ||||||||||
Прекращение полномочий Sarah Nelson в качестве директора 14 янв. 2019 г. | 1 страницы | TM01 | ||||||||||
Назначение Mr David Clifford Wheeler на должность директора 14 янв. 2019 г. | 2 страницы | AP01 | ||||||||||
Все имущество или предприятие освобождены от обременения 2 | 5 страницы | MR05 | ||||||||||
Все имущество или предприятие освобождены от обременения 4 | 5 страницы | MR05 | ||||||||||
Кто является должностными лицами BLSSP (PHC 19) LIMITED?
Имя | Назнач ен | Ушел в отставку | Роль | Адрес | Идентификация компании | Страна проживания | Гражданство | Дата рождения | Профессия | Номер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Секретарь компании | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
COWEN, Geraint Jamie | Директор | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | Company Director | 141040000003 | ||||||||
PINKSTONE, James Michael | Директор | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | Corporate Finance Executive | 241498640001 | ||||||||
BRAINE, Anthony | Секретарь | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | British | 32809000002 | ||||||||||
EKPO, Ndiana | Секретарь | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
SCUDAMORE, Rebecca Jane | Секретарь | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Номинированный секретарь | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
ADAM, Shenol | Директор | 13 Beech Drive N2 9NX London | British | Company Director | 2068480001 | |||||||||
ATKINSON, William Stephen | Директор | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Investment Surveyor | 174566650001 | ||||||||
BAGULEY, Peter Jeffrey | Директор | Westridge Farm Daggerridge Plain Cadeleigh EX16 8HU Tiverton Devon | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 175617500001 | ||||||||
BELL, Lucinda Margaret | Директор | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | Chartered Accountant | 32809050004 | ||||||||
BELL-BROWN, Philip | Директор | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | Company Director | 119073370001 | ||||||||
BIRCH, John Matthew | Директор | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 191027500001 | ||||||||
BOWDEN, Robert Edward | Директор | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 152497530001 | ||||||||
BRAINE, Anthony | Директор | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 32809000002 | ||||||||
BURKE, Martyn Stephen | Директор | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 152531940004 | ||||||||
CARTER, Simon Geoffrey | Директор | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Treasury Executive | 170891060001 | ||||||||
CLARKE, Peter Courtenay | Директор | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 78691990003 | ||||||||
CLEGG, Dean | Директор | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | Company Director | 189632520001 | ||||||||
COHEN, Carolina Alfred | Директор | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | Investment Executive | 248093020001 | ||||||||
FLEMING, Richard Alexander | Директор | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 125990210002 | ||||||||
FORSHAW, Christopher Michael John | Директор | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | Company Director | 1898090001 | ||||||||
FRANCIS, Luke Thomas | Директор | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Accountant | 223122340001 | ||||||||
GROSE, Benjamin Toby | Директор | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 146546000001 | ||||||||
HESTER, Stephen Alan Michael | Директор | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | Chief Executive | 51688320001 | |||||||||
HONEYMAN, James Andrew | Директор | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 201179510001 | ||||||||
JONES, Andrew Marc | Директор | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | Company Director | 82020730004 | ||||||||
LEARMONT, Richard John | Директор | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 116126860008 | ||||||||
LEARMONT, Richard John | Директор | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 116126860008 | ||||||||
LEWIS, Bryan John | Директор | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 58257940003 | ||||||||
MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Директор | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 58478890003 | ||||||||
MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Директор | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 58478890003 | ||||||||
METLISS, Cyril | Директор | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | Chartered Accountant | 3079600001 | |||||||||
MOORE, Stephen Howard | Директор | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | Corporate Finance Executive | 185276290002 | ||||||||
NELSON, Sarah | Директор | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 220620220001 |
Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над BLSSP (PHC 19) LIMITED?
Имя | Уведомлен | Адрес | Прекращено | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blssp Property Holdings Limited | 06 апр. 2016 г. | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Нет | ||||
| |||||||
Характер контроля
|
Есть ли у BLSSP (PHC 19) LIMITED какие-либо обременения?
Классификация | Даты | Статус | Подробности | |
---|---|---|---|---|
Supplemental deed | Создан 05 апр. 2013 г. Поставлен 23 апр. 2013 г. | Полностью погашен | Обеспеченная сумма All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Краткое описание F/H land and buildings to the east side of brooks road cambridge (coldhams lane) t/no CB117002 fixed charge all rental income any guarantee of rental income,its rights under any security or deposit agreement or arrangement see image for full details. | ||||
Уполномоченные лица
| ||||
Транзакции
| ||||
Borrower deed of charge | Создан 28 февр. 2006 г. Приобретен 05 апр. 2013 г. Поставлен 23 апр. 2013 г. | Полностью погашен | Обеспеченная сумма All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever | |
Краткое описание The existing nominee property assets see image for full details. | ||||
Уполномоченные лица
| ||||
Транзакции
| ||||
Borrower deed of charge | Создан 28 февр. 2006 г. Поставлен 09 мар. 2006 г. | Полностью погашен | Обеспеченная сумма All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Краткое описание Please refer to form 395 for details of property charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Уполномоченные лица
| ||||
Транзакции
| ||||
Deed of charge between amongst others blssp (funding) PLC (the "borrower"), the original charging companies and capita irg trustees limited (the "secured note registrar") | Создан 20 июн. 2001 г. Поставлен 06 июл. 2001 г. | Полностью погашен | Обеспеченная сумма All present and future obligations and liabilities of the borrower to the borrower secured parties under: (1) the secured note trust deed; (2) any property advisory agreement; (3) the property management agreement; (4) the borrower bank agreement; (5) the borrower cash management agreement; (6) the secured note registrar agreement; and (7) clause 5(e) of the note subscription agreement. All preset and futurre obligations and liabilities of the charging companies to the borrower under clause 2.2 of the borrower deed of charge (all terms as defined) | |
Краткое описание Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Уполномоченные лица
| ||||
Транзакции
|
Источник данных
- Companies House Великобритании
Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность. - Лицензия: CC0