GRS PUBS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииGRS PUBS LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 04111631
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель GRS PUBS LIMITED?

    • Разработка строительных проектов (41100) / Строительство
    • Управление недвижимостью на договорной или комиссионной основе (68320) / Операции с недвижимым имуществом

    Где находится GRS PUBS LIMITED?

    Юридический адрес
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия GRS PUBS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    BANKSIDE PUBS LIMITED11 мая 2007 г.11 мая 2007 г.
    BANKSIDE DEVELOPMENTS LIMITED03 мая 2001 г.03 мая 2001 г.
    TATE TOWER LIMITED21 нояб. 2000 г.21 нояб. 2000 г.

    Каковы последние отчеты GRS PUBS LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на28 дек. 2014 г.

    Какие последние документы подавались GRS PUBS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации кредиторов

    18 страницыLIQ14

    Прекращение полномочий Samual Edward Kennedy в качестве директора 08 апр. 2018 г.

    2 страницыTM01

    Прекращение полномочий директора

    2 страницыTM01

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 10 авг. 2017 г.

    32 страницыLIQ03

    Отчет о состоянии дел с приложенной формой 4.19

    5 страницы4.20

    Юридический адрес изменен с 31 Haverscroft Industrial Estate New Road Attleborough Norfolk NR17 1YE на Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL 14 сент. 2016 г.

    2 страницыAD01

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное внеочередное решение о ликвидации с даты начала дела 11 авг. 2016 г.

    LRESEX

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    14 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital13 янв. 2016 г.

    Отчет о капитале на 13 янв. 2016 г.

    • Капитал: GBP 8,405,766
    SH01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    19 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    14 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital03 янв. 2015 г.

    Отчет о капитале на 03 янв. 2015 г.

    • Капитал: GBP 13,889,684
    SH01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    19 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    14 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital03 дек. 2013 г.

    Отчет о капитале на 03 дек. 2013 г.

    • Капитал: GBP 13,889,684
    SH01

    Бухгалтерская отчетность

    16 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    14 страницыAR01

    Бухгалтерская отчетность

    16 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    14 страницыAR01

    Бухгалтерская отчетность

    16 страницыAA

    Годовой отчет

    14 страницыAR01

    Бухгалтерская отчетность

    16 страницыAA

    Прекращение полномочий Alastair Ferguson в качестве секретаря

    2 страницыTM02

    Прекращение полномочий Ian Robinson в качестве директора

    2 страницыTM01

    Прекращение полномочий William Buchanan в качестве директора

    2 страницыTM01

    Прекращение полномочий Russell Cawtheray в качестве директора

    2 страницыTM01

    Кто является должностными лицами GRS PUBS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    THOMSON, Robert Keith Finlay
    Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Hill Copse 92
    Директор
    Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Hill Copse 92
    United KingdomBritish51167890002
    CULVER, Justin Mark
    143 Andrewes House
    Barbican
    EC2Y 8BA London
    Секретарь
    143 Andrewes House
    Barbican
    EC2Y 8BA London
    British83567650001
    DODWELL, John Christopher
    Aria House
    23 Craven Street
    WC2N 5NT London
    Секретарь
    Aria House
    23 Craven Street
    WC2N 5NT London
    British95741610001
    FERGUSON, Alastair William
    Haverscroft Industrial Estate
    New Road
    NR17 1YE Attleborough
    31
    Norfolk
    Секретарь
    Haverscroft Industrial Estate
    New Road
    NR17 1YE Attleborough
    31
    Norfolk
    British146760260001
    LELLO, Graham
    91a Haverhill Road
    Balham
    SW12 0HE London
    Секретарь
    91a Haverhill Road
    Balham
    SW12 0HE London
    South African97505870001
    MCGOURTY, Paula Kim
    68 Standen Road
    Southfields
    SW18 5TG London
    Секретарь
    68 Standen Road
    Southfields
    SW18 5TG London
    British73364230001
    THORNTON, Howard
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    Секретарь
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    British149837760001
    GD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Goodman Derrick
    6th Floor 90 Fetter Lane
    EC4A 1PT London
    Секретарь компании
    Goodman Derrick
    6th Floor 90 Fetter Lane
    EC4A 1PT London
    66216820001
    BUCHANAN, Jonathan Angus
    Unstead Manor
    Trunley Heath Road Bramley
    GU5 0BW Guildford
    Surrey
    Директор
    Unstead Manor
    Trunley Heath Road Bramley
    GU5 0BW Guildford
    Surrey
    EnglandBritish121511400002
    BUCHANAN, William Arthur Neil
    3 Westerton Court
    Clarkston
    G76 8NG Glasgow
    Lanarkshire
    Директор
    3 Westerton Court
    Clarkston
    G76 8NG Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish67066450003
    CAWTHERAY, Russell
    8 Shears Crescent
    CO5 8AR West Mersea
    Essex
    Директор
    8 Shears Crescent
    CO5 8AR West Mersea
    Essex
    British124176180001
    CROWTHER, Mark
    Randwick House
    5 Bridge Street
    NN14 3ET Brigstock
    Northamptonshire
    Директор
    Randwick House
    5 Bridge Street
    NN14 3ET Brigstock
    Northamptonshire
    British104967480001
    DODWELL, John Christopher
    Aria House
    23 Craven Street
    WC2N 5NT London
    Директор
    Aria House
    23 Craven Street
    WC2N 5NT London
    British95741610001
    GRAY, Peter Francis
    1 Bradbourne Street
    SW6 3TF London
    Директор
    1 Bradbourne Street
    SW6 3TF London
    United KingdomBritish4637200001
    GUNDRY, Richard
    Holgate Farm 29 The Street
    Bunwell
    NR16 1NA Norwich
    Norfolk
    Директор
    Holgate Farm 29 The Street
    Bunwell
    NR16 1NA Norwich
    Norfolk
    British107010490001
    KENNEDY, Samual Edward
    Haverscroft Industrial Estate
    New Road
    NR17 1YE Attleborough
    31
    Norfolk
    Директор
    Haverscroft Industrial Estate
    New Road
    NR17 1YE Attleborough
    31
    Norfolk
    EnglandBritish149343140001
    LELLO, Graham
    91a Haverhill Road
    Balham
    SW12 0HE London
    Директор
    91a Haverhill Road
    Balham
    SW12 0HE London
    South African97505870001
    ROBINSON, Ian George
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    Директор
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritish57975730001
    SHARP, Kevan
    5 Mizen Close
    KT11 2RJ Cobham
    Surrey
    Директор
    5 Mizen Close
    KT11 2RJ Cobham
    Surrey
    British82257500001
    THORNTON, Howard
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    Директор
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish149837760001
    WANFORD, Matthew
    Flat 1 Bridgport Place
    SE17 1HB Wapping
    Директор
    Flat 1 Bridgport Place
    SE17 1HB Wapping
    British88305120002
    WILSON, Andrew Stephen
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Директор
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    United KingdomBritish82667700001

    Есть ли у GRS PUBS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Deed of charge over shares
    Создан 13 апр. 2007 г.
    Поставлен 30 апр. 2007 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    First fixed legal charge all of its present and future rights,title and interest in and to the scheduled securities. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Security Agent")
    Транзакции
    • 30 апр. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    Supplemental legal charge
    Создан 13 апр. 2007 г.
    Поставлен 30 апр. 2007 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    F/H bull berkhamstead herts t/no HD329381,f/h cheshire cheese warrington cheshire t/no CH443388,f/h dock south shields t/no TY350973 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Securtiy Agent")
    Транзакции
    • 30 апр. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    Supplemental legal charge
    Создан 21 дек. 2006 г.
    Поставлен 28 дек. 2006 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    F/H abinger arms guildford road abinger hammer dorking surrey t/no sy 648908,f/h alexandra 170 prsecott road fairfield liverpool t/no MS349200,f/h anchor london road bourne end hemel hempstead herts t/no HD329370 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Security Agrent")
    Транзакции
    • 28 дек. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 30 нояб. 2006 г.
    Поставлен 06 дек. 2006 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Anchor inn fore street chudleigh knighton f/h t/n DN318739 bell inn 180 drew street brixham f/h t/n DN313236 cheddar valley inn tusker street wells f/h t/n ST89453. For further details of property charged please refer to form 395. the security assets. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Security Agent")
    Транзакции
    • 06 дек. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    Debenture
    Создан 31 мая 2006 г.
    Поставлен 13 июн. 2006 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    F/H property k/a anchor inn fore street chudleigh knighton t/no DN318739, f/h property k/a bell inn 108 drew street brixham t/no DN313236, f/h property k/a cheddar valley inn tucker street wells t/no ST89453 for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Транзакции
    • 13 июн. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    A security agreement
    Создан 09 апр. 2003 г.
    Поставлен 19 апр. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All estates or interest in any f/h or l/h property now owned by it, all buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery on that property, and the benefit of any covenants for title given or entered into by any predecessor in title of the chargor in respect of that property. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • London Town PLC
    Транзакции
    • 19 апр. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 мая 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal mortgage
    Создан 25 июн. 2001 г.
    Поставлен 30 июн. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The freehold property known as 44 holland street & 47 hopton street london t/no: SGL340846. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 30 июн. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 мая 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 29 мая 2001 г.
    Поставлен 02 июн. 2001 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 02 июн. 2001 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 мая 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у GRS PUBS LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    19 сент. 2018 г.Дата ликвидации
    11 авг. 2016 г.Начало ликвидации
    Добровольная ликвидация по требованию кредиторов
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Lyn L Vardy
    Central Square 8th Floor, 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Практик
    Central Square 8th Floor, 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    David Christian Chubb
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Практик
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0