ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Годовая отчетность
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 04204306
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?

    • Деятельность головных офисов (70100) / Деятельность профессиональная, научная и техническая

    Где находится ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?

    Юридический адрес
    Royal Pavilion
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Hampshire
    United Kingdom
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    TOREX EUROPE (HOLDINGS) LIMITED16 мая 2001 г.16 мая 2001 г.
    SPEED 8732 LIMITED24 апр. 2001 г.24 апр. 2001 г.

    Каковы последние отчеты ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 мар. 2012 г.

    Каков статус последней годовой декларации для ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?

    Годовая отчетность
    Последняя годовая отчетность

    Какие последние документы подавались ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Предыдущий отчетный период продлен

    3 страницыAA01

    Прекращение полномочий Andrew Thomson в качестве директора

    2 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital08 мая 2013 г.

    Отчет о капитале на 08 мая 2013 г.

    • Капитал: GBP 2
    SH01

    Регистры перемещены по юридическому адресу

    1 страницыAD04

    Назначение David William Hart Gray на должность секретаря

    3 страницыAP03

    Прекращение полномочий Gareth Wilson в качестве секретаря

    2 страницыTM02

    Бухгалтерская отчетность

    14 страницыAA

    Решения

    Resolutions
    34 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об Уставе

    RES01

    Прекращение полномочий Adrian Stevens в качестве директора

    2 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01

    Бухгалтерская отчетность

    15 страницыAA

    Текущий отчетный период сокращен

    1 страницыAA01

    Изменение данных директора для Mr Andrea Fiumicelli 12 сент. 2011 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Mr Andrew James Edward Thomson 12 сент. 2011 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Mr Adrian Charles Stevens 12 сент. 2011 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных секретаря для Mr Gareth Antony Wilson 12 сент. 2011 г.

    2 страницыCH03

    Юридический адрес изменен с * C/O Csc Computer Sciences International Ltd Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom* 18 авг. 2011 г.

    1 страницыAD01

    Юридический адрес изменен с * C/O Isoft Group Plc Daventry Road Banbury Oxfordshire OX16 3JT* 05 авг. 2011 г.

    1 страницыAD01

    legacy

    3 страницыMG02

    legacy

    3 страницыMG02

    legacy

    3 страницыMG02

    Назначение Mr Andrew James Edward Thomson на должность директора

    2 страницыAP01

    Кто является должностными лицами ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    GRAY, David William Hart
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    British177357700001
    FIUMICELLI, Andrea
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Директор
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    ItalyItalianCompany Director135619020001
    EDELMAN, Howard Todd
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    Секретарь
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    AustralianCompany Secretary126124430005
    HILL, Teifion Mark
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    Секретарь
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    British100105520001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Секретарь
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    WILSON, Gareth Antony
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    162047940001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Номинированный секретарь
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    COHEN, Gary Michael
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    Директор
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    AustraliaAustralianCompany Director125992970001
    GRAHAM, Stephen Paul
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    Директор
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector97528710001
    HENRY, William Patrick
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    Директор
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandAmericanCompany Director119049370001
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    Директор
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director44173560008
    KUMAR, Ravi
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    Директор
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    BritishDirector101025710001
    MACKAY, James Gordon
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director178097680001
    PEARMAN, Mark Chalice
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    Директор
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector57516220003
    RICHARDS, Paul
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    Директор
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    United KingdomBritishCompany Director126777780001
    STEVENS, Adrian Charles
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Директор
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director76964750002
    THOMSON, Andrew James Edward
    Wellesley Road
    GU11 1 PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Директор
    Wellesley Road
    GU11 1 PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant147270780001
    WHELAN, John
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    Директор
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    UkBritishDirector105872500001
    WHISTON, Timothy Andrew
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    Директор
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    EnglandBritishDirector69575560002
    WOODBRIDGE, Mark Gavin
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    Директор
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    BritishFinance Director74738270002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Номинированный директор
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Есть ли у ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Second ranking share pledge
    Создан 03 дек. 2010 г.
    Поставлен 14 дек. 2010 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All shares and share rights, the first ranking deed. Future assets of the second ranking share charge see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 14 дек. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 01 авг. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Deed of pledge of shares
    Создан 30 дек. 2009 г.
    Поставлен 15 янв. 2010 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All rights means all rights dividends interest money or property bonus see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Транзакции
    • 15 янв. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 01 авг. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Security agreement
    Создан 30 дек. 2009 г.
    Поставлен 13 янв. 2010 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Транзакции
    • 13 янв. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 01 авг. 2011 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    A third ranking deed of pledge of shares
    Создан 29 окт. 2008 г.
    Поставлен 13 нояб. 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee in its capacity as creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All shares and share rights see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Abn Amro Bank N.V. (The Security Agent)
    Транзакции
    • 13 нояб. 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 янв. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Second ranking deed of pledge of shares
    Создан 29 июл. 2008 г.
    Поставлен 15 авг. 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All its shares and share rights see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Abn Amro Bank N.V. (The Security Agent)
    Транзакции
    • 15 авг. 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 янв. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Deed of pledge
    Создан 27 нояб. 2007 г.
    Поставлен 17 дек. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Shares and share rights including any dividend, interest. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Abn Amro Bank N.V. London Branch (The Security Agent)
    Транзакции
    • 17 дек. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 янв. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    A deed of accession
    Создан 27 нояб. 2007 г.
    Поставлен 13 дек. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch, as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Securityagent)
    Транзакции
    • 13 дек. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 18 янв. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Создан 24 авг. 2006 г.
    Поставлен 31 авг. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 31 авг. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 16 февр. 2010 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (MG02)
    Supplemental guarantee and debenture
    Создан 25 июн. 2004 г.
    Поставлен 01 июл. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the parent company, any chargor or any other of the parent company's subsidiaries (together the group) to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    F/H property known as unit 2 firecrest court warrington t/no CH445922, l/h property known as upminster unit 16 essex, l/h property known as sarum gate basingstoke t/no HP208786. For details of further properties charged please refer to form 395. by way of fixed charge the rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, rights as tenant, book debts and other debts. Floating charge all undertaking and all other property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Agent and Security Trustee)
    Транзакции
    • 01 июл. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 дек. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A legal charge containing fixed and floating charges
    Создан 21 июл. 2003 г.
    Поставлен 06 авг. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of legal mortgage the f/h property known as churchfields, stonesfield, witney OX8 8PQ t/no ON214941 and all that f/h property known as unit 2 (postal number 310) firecrest court, centre park, warrington, cheshire, t/no CH445922. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Securedparties (The Security Trustee)
    Транзакции
    • 06 авг. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 авг. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0