ELMSWAY (NO. 1) LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииELMSWAY (NO. 1) LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 04359815
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?

    • (7012) /
    • (7020) /
    • (7032) /

    Где находится ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?

    Юридический адрес
    c/o CHANTREY VELLACOTT DFK LLP
    Russell Square House 10-12 Russell Square
    WC1B 5LF London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    BRITANNIC BUSINESS PARKS LIMITED10 сент. 2002 г.10 сент. 2002 г.
    SOUTHTOUR LIMITED24 янв. 2002 г.24 янв. 2002 г.

    Каковы последние отчеты ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 янв. 2009 г.

    Какие последние документы подавались ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации кредиторов

    23 страницы4.72

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 08 мая 2012 г.

    18 страницы4.68

    Юридический адрес изменен с C/O Elmsway (No1) Limited Hercules Business Park Lostock Lane Lostock Bolton BL6 4BR England 02 июн. 2011 г.

    2 страницыAD01

    Отчет о состоянии дел с приложенной формой 4.19

    5 страницы4.20

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное внеочередное решение о ликвидации с даты начала дела 09 мая 2011 г.

    LRESEX

    Юридический адрес изменен с Canal Mill Botany Bay Villages Botany Brow Chorley Lancashire PR6 9AF 22 февр. 2011 г.

    1 страницыAD01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital26 янв. 2011 г.

    Отчет о капитале на 26 янв. 2011 г.

    • Капитал: GBP 1
    SH01

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    change-of-name

    Решение об изменении наименования

    RES15

    Уведомление об изменении наименования"

    2 страницыCONNOT

    Предыдущий отчетный период сокращен

    1 страницыAA01

    Прекращение полномочий Timothy Knowles в качестве директора

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Gerald Wood в качестве директора

    2 страницыTM01

    legacy

    4 страницыLQ01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    6 страницыAR01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    16 страницыAA

    legacy

    3 страницы288a

    legacy

    4 страницы363a

    Годовая бухгалтерская отчетность

    16 страницыAA

    Отставка аудитора

    2 страницыAUD

    Отставка аудитора

    1 страницыAUD

    legacy

    1 страницы288a

    legacy

    1 страницы288a

    legacy

    1 страницы288b

    Кто является должностными лицами ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    SHARP, Claire Caroline
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    Секретарь
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    BritishProperty Director141979130001
    DIXON, William Ronald
    Cumberland Drive
    WA14 3QP Bowdon
    27
    Cheshire
    Директор
    Cumberland Drive
    WA14 3QP Bowdon
    27
    Cheshire
    EnglandBritishFinance Director136501510001
    HOPKINSON, Thomas Duncan
    Bank House
    Sawley Road Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    Директор
    Bank House
    Sawley Road Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritishChartered Accountant71862660002
    SHARP, Claire Caroline
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    Директор
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    EnglandBritishProperty Management141979130001
    ALLEN, Rachel Mary
    1263 Burnley Road
    Loveclough
    BB4 8RG Rossendale
    Lancashire
    Секретарь
    1263 Burnley Road
    Loveclough
    BB4 8RG Rossendale
    Lancashire
    British98369110001
    JENKINSON, Jayne Elizabeth
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Секретарь
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    British85366800001
    SHARP, Claire Caroline
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    Секретарь
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    British141979130001
    WESTHEAD, Paul
    11 Delph Way
    Whittle Le Woods
    PR6 7TG Chorley
    Lancashire
    Секретарь
    11 Delph Way
    Whittle Le Woods
    PR6 7TG Chorley
    Lancashire
    BritishDirector72955010002
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    Номинированный секретарь
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    900018560001
    JENKINSON, Jayne Elizabeth
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Директор
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    EnglandBritishFinancial Controller85366800001
    KNOWLES, Timothy John Peter
    Clogh Willey Cottage
    Tosaby Road Stoney Mountain
    IM9 3AN St Marks
    Isle Of Man
    Директор
    Clogh Willey Cottage
    Tosaby Road Stoney Mountain
    IM9 3AN St Marks
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishDirector33274370003
    WESTHEAD, Paul
    11 Delph Way
    Whittle Le Woods
    PR6 7TG Chorley
    Lancashire
    Директор
    11 Delph Way
    Whittle Le Woods
    PR6 7TG Chorley
    Lancashire
    BritishDirector72955010002
    WOOD, Gerald Jospeh
    1 Stanley Road
    Farington
    PR25 4RH Leyland
    Lancashire
    Директор
    1 Stanley Road
    Farington
    PR25 4RH Leyland
    Lancashire
    EnglandBritishDirector110948700001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    Номинированный директор
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    900018550001

    Есть ли у ELMSWAY (NO. 1) LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Security deed
    Создан 12 сент. 2006 г.
    Поставлен 25 сент. 2006 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each borrower to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Credit Suisse, as Security Agent for the Finance Parties
    Транзакции
    • 25 сент. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 128 апр. 2010 г.Назначение приемщика или управляющего (LQ01)
      • Дело № 1
    Legal charge
    Создан 09 мая 2003 г.
    Поставлен 17 мая 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Brownlow business park tennyson street bolton. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 17 мая 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 15 сент. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 09 мая 2003 г.
    Поставлен 17 мая 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Florence business park whalley new road blackburn. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 17 мая 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 15 сент. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 09 мая 2003 г.
    Поставлен 17 мая 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Waverledge business park waverledge street great harwood blackburn. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 17 мая 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 15 сент. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 20 дек. 2002 г.
    Поставлен 30 дек. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 30 дек. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 15 сент. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Second legal charge
    Создан 09 июл. 2002 г.
    Поставлен 25 июл. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    The sum of £25,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Bronlow business park tennyson street bolton title number GM502273 waverledge mill waverledge street hyndburn title number LA36928 florence business park whaley new road blackburn title number LA386971 LA351831 LA351830 LA565627 LA374844 LA328794 together with all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery of the company from time to time thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Southern Funding Limited
    Транзакции
    • 25 июл. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 22 мая 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Legal charge
    Создан 09 июл. 2002 г.
    Поставлен 25 июл. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Bronlow business park tennyson street bolton title number GM502273 waverledge mill waverledge street hyndburn title number LA36928 florence business park whaley new road blackburn title numbers LA386971 LA351831 LA351830 LA565627 LA374844 LA328794 together with all buildings trade and other fixtures fixed plant fixed plant and machinery of the company from time to time thereon.. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Property Finance Nominees (No 4) Limited
    Транзакции
    • 25 июл. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 22 мая 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 09 июл. 2002 г.
    Поставлен 25 июл. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Brownlow business park tennyson street bolton title number 502273, waverledge mill waverledge street hyndburn title number LA36928 florence business park whaley new road blackburn title numbers LA386971 LA351831 LA351830 LA565627 LA374844 LA328794. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Property Finance Nominees (No 4) Limited
    Транзакции
    • 25 июл. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 22 мая 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge
    Создан 09 июл. 2002 г.
    Поставлен 23 июл. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    F/Hold property known as waterledge mill,great harwood,hyndburn,lancashire; la 36928;specific charge over all income and rights thereto and the proceeds of sale thereof,lease or other disposition and all deeds and documents thereto; all insurance and compensation monies; floating charge over all undertaking,property,assets and rights whatsoever; see form 395 for details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Уполномоченные лица
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Транзакции
    • 23 июл. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 22 мая 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Floating charge
    Создан 08 июл. 2002 г.
    Поставлен 23 июл. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    First floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Уполномоченные лица
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Транзакции
    • 23 июл. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 22 мая 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у ELMSWAY (NO. 1) LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1Назначен ресивер/менеджер
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Richard Murphy
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Административный ресивер
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Bryn Williams
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Административный ресивер
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    2
    ДатаТип
    09 мая 2011 г.Начало ликвидации
    16 окт. 2013 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по требованию кредиторов
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Kevin Anthony Murphy
    Chantrey Vellacott Dfk
    Russell Square House
    WC1B 5LF 10-12 Russell Square
    London
    Практик
    Chantrey Vellacott Dfk
    Russell Square House
    WC1B 5LF 10-12 Russell Square
    London
    Richard Howard Toone
    Cvr Global Llp
    Russell Square House 10-12 Russell Square
    WC1B 5LB London
    Практик
    Cvr Global Llp
    Russell Square House 10-12 Russell Square
    WC1B 5LB London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0