SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииSOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 04502016
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?

    • Прочая деятельность в области здравоохранения (86900) / Здравоохранение и социальные услуги

    Где находится SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?

    Юридический адрес
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    HIGHFIELD HEALTHCARE CENTRES LIMITED23 окт. 2002 г.23 окт. 2002 г.
    SOUTHWEST LIMITED02 авг. 2002 г.02 авг. 2002 г.

    Каковы последние отчеты SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 сент. 2010 г.

    Какие последние документы подавались SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Прекращение полномочий Francis Declan Finbar Tempany Mccormack в качестве секретаря 09 окт. 2012 г.

    1 страницыTM02

    Уведомление о завершении добровольного соглашения

    6 страницы1.4

    Прекращение полномочий Timothy James Bolot в качестве директора 17 авг. 2012 г.

    1 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital14 авг. 2012 г.

    Отчет о капитале на 14 авг. 2012 г.

    • Капитал: GBP 600,002
    SH01

    Уведомление регистратору компаний о вступлении в силу добровольного соглашения

    4 страницы1.1

    Прекращение полномочий William James Buchan в качестве директора 15 нояб. 2011 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий David Andrew Smith в качестве директора 01 нояб. 2011 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Stephen Jonathan Taylor на должность директора 26 окт. 2011 г.

    2 страницыAP01

    Назначение Mr Timothy James Bolot на должность директора 26 окт. 2011 г.

    2 страницыAP01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    28 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    3 страницыAR01

    Прекращение полномочий William Mcleish в качестве секретаря

    1 страницыTM02

    Назначение Francis Declan Finbar Tempany Mccormack на должность секретаря

    1 страницыAP03

    Прекращение полномочий Richard Midmer в качестве директора

    1 страницыTM01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01

    Решения

    Resolutions
    3 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital

    Решения

    Explanatory statment to sole member 14/05/2010
    RES13

    Годовая бухгалтерская отчетность

    25 страницыAA

    Изменение данных директора для Mr David Andrew Smith 07 янв. 2010 г.

    2 страницыCH01

    Назначение Mr David Andrew Smith на должность директора

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий David Smith в качестве директора

    1 страницыTM01

    Назначение Mr David Andrew Smith на должность директора

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Kamma Foulkes в качестве директора

    1 страницыTM01

    Кто является должностными лицами SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Директор
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    JOYCE, Meriel Lucy Ann
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    Секретарь
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    British16385330010
    KAUL, Sheila
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    Секретарь
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    British70194600001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Секретарь
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158305970001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Секретарь
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    Номинированный секретарь
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001
    ASARIA, Mohamed Saleem
    Fringewood Close
    HA6 2TB Northwood
    8
    Middlesex
    Директор
    Fringewood Close
    HA6 2TB Northwood
    8
    Middlesex
    EnglandBritish13927880001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Директор
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Директор
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Директор
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Директор
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    FARMER, Nicholas John
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Директор
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish124228290001
    FINNIS, Pam
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Директор
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish133719530001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Директор
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GROOMBRIDGE, Kevin John
    51 Old Croft Road
    ST17 0NL Stafford
    Директор
    51 Old Croft Road
    ST17 0NL Stafford
    EnglandBritish105722880001
    JOYCE, Martin Patrick
    La Rue A
    St Peter Port
    GY1 1QG Guernsey
    Директор
    La Rue A
    St Peter Port
    GY1 1QG Guernsey
    United KingdomBritish27130160009
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Директор
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MALHAM, Janette
    The Limekilns
    9a Elm Grove
    TS26 8LZ Hartlepool
    Директор
    The Limekilns
    9a Elm Grove
    TS26 8LZ Hartlepool
    EnglandBritish91088900003
    MCKEEVER, Pauline Ann
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    Директор
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    BritainBritish91521130001
    MCQUAID, Michael James
    Baily Bach
    Cobham Way
    KT24 5BH East Horsley
    Surrey
    Директор
    Baily Bach
    Cobham Way
    KT24 5BH East Horsley
    Surrey
    United KingdomBritish89052830001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Директор
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Директор
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    MURPHY, John
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    Директор
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    British26177180002
    MURRAY, Andrew John
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    Директор
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    British110957990001
    MURRAY, Andrew John
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    Директор
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    British110957990001
    POYNTON, Ellen
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    Директор
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    United KingdomBritish89071020004
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Директор
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Директор
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Директор
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Директор
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Директор
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritish147997950001
    STEIN, Anthony Karl
    9 Birmingham Road
    Coughton
    B49 5HR Alcester
    Директор
    9 Birmingham Road
    Coughton
    B49 5HR Alcester
    United KingdomBritish109518530001
    WILSON, Mark Stephen
    9 Wheatear Lane
    Ingleby Barwick
    TS17 0TB Stockton On Tees
    Директор
    9 Wheatear Lane
    Ingleby Barwick
    TS17 0TB Stockton On Tees
    British90893350001
    STEPHEN MABBOTT LTD.
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Номинированный директор
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    900018650001

    Есть ли у SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Rent deposit deed
    Создан 07 мая 2003 г.
    Поставлен 15 мая 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The deposit; the interest; the deposit account and the deposit balance.
    Уполномоченные лица
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Транзакции
    • 15 мая 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 апр. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 07 мая 2003 г.
    Поставлен 10 мая 2003 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Leasehold premises situate at the limes nursing home main street whaley thorns nether langwith mansfield nottinghamshire NG20 9HU. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Транзакции
    • 10 мая 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 мая 2004 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 10 мая 2004 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    Rent deposit deed
    Создан 29 апр. 2003 г.
    Поставлен 09 мая 2003 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The deposit the interest the deposit account and the deposit balance.
    Уполномоченные лица
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Транзакции
    • 09 мая 2003 г.Регистрация обременения (395)
    Rent deposit deed
    Создан 29 апр. 2003 г.
    Поставлен 08 мая 2003 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The deposit, all interest, the deposit account being an interest bearing account specifically designated "regis house nursing home deposit account" and the deposit balance being the sum of £10,080. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Nhp Securities No. 10 Limited
    Транзакции
    • 08 мая 2003 г.Регистрация обременения (395)
    Mortgage debenture
    Создан 29 апр. 2003 г.
    Поставлен 02 мая 2003 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    L/H premises at beech tree house 120-122 himley road dudley west midlands DY1 2QQ. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Транзакции
    • 02 мая 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 апр. 2004 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    Mortgage debenture
    Создан 29 апр. 2003 г.
    Поставлен 02 мая 2003 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    L/H premises at regis house nursing home 29 causeway blackheath rowley regis warley west midlands B65 8AA. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Транзакции
    • 02 мая 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 апр. 2004 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    Rent deposit deed
    Создан 24 мар. 2003 г.
    Поставлен 03 апр. 2003 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The deposit being the sum of £39,348 all interest the deposit account being an interest bearing account specifically designated "woodcross mental care centre deposit account" and the deposit balance being the sum from time to time standing to the credit of the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Транзакции
    • 03 апр. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    Mortgage debenture
    Создан 24 мар. 2003 г.
    Поставлен 27 мар. 2003 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    L/H premises situate at woodcross mental care centre 23 reeves street bloxwich walsall west midlands WS3 2DG. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Транзакции
    • 27 мар. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 30 апр. 2004 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    Rent deposit deed
    Создан 20 мар. 2003 г.
    Поставлен 03 апр. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Транзакции
    • 03 апр. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 апр. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 20 мар. 2003 г.
    Поставлен 25 мар. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Транзакции
    • 25 мар. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 мая 2004 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 28 апр. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 28 янв. 2003 г.
    Поставлен 05 февр. 2003 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    The l/h property k/a woodcross house nursing home (sedgley) woodcross street, woodcross, wolverhampton, WV14 9RT. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Транзакции
    • 05 февр. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 мая 2004 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    • 10 мая 2004 г.Заявление, что часть или все имущество из плавающего залога освобождено (403b)
    Rent deposit deed
    Создан 28 янв. 2003 г.
    Поставлен 01 февр. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Транзакции
    • 01 февр. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 28 апр. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    20 июн. 2012 г.Дата собрания для утверждения CVA
    20 авг. 2012 г.Дата завершения или прекращения CVA
    Добровольное соглашение с кредиторами (CVA)
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Howard Smith
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Практик
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0