CPH (R&L) NO.1 LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииCPH (R&L) NO.1 LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 04807690
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель CPH (R&L) NO.1 LIMITED?

    • Рестораны с лицензией (56101) / Гостиницы и рестораны
    • Питейные заведения и бары (56302) / Гостиницы и рестораны

    Где находится CPH (R&L) NO.1 LIMITED?

    Юридический адрес
    Resolve Partners Limited 22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия CPH (R&L) NO.1 LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    HOUSEBUTTON LIMITED23 июн. 2003 г.23 июн. 2003 г.

    Каковы последние отчеты CPH (R&L) NO.1 LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на22 авг. 2015 г.

    Какие последние документы подавались CPH (R&L) NO.1 LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    10 страницыLIQ13

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 11 янв. 2018 г.

    9 страницыLIQ03

    Юридический адрес изменен с Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL на Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU 13 сент. 2017 г.

    2 страницыAD01

    Уведомление о подтверждении, составленное 04 июл. 2017 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Юридический адрес изменен с Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom на 48 Warwick Street London W1B 5NL 10 февр. 2017 г.

    2 страницыAD01

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Решения

    Resolutions
    2 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 12 янв. 2017 г.

    LRESSP

    Заявление о платежеспособности

    9 страницы4.70

    Полное погашение обременения 4

    2 страницыMR04

    Полное погашение обременения 5

    2 страницыMR04

    Полное погашение обременения 6

    1 страницыMR04

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    3 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital23 июн. 2016 г.

    Отчет о капитале на 23 июн. 2016 г.

    • Капитал: GBP 100
    SH01

    Отставка аудитора

    1 страницыAUD

    Назначение Lindsay Anne Keswick на должность секретаря 25 апр. 2016 г.

    2 страницыAP03

    Прекращение полномочий Claire Susan Stewart в качестве секретаря 25 апр. 2016 г.

    1 страницыTM02

    Годовая бухгалтерская отчетность

    16 страницыAA

    Юридический адрес изменен с Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ на Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT 07 мар. 2016 г.

    1 страницыAD01

    Прекращение полномочий Jonathan Robert Langford в качестве директора 26 янв. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Daryl Antony Kelly в качестве директора 26 янв. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Lucy Jane Bell в качестве директора 26 янв. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Kirk Dyson Davis на должность директора 21 дек. 2015 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Henry Jones в качестве секретаря 04 дек. 2015 г.

    1 страницыTM02

    Текущий отчетный период сокращен

    1 страницыAA01

    Прекращение полномочий Patrick James Gallagher в качестве директора 23 июн. 2015 г.

    1 страницыTM01

    Кто является должностными лицами CPH (R&L) NO.1 LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    Секретарь
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    207523590001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector158484730001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592040001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Секретарь
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172445160001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Секретарь
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEVENS, Mark
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    Секретарь
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    BritishCompany Secretary80951870001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181022110001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Секретарь
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    BritishCompany Secretary135181230001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Номинированный секретарь
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector164754670001
    CRICHTON, Roger Wells
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    Директор
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director67937290001
    CUMMING, Johanna Louise
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    Директор
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    United KingdomBritishDirector111108910001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141395280001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector170184800001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Директор
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritishCompany Director47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant86246470001
    KNIGHT, Andrew Ronald
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    Директор
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    BritishCompany Director81555100002
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector135408140001
    LESLIE, John Stewart
    Bec House Church End
    HP27 9PD Bledlow
    Buckinghamshire
    Директор
    Bec House Church End
    HP27 9PD Bledlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director59934350001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Директор
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector42019620001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector63043630002
    RIKLIN, Cornel Carl
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    Директор
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    EnglandSwissManaging Director78412270001
    RIPPER, Christopher
    Hillroft House
    Main Street Upper Stowe
    NN7 4SH Northampton
    Northamptonshire
    Директор
    Hillroft House
    Main Street Upper Stowe
    NN7 4SH Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director97847560001
    SMITH, Benedict James
    Flat 9
    62 Eccleston Square
    SW1V 1PH London
    Директор
    Flat 9
    62 Eccleston Square
    SW1V 1PH London
    United KingdomBritishCompany Director75231110001
    STONE, Stephen John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Директор
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131652460001
    SYMONDS, Paul
    Willow House
    10a Vicars Close, Biddenham
    MK40 4BG Bedford
    Bedfordshire
    Директор
    Willow House
    10a Vicars Close, Biddenham
    MK40 4BG Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishCompany Director80167420001
    THORLEY, Giles Alexander
    Charlton Manor
    Ashley Road Charlton Kings
    GL52 6NS Cheltenham
    Gloucestershire
    Директор
    Charlton Manor
    Ashley Road Charlton Kings
    GL52 6NS Cheltenham
    Gloucestershire
    Gb-EngBritishDirector81928120001
    TURPIN, Nigel Richard
    The Granary
    Cross Hill, Brixworth
    NN6 9DB Northampton
    Northamptonshire
    Директор
    The Granary
    Cross Hill, Brixworth
    NN6 9DB Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director63410670001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Директор
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    EnglandBritishCompany Secretary135181230001

    Есть ли у CPH (R&L) NO.1 LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Amendment and restatement deed
    Создан 07 июл. 2006 г.
    Поставлен 21 июл. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each security provider or any other security provider to the chargee or any of the other borrower group secured creditors on any account whatsoever. All monies due or to become due from each security provider and/or any other security provider and/or the punch borrower to the chargee or any of the other junior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Real property scottish property ancillary property rights shares contractual rights insurance intellectual property book debts accounts licences and consents. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Deutsche Truste Company Limited in Its Capacity as the "Issuer Security Trustee" and "Borrowergroup Security Trustee"
    Транзакции
    • 21 июл. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 12 янв. 2017 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Supplemental deed of charge
    Создан 21 мар. 2006 г.
    Поставлен 31 мар. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any other security provider and/or the punch borrower or any of the other junior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    F/H abbey 944 chesterfield road sheffield t/no SYK428293,f/h abington park brewery wellingborough road northampton t/no NN160993,f/h adam & eve high street homerton t/no EGL413814 (for details of further properties charged please refer to form 395) all estates or interests in such property and all buildings,trade and other fixtures,fixed plant and machinery from time to time on such f/h or l/h property. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Deutsche Trustee Company Limited as Agent and Trustee for the Borrower Secured Parties
    Транзакции
    • 31 мар. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 12 янв. 2017 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Borrower group deed of charge
    Создан 25 нояб. 2004 г.
    Поставлен 13 дек. 2004 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company or any other security provider to the borrower group security trustee or any of the other borrower group secured creditors on any account whatsoever and all monies due or to become due from the company and/or any other security provider and/or bankco and/or loanco to the borrower group security trustee or any of the other junior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    F/H property k/a abbey 944 chesterfield road sheffield t/no SYK428293, f/h property k/a abington park brewery wellingborough road northampton t/no NN160993, f/h property k/a adam & eve st james 81 & 82 petty france westminster london t/no LN211870. For details of further properties charged please refer to form 395. by way of fixed security all right title interest and benefit in to and under all shares stocks debentures and other securities and all dividends, the relevant documents, the insurance policies, the intellectual property rights, book debts and floating charge all undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Deutsche Trustee Company Limited (As Trustee for the Borrower Secured Parties)
    Транзакции
    • 13 дек. 2004 г.Регистрация обременения (395)
    • 12 янв. 2017 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Security agreement
    Создан 15 дек. 2003 г.
    Поставлен 31 дек. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Транзакции
    • 31 дек. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 дек. 2004 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Twentieth supplemental trust deed
    Создан 18 июл. 2003 г.
    Поставлен 24 июл. 2003 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    The principal amount of the £104,416,451 debenture stock of the lender (of which £29,126,963 is outstanding) secured by the trust deeds the premium (if any) and interest thereon and all other moneys intended to be secured by the trust deeds
    Краткое описание
    All its undertaking and all its assets both present and future wherever situate (including any uncalled capital) as a first floating charge.
    Уполномоченные лица
    • Alliance Assurance Company Limited (The Trustee)
    Транзакции
    • 24 июл. 2003 г.Регистрация обременения (395)
    • 23 сент. 2003 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у CPH (R&L) NO.1 LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    12 янв. 2017 г.Начало ликвидации
    15 апр. 2019 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Simon Harris
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Практик
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Ben David Woodthorpe
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Практик
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0