HCCAH LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Годовая отчетность
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииHCCAH LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 05096889
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель HCCAH LIMITED?

    • Спящие компании (99999) / Деятельность экстратерриториальных организаций и органов

    Где находится HCCAH LIMITED?

    Юридический адрес
    The Inspire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    North Yorkshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия HCCAH LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    ALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED01 июн. 2004 г.01 июн. 2004 г.
    TRUSHELFCO (NO.3043) LIMITED06 апр. 2004 г.06 апр. 2004 г.

    Каковы последние отчеты HCCAH LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 дек. 2013 г.

    Каков статус последней годовой декларации для HCCAH LIMITED?

    Годовая отчетность
    Последняя годовая отчетность

    Какие последние документы подавались HCCAH LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии компании с учета

    3 страницыDS01

    Назначение Mr James Alexander Burrell на должность директора 10 нояб. 2014 г.

    2 страницыAP01

    Бухгалтерская отчетность

    1 страницыAA

    Полное погашение обременения 7

    4 страницыMR04

    Регистрация обременения 050968890008, создано 12 июн. 2014 г.

    91 страницыMR01

    Полное погашение обременения 5

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 6

    1 страницыMR04

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital07 апр. 2014 г.

    Отчет о капитале на 07 апр. 2014 г.

    • Капитал: GBP 2
    SH01

    Назначение Mrs Geraldine Josephine Gallagher на должность директора 31 янв. 2014 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Matthew Edward Bennison в качестве директора 31 янв. 2014 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Matthew Edward Bennison в качестве секретаря 31 янв. 2014 г.

    1 страницыTM02

    Бухгалтерская отчетность

    1 страницыAA

    Заявление о предмете деятельности общества

    2 страницыCC04

    Решения

    Resolutions
    11 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    incorporation

    Решение об утверждении Устава

    RES01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01

    legacy

    18 страницыMG01

    Бухгалтерская отчетность

    1 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    4 страницыAR01

    legacy

    14 страницыMG01

    Бухгалтерская отчетность

    1 страницыAA

    Назначение Mr Matthew Edward Bennison на должность директора

    2 страницыAP01

    Назначение Mr Matthew Edward Bennison на должность секретаря

    1 страницыAP03

    Прекращение полномочий Timothy Doubleday в качестве директора

    1 страницыTM01

    Кто является должностными лицами HCCAH LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    BURRELL, James Alexander
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Директор
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United KingdomBritish192486560001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Директор
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandIrish185108770001
    HUNTER, Gail Susan
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Директор
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish89557480002
    TROY, Anthony Gerard
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    Директор
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomIrish104500230001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    161805270001
    DOUBLEDAY, Timothy
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    British156121500001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Секретарь
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Irish185108770001
    SOLOMAN, Sheila Margaret
    5 The Green
    Hardingstone
    NN4 7BU Northampton
    Northamptonshire
    Секретарь
    5 The Green
    Hardingstone
    NN4 7BU Northampton
    Northamptonshire
    British45253560008
    TRUSEC LIMITED
    2 Lambs Passage
    EC1Y 8BB London
    Номинированный секретарь
    2 Lambs Passage
    EC1Y 8BB London
    900007200001
    ANDERSON, Peter George
    23 Cheshire Road
    OX9 3LQ Thame
    Oxfordshire
    Директор
    23 Cheshire Road
    OX9 3LQ Thame
    Oxfordshire
    British70304810001
    BELLONE, Norman Edward
    Gardens Cottage
    Bagendon
    GL7 7DU Cirencester
    Gloucestershire
    Директор
    Gardens Cottage
    Bagendon
    GL7 7DU Cirencester
    Gloucestershire
    British126414070001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Директор
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish108534390002
    DAY, Mark
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    Директор
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    EnglandBritish124446000001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Директор
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish91011320001
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    Директор
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritish132613500001
    PEEKE, Alexander
    7 Milton Lodge
    Whitton Road
    TW1 1BU Twickenham
    Директор
    7 Milton Lodge
    Whitton Road
    TW1 1BU Twickenham
    British98031180001
    STOKER, Louise Jane
    2nd Floor Flat
    45 Hillfield Road, West Hampstead
    NW6 1QD London
    Директор
    2nd Floor Flat
    45 Hillfield Road, West Hampstead
    NW6 1QD London
    British96079800001
    WHITE, Graham Peter
    Copsem Lane
    KT22 0NT Oxshott
    Woodlands House
    Surrey
    Директор
    Copsem Lane
    KT22 0NT Oxshott
    Woodlands House
    Surrey
    United KingdomBritish4934020002
    ZUERCHER, Eleanor Jane
    14 St Marys Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Buckinghamshire
    Директор
    14 St Marys Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Buckinghamshire
    British61053330001

    Есть ли у HCCAH LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 12 июн. 2014 г.
    Поставлен 18 июн. 2014 г.
    Не погашен
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Транзакции
    • 18 июн. 2014 г.Регистрация залога (MR01)
    English law deed of accession
    Создан 27 февр. 2013 г.
    Поставлен 01 мар. 2013 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Транзакции
    • 01 мар. 2013 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 27 июн. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Debenture
    Создан 01 дек. 2011 г.
    Поставлен 10 дек. 2011 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 10 дек. 2011 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 03 июн. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Deed of accession
    Создан 18 июн. 2007 г.
    Поставлен 22 июн. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Транзакции
    • 22 июн. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 03 июн. 2014 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Создан 31 мар. 2006 г.
    Поставлен 06 апр. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Royal Bank of Scotland PLC as 'Security Agent'
    Транзакции
    • 06 апр. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 16 нояб. 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of accession to the composite guarantee and debenture dated 18 december 2003
    Создан 24 янв. 2005 г.
    Поставлен 02 февр. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due by each charging company to each of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Princess alexandra raf hospital, wroughton, nr swindon, wiltshire t/ns WT213965 and WT216467,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Транзакции
    • 02 февр. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 04 мая 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Создан 18 дек. 2003 г.
    Приобретен 24 янв. 2005 г.
    Поставлен 27 янв. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each charging company to each of the lenders
    Краткое описание
    Property k/a alexander house, wroughton, near swindon, wiltshire t/n WT2139665 and WT216467.
    Уполномоченные лица
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Транзакции
    • 27 янв. 2005 г.Регистрация приобретения (400)
    • 04 мая 2006 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Charge
    Создан 14 янв. 2000 г.
    Приобретен 24 янв. 2005 г.
    Поставлен 03 февр. 2005 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Land containing 29.830 hectares or thereabouts situated wroughton swindon wiltshire.
    Уполномоченные лица
    • The Secretary of State for Defence
    Транзакции
    • 03 февр. 2005 г.Регистрация приобретения (400)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0