BRANDSPACE GROUP LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииBRANDSPACE GROUP LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 05973040
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель BRANDSPACE GROUP LIMITED?

    • Прочие услуги н.в.и.д. (96090) / Деятельность по оказанию прочих услуг

    Где находится BRANDSPACE GROUP LIMITED?

    Юридический адрес
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия BRANDSPACE GROUP LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    PROMOTION SPACE GROUP LIMITED24 апр. 2007 г.24 апр. 2007 г.
    COBCO 810 LIMITED20 окт. 2006 г.20 окт. 2006 г.

    Каковы последние отчеты BRANDSPACE GROUP LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 мар. 2011 г.

    Какие последние документы подавались BRANDSPACE GROUP LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации кредиторов

    17 страницыLIQ14

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 27 мар. 2018 г.

    15 страницыLIQ03

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 27 мар. 2017 г.

    11 страницы4.68

    Полное погашение обременения 8

    4 страницыMR04

    Полное погашение обременения 10

    4 страницыMR04

    Полное погашение обременения 9

    4 страницыMR04

    Полное погашение обременения 6

    4 страницыMR04

    Полное погашение обременения 12

    4 страницыMR04

    Полное погашение обременения 7

    4 страницыMR04

    Прекращение полномочий Jane Elizabeth Vinson в качестве директора 28 сент. 2016 г.

    2 страницыTM01

    Прекращение полномочий Sebastien Canderle в качестве директора 02 июн. 2016 г.

    2 страницыTM01

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 27 мар. 2016 г.

    13 страницы4.68

    Заявление ликвидаторов о поступлениях и платежах до 27 мар. 2015 г.

    13 страницы4.68

    Регистрация банкротства

    Insolvency:secretary of state release of liquidator
    1 страницыLIQ MISC

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Решение суда по делу о банкротстве

    Court order insolvency:block transfer order - replacement of liquidator
    47 страницыLIQ MISC OC

    Уведомление о прекращении деятельности в качестве добровольного ликвидатора

    1 страницы4.40

    Отчет о ходе администрации до 28 мар. 2014 г.

    14 страницы2.24B

    Назначение ликвидатора

    1 страницы600

    Уведомление о переходе от администрации к добровольной ликвидации кредиторов

    1 страницы2.34B

    Отчет о ходе администрации до 04 окт. 2013 г.

    14 страницы2.24B

    Уведомление о предполагаемом одобрении предложений

    1 страницыF2.18

    Заявление о состоянии дел с приложенной формой 2.14B

    6 страницы2.16B

    Заявление о предложениях администратора

    31 страницы2.17B

    Кто является должностными лицами BRANDSPACE GROUP LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    DE YOUNG, Michelle Anna-Lisa
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    Директор
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    EnglandBritish140102770001
    LORD, Julian
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    Секретарь
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    British102300760001
    COBBETTS (SECRETARIAL) LIMITED
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    Секретарь компании
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    86546820001
    ALLNER, Christopher Charles
    Woodrow
    HP7 0QQ Amersham
    Childs Farm
    Директор
    Woodrow
    HP7 0QQ Amersham
    Childs Farm
    EnglandBritish78206300001
    BERGIN, Joseph Damien
    Springwood House
    Davey Lane
    SK9 7NZ Alderley Edge
    Cheshire
    Директор
    Springwood House
    Davey Lane
    SK9 7NZ Alderley Edge
    Cheshire
    United KingdomBritish113935400001
    CANDERLE, Sebastien
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    Директор
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    EnglandFrench124282690001
    FAY, Sean Ernan
    7th Floor South
    11-19 Artillery Row
    SW1P 1RT London
    Artillery House
    England
    Директор
    7th Floor South
    11-19 Artillery Row
    SW1P 1RT London
    Artillery House
    England
    United KingdomIrish84925400001
    HUGHES, Stephan Michael
    492 Hempshaw Lane
    SK2 5TL Stockport
    Cheshire
    Директор
    492 Hempshaw Lane
    SK2 5TL Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish95176800002
    JAQUES, Richard Charles
    Glenbank
    Kershaw Grove
    SK11 8TN Macclesfield
    Cheshire
    Директор
    Glenbank
    Kershaw Grove
    SK11 8TN Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritish56356980006
    JONES, Neil Henry
    Richmond Hill Court
    TW10 6BG Richmond
    98
    Surrey
    Директор
    Richmond Hill Court
    TW10 6BG Richmond
    98
    Surrey
    United KingdomBritish139632430001
    KEILLER, Andrew James
    Harlands Road
    RH16 1LZ Haywards Heath
    95
    West Sussex
    Директор
    Harlands Road
    RH16 1LZ Haywards Heath
    95
    West Sussex
    United KingdomBritish172132420001
    LANE, Damien John Patrick
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    England
    Директор
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    England
    EnglandEnglish158036110001
    LORD, Julian
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    Директор
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish102300760001
    RAVILIOUS, Greg William Frederick
    Furzefield Avenue
    TN3 0LD Speldhurst
    Ridge House
    Kent
    Директор
    Furzefield Avenue
    TN3 0LD Speldhurst
    Ridge House
    Kent
    United KingdomBritish130854210001
    SOANES, Paul Henry
    Sparrow Row
    GU24 8TA Chobham
    Woodside
    Surrey
    Директор
    Sparrow Row
    GU24 8TA Chobham
    Woodside
    Surrey
    EnglandBritish68377030007
    SOAR, Guy Jason
    Lime Grove
    Timperley
    WA15 6PJ Altrincham
    27
    Cheshire
    Директор
    Lime Grove
    Timperley
    WA15 6PJ Altrincham
    27
    Cheshire
    United KingdomBritish96671300002
    SPOONER, Julian Robert Archer
    Kings Road
    KT2 5JJ Kingston Upon Thames
    301
    Surrey
    Директор
    Kings Road
    KT2 5JJ Kingston Upon Thames
    301
    Surrey
    EnglandBritish117770880001
    TAYLOR, Richard David
    Lyndon Cottage
    York Road
    LS25 5JW Burton Salmon
    North Yorkshire
    Директор
    Lyndon Cottage
    York Road
    LS25 5JW Burton Salmon
    North Yorkshire
    United KingdomBritish123754500001
    VINSON, Jane Elizabeth
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    United Kingdom
    Директор
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish146632890001
    WADE, Roy
    Newman Grove
    College Farm
    FY5 2WT Thornton Cleveleys
    6
    Lancashire
    Директор
    Newman Grove
    College Farm
    FY5 2WT Thornton Cleveleys
    6
    Lancashire
    British131852890001
    WRIGHT, Richard Alan
    9 Belsize Mews
    Hampstead
    NW3 5AT London
    Директор
    9 Belsize Mews
    Hampstead
    NW3 5AT London
    United KingdomBritish80470950001
    COBBETTS (DIRECTOR) LIMITED
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    Директор компании
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    107196800001

    Есть ли у BRANDSPACE GROUP LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Debenture
    Создан 30 июн. 2010 г.
    Поставлен 08 июл. 2010 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Octopus Capital for Enterprise Fund L.P.
    Транзакции
    • 08 июл. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Создан 02 нояб. 2009 г.
    Поставлен 13 нояб. 2009 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 13 нояб. 2009 г.Регистрация обременения (MG01)
    • 17 нояб. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Composite guarantee and debentures
    Создан 14 июл. 2009 г.
    Поставлен 31 июл. 2009 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Octopus Investments Limited
    Транзакции
    • 31 июл. 2009 г.Регистрация обременения (395)
    Mortgage of a life policy
    Создан 12 авг. 2008 г.
    Поставлен 14 авг. 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Краткое описание
    P/No L0198163613, argon scottish equitable, life cover £500,000, date 31/07/08, life assured paul soanes see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 14 авг. 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 нояб. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Mortgage of a life policy to secure own liabilities
    Создан 30 апр. 2008 г.
    Поставлен 07 мая 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Life assured stephan hughes zurich assurance limited policy number 1827-62L-dhs lifestyle benefit: £1,000,000 life cover: £2,000,000 all bonuses all rights and interests see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 07 мая 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 нояб. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Mortgage of a life policy to secure own liabilities
    Создан 30 апр. 2008 г.
    Поставлен 07 мая 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Life assured guy soar zurich assurance limited policy number 1845-62L-dhs lifestyle benefit: £500,000 life cover: £1,000,000 all bonuses all rights and interests see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 07 мая 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 нояб. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Создан 30 апр. 2008 г.
    Поставлен 07 мая 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 07 мая 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 нояб. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Debenture
    Создан 30 апр. 2008 г.
    Поставлен 07 мая 2008 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 07 мая 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 17 нояб. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Guarantee & debenture
    Создан 30 апр. 2008 г.
    Поставлен 07 мая 2008 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Octopus Investments Limited as Security Trustee
    Транзакции
    • 07 мая 2008 г.Регистрация обременения (395)
    • 12 мая 2008 г.
    Debenture
    Создан 28 нояб. 2007 г.
    Поставлен 11 дек. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Транзакции
    • 11 дек. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 мая 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage of policy
    Создан 28 нояб. 2007 г.
    Поставлен 11 дек. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The policy being dated 1 july 2007 p/no 1845-62L-dhs with zurich assurance limited on the life of guy jason soar in the sum of £1,000,000. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Транзакции
    • 11 дек. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 мая 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage of policy
    Создан 28 нояб. 2007 г.
    Поставлен 11 дек. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The policy dated 1 july 2007 p/no 1827-62L-dhs with zurich assurance limited on the life of stephen michael hughes in the sum of £2,000,000. see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Транзакции
    • 11 дек. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 мая 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee & debenture
    Создан 30 апр. 2007 г.
    Поставлен 11 мая 2007 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Octopus Investments Limited (The Security Trustee)
    Транзакции
    • 11 мая 2007 г.Регистрация обременения (395)

    Есть ли у BRANDSPACE GROUP LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    05 апр. 2013 г.Начало управления
    28 мар. 2014 г.Окончание управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Практик
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Практик
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    2
    ДатаТип
    28 мар. 2014 г.Начало ликвидации
    16 янв. 2019 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по требованию кредиторов
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Предлагаемый ликвидатор
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Предлагаемый ликвидатор
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Практик
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Практик
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Neville Side
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Практик
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0