GREEN HILL ENERGY LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подтверждающее заявление
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииGREEN HILL ENERGY LIMITED
    Статус компанииАктивная
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 06952903
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель GREEN HILL ENERGY LIMITED?

    • Прочие вспомогательные услуги для бизнеса, не включенные в другие группировки (82990) / Административные и вспомогательные услуги

    Где находится GREEN HILL ENERGY LIMITED?

    Юридический адрес
    Beaufort Court
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Hertfordshire
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Каковы последние отчеты GREEN HILL ENERGY LIMITED?

    ПросроченоНет
    Следующие отчеты
    Следующий отчетный период заканчивается31 окт. 2024 г.
    Следующие отчеты должны быть представлены31 июл. 2025 г.
    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 окт. 2023 г.

    Каков статус последнего подтверждающего заявления для GREEN HILL ENERGY LIMITED?

    Последнее подтверждающее заявление составлено по состоянию на06 июл. 2025 г.
    Следующее подтверждающее заявление должно быть представлено20 июл. 2025 г.
    Последнее подтверждающее заявление
    Следующее подтверждающее заявление составлено по состоянию на06 июл. 2024 г.
    ПросроченоНет

    Какие последние документы подавались GREEN HILL ENERGY LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Уведомление о подтверждении, составленное 06 июл. 2024 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    37 страницыAA

    Прекращение полномочий Melissa Clare Venetia Charlton в качестве директора 06 мая 2024 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Stuart Patrick Lunn в качестве директора 06 мая 2024 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Milan Dave в качестве директора 06 мая 2024 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Jeremy Hugh Bass в качестве директора 06 мая 2024 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Sean Mackie на должность директора 01 мая 2024 г.

    2 страницыAP01

    Назначение Fiona Catherine Power на должность директора 01 мая 2024 г.

    2 страницыAP01

    Назначение David John Roland Eastman на должность директора 01 мая 2024 г.

    2 страницыAP01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    36 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 06 июл. 2023 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Назначение Melissa Clare Venetia Charlton на должность директора 25 янв. 2023 г.

    2 страницыAP01

    Изменение данных о Trafalgar Wind Holdings Limited как лице, осуществляющем значительный контроль, 23 сент. 2020 г.

    2 страницыPSC05

    Уведомление о подтверждении, составленное 06 июл. 2022 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    36 страницыAA

    Прекращение полномочий Jennifer Gascoigne в качестве директора 02 мар. 2022 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 06 июл. 2021 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Годовая бухгалтерская отчетность

    32 страницыAA

    Вторая подача заявления о назначении Mrs Jennifer Gascoigne директором

    3 страницыRP04AP01

    Вторая подача заявления о назначении Mr Jeremy Hugh Bass директором

    3 страницыRP04AP01

    Изменение данных директора для Mrs Jennifer Gascoigne 28 янв. 2021 г.

    2 страницыCH01

    Изменение данных директора для Mr Jeremy Hugh Bass 28 янв. 2021 г.

    2 страницыCH01

    Назначение Stuart Patrick Lunn на должность директора 28 янв. 2021 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Peter Douglas Stuart в качестве директора 28 янв. 2021 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Jeremy Hugh Bass на должность директора 28 янв. 2021 г.

    3 страницыAP01
    Аннотации
    ДатаАннотация
    03 февр. 2021 г.Clarification A second filed AP01 was registered on 03/02/21
    17 мар. 2021 г.Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 17/03/2021 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Кто является должностными лицами GREEN HILL ENERGY LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    HEARTH, Dominic James
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    Секретарь
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    British102764890002
    EASTMAN, David John Roland
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    ScotlandBritishProject Manager265278310002
    MACKIE, Sean
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCommercial Manager322708780001
    POWER, Fiona Catherine
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant322707490001
    BASS, Jeremy Hugh
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    Директор
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    United KingdomBritishHead Of Specialist Services279106320001
    CHARLTON, Melissa Clare Venetia
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Strategy & Sustainability304733570001
    DAVE, Milan
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    Директор
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCommercial Manager252806980001
    FARNHILL, Russell Alan
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    Директор
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    United KingdomBritishGroup Financial Controller160135480001
    GASCOIGNE, Jennifer
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    Директор
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director279106310001
    HUGHES, Steven William
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    Директор
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    EnglandBritishGeneration & Asset Management Director122301220003
    JOHNSTON, Allan Gerard
    Polbae Crescent
    Eaglesham
    G76 0LR Glasgow
    29
    East Renfrewshire
    Директор
    Polbae Crescent
    Eaglesham
    G76 0LR Glasgow
    29
    East Renfrewshire
    United KingdomBritishEngineer139375400001
    LUNN, Stuart Patrick
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    United Kingdom
    Директор
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    United Kingdom
    United KingdomBritishCommercial Director Uk&I279107930001
    MACDOUGALL, Gordon Alan
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    Директор
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    United KingdomBritishManaging Director, Western Europe139037300001
    MERRY, Fraser Stephen
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    Директор
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor62088380003
    PATEL, Mitesh Raj
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    Директор
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    United KingdomBritishGroup Financial Controller251624130001
    RUFFLE, Rachel
    Bourne Road
    HP4 3JU Berkhamsted
    4
    Hertfordshire
    Директор
    Bourne Road
    HP4 3JU Berkhamsted
    4
    Hertfordshire
    United KingdomBritishHead Of Uk & Ireland Development130053180002
    RUSSELL, Richard Paul
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    Директор
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director190386180001
    STUART, Peter Douglas
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Egg Farm Lane
    WD4 8LR Kings Langley
    Beaufort Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrishTechnical Director265576050001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над GREEN HILL ENERGY LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    One Bartholomew Close
    Barts Square
    EC1A 7BL London
    Level 7
    England
    30 окт. 2018 г.
    One Bartholomew Close
    Barts Square
    EC1A 7BL London
    Level 7
    England
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииUnited Kingdom
    Юридическое основаниеCorporate Law
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер11443809
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.
    The Renewables Infrastructure Group (Uk) Investments Limited
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    England
    06 апр. 2016 г.
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    England
    Да
    Организационно-правовая формаPrivate Limited Company
    Страна регистрацииUnited Kingdom
    Юридическое основаниеCompanies Act 2006
    Место регистрацииEngland And Wales
    Регистрационный номер09564873
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у GREEN HILL ENERGY LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 07 дек. 2018 г.
    Поставлен 21 дек. 2018 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    1. lease between (1) green hill energy limited (company number 06952903), A. company incorporated in england whose registered office is at beaufort court, egg. Farm lane, kings langley, hertfordshire, WD4 8LR and (2) robert wilson and. Margaret aird wilson, spouses, both residing at dykes farm, dalry, ayrshire dated 6. july and 15 july 2010 and registered in the land register of scotland under title. Number AYR89892 on 29 july 2010.. 2. lease between (1) green hill energy limited (company number 06952903), A. company incorporated in england whose registered office is at beaufort court, egg. Farm lane, kings langley, hertfordshire, WD4 8LR and (2) ronald purves fergie,. Residing at knockenden farm, dalry, ayrshire dated 7 july and 15 july 2010 and. Registered in the land register of scotland under title number AYR89938 on 4. august 2010.. 3. lease between (1) green hill energy limited (company number 06952903), A. company incorporated in england whose registered office is at beaufort court, egg. Farm lane, kings langley, hertfordshire, WD4 8LR and (2) blair trust company. (Company number SC013503), a private unlimited company incorporated in scotland. Whose registered office was formally at clydesdale bank chambers, dalry, ayrshire. And is now at edinburgh quay, 133 fountainbridge, edinburgh, EH3 96A with the. Consent of luke malise borwick dated 3 july and 15 july 2010 and registered in the. Land register of scotland under title number AYR89940 on 4 august 2010.. J. 4. lease between (1) green hill energy limited (company number 06952903), A. company incorporated in england whose registered office is at beaufort court, egg. Farm lane, kings langley, hertfordshire, WD4 8LR and (2) the right honourable. Patrick robin archibald boyle, the earl of glasgow, residing at kelburn, fairlie,. Ayrshire dated 23 april and 7 june 2010 and registered in the land register of. Scotland under title number AYR89722 on 8 july 2010.
    Уполномоченные лица
    • Kfw Ipex-Bank Gmbh
    Транзакции
    • 21 дек. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 31 окт. 2018 г.
    Поставлен 01 нояб. 2018 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    1. lease between (1) green hill energy limited (company number 06952903), a company incorporated in england whose registered office is at beaufort court, egg farm lane, kings langley, hertfordshire, WD4 8LR and (2) robert wilson and margaret aird wilson, spouses, both residing at dykes farm, dalry, ayrshire dated 6 july and 15 july 2010 and registered in the land register of scotland under title number AYR89892 on 29 july 2010.. 2. lease between (1) green hill energy limited (company number 06952903), a company incorporated in england whose registered office is at beaufort court, egg farm lane, kings langley, hertfordshire, WD4 8LR and (2) ronald purves fergie, residing at knockenden farm, dalry, ayrshire dated 7 july and 15 july 2010 and registered in the land register of scotland under title number AYR89938 on 4 august 2010.. 3. lease between (1) green hill energy limited (company number 06952903), a company incorporated in england whose registered office is at beaufort court, egg farm lane, kings langley, hertfordshire, WD4 8LR and (2) blair trust company (company number SC013503), a private unlimited company incorporated in scotland whose registered office was formally at clydesdale bank chambers, dalry, ayrshire and is now at edinburgh quay, 133 fountainbridge, edinburgh, EH3 9BA with the consent of luke malise borwick dated 3 july and 15 july 2010 and registered in the land register of scotland under title number AYR89940 on 4 august 2010.. 4. lease between (1) green hill energy limited (company number 06952903), a company incorporated in england whose registered office is at beaufort court, egg farm lane, kings langley, hertfordshire, WD4 8LR and (2) the right honourable patrick robin archibald boyle, the earl of glasgow, residing at kelburn, fairlie, ayrshire dated 23 april and 7 june 2010 and registered in the land register of scotland under title number AYR89722 on 8 july 2010.
    Уполномоченные лица
    • Kfw Ipex-Bank Gmbh
    Транзакции
    • 01 нояб. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 31 окт. 2018 г.
    Поставлен 31 окт. 2018 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    1. lease between (1) green hill energy limited (company number 06952903), a company incorporated in england whose registered office is at beaufort court, egg farm lane, kings langley, hertfordshire, WD4 8LR and (2) robert wilson and margaret aird wilson, spouses, both residing at dykes farm, dalry, ayrshire dated 6 july and 15 july 2010 and registered in the land register of scotland under title number AYR89892 on 29 july 2010.. 2. lease between (1) green hill energy limited (company number 06952903), a company incorporated in england whose registered office is at beaufort court, egg farm lane, kings langley, hertfordshire, WD4 8LR and (2) ronald purves fergie, residing at knockenden farm, dalry, ayrshire dated 7 july and 15 july 2010 and registered in the land register of scotland under title number AYR89938 on 4 august 2010.. 3. lease between (1) green hill energy limited (company number 06952903), a company incorporated in england whose registered office is at beaufort court, egg farm lane, kings langley, hertfordshire, WD4 8LR and (2) blair trust company (company number SC013503), a private unlimited company incorporated in scotland whose registered office was formally at clydesdale bank chambers, dalry, ayrshire and is now at edinburgh quay, 133 fountainbridge, edinburgh, EH3 9BA with the consent of luke malise borwick dated 3 july and 15 july 2010 and registered in the land register of scotland under title number AYR89940 on 4 august 2010.. 4. lease between (1) green hill energy limited (company number 06952903), a company incorporated in england whose registered office is at beaufort court, egg farm lane, kings langley, hertfordshire, WD4 8LR and (2) the right honourable patrick robin archibald boyle, the earl of glasgow, residing at kelburn, fairlie, ayrshire dated 23 april and 7 june 2010 and registered in the land register of scotland under title number AYR89722 on 8 july 2010.
    Уполномоченные лица
    • Kfw Ipex-Bank Gmbh
    Транзакции
    • 31 окт. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 31 окт. 2018 г.
    Поставлен 31 окт. 2018 г.
    Не погашен
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Kfw Ipex-Bank Gmbh
    Транзакции
    • 31 окт. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 29 окт. 2018 г.
    Поставлен 31 окт. 2018 г.
    Не погашен
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Kfw Ipex-Bank Gmbh
    Транзакции
    • 31 окт. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    Standard security executed on 27 october 2010
    Создан 01 нояб. 2010 г.
    Поставлен 13 нояб. 2010 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All and whole the tenant's interest in the lease by the right honourable patrick robin archibald boyle, the earl of glasgow in favour of green hill energy limited dated 23 april and 7 june and registered in the books of council and session on 3 august 2010 an in the course of registration in the land register of scotland under t/no: AYR89722 see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC, as Trustee and Security Agent for the Secured Creditors (The "Security Agent")
    Транзакции
    • 13 нояб. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    Standard security executed on 27 october 2010
    Создан 01 нояб. 2010 г.
    Поставлен 13 нояб. 2010 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All and whole the tenants interest in the lease granted by blair trust company with consent of luke malise borwick in favour of green hill energy limited dated 3 and 15 july 2010 and registered in the books of council and session on 23 august 2010 and in the course of registration in the land register of scotland under t/no: AYR89940 see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC, as Trustee and Security Agent for the Secured Creditors (The "Security Agent")
    Транзакции
    • 13 нояб. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    Standard security
    Создан 01 нояб. 2010 г.
    Поставлен 11 нояб. 2010 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The chargor as a continuing security for the payment and discharge of the secured obligations hereby grants a standard security in favour of the security agent as trustee for the secured creditors see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Транзакции
    • 11 нояб. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    Standard security
    Создан 01 нояб. 2010 г.
    Поставлен 11 нояб. 2010 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The chargor as a continuing security for the payment and discharge of the secured obligations hereby grants a standard security in favour of the security agent see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Транзакции
    • 11 нояб. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    Assignation in security
    Создан 28 окт. 2010 г.
    Поставлен 11 нояб. 2010 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    As continuing security for the payment and discharge of the secured obligations has assigned its whole, right, title, interest and benefit in and to the contracts and all related rights see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC as Trustee and Security Agent for the Secured Creditors from Time to Time (The "Security Agent")
    Транзакции
    • 11 нояб. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)
    Debenture
    Создан 27 окт. 2010 г.
    Поставлен 01 нояб. 2010 г.
    Не погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 01 нояб. 2010 г.Регистрация обременения (MG01)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0