THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.6, LLP

  • Обзор
  • Резюме
  • Адрес
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Заявления лиц, оказывающих значительное влияние
  • Залоги
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииTHE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.6, LLP
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью (полное товарищество)
    Номер компании OC301153
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиНет
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Где находится THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.6, LLP?

    Юридический адрес
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Middlesex
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Каковы последние отчеты THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.6, LLP?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на05 апр. 2018 г.

    Какие последние документы подавались THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.6, LLP?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательный Вестник, ликвидированный путем добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ2(A)

    Первое уведомление в Вестнике о добровольной ликвидации

    1 страницыGAZ1(A)

    Заявление о снятии с учета партнерства с ограниченной ответственностью

    3 страницыLLDS01

    Прекращение полномочий Paul Graham Wiltshire в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Simon Francis Winn в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Iestyn Milton Williams в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Rhoderick Peter Whitbread в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Lewis Fitzgerald Watts в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Nigel Jeremy Webb в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Garry Tibbott Veale в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Walter Henry Rupert Wilkes в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Stephen William Vaughan в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Julian Usher в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Katherine Isobel Mary Sanders в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Martin Philip Trees в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Paul Smith в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Neil Douglas Smith в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Lance Clifford Redfern Smith в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Werner Schuenemann в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Trudi Ometha Ryan Dawes в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Peter John Rowlins в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Daman Marcus Sanders в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Christine Louise Marina Ross в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Peter Bernard Robson в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Прекращение полномочий Stuart Godfrey Popham в качестве участника 01 апр. 2019 г.

    1 страницыLLTM01

    Кто является должностными лицами THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.6, LLP?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    INVICTA FILM NOMINEES LIMITED
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Назначенный член LLP
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Тип идентификацииЕЭЗ
    Регистрационный номер4244535
    141180010001
    SOVEREIGN FILM NOMINEES LIMITED
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Назначенный член LLP
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Тип идентификацииЕЭЗ
    Регистрационный номер4244204
    141180020001
    ANDREW, Jonathan
    Steels Lane
    Cherington
    CV36 5HL Shipston On Stour
    The Thatched Cottage
    Warwickshire
    Член LLP
    Steels Lane
    Cherington
    CV36 5HL Shipston On Stour
    The Thatched Cottage
    Warwickshire
    England88713160003
    BALZER, Doris
    154 Ashley Gardens
    Thirleby
    SW1P 1HW London
    Член LLP
    154 Ashley Gardens
    Thirleby
    SW1P 1HW London
    United Kingdom141222510001
    BARNES, Simon Seton
    Frienden Farm
    Moat Lane Chiddingstone Hoath
    TN8 7DN Edenbridge
    Член LLP
    Frienden Farm
    Moat Lane Chiddingstone Hoath
    TN8 7DN Edenbridge
    England138395230001
    BEST, Anthony John
    64 Chester Square
    SW1W 9EA London
    Член LLP
    64 Chester Square
    SW1W 9EA London
    United Kingdom141213930001
    BLACKMAN, Carmela Louisa
    Warren Yard
    Wolverton Mill
    MK12 5NW Milton Keynes
    3
    England
    Член LLP
    Warren Yard
    Wolverton Mill
    MK12 5NW Milton Keynes
    3
    England
    England19845460001
    BRADLEY, Carolyn Jane
    Coleman Street
    EC2R 5AA London
    1
    England
    Член LLP
    Coleman Street
    EC2R 5AA London
    1
    England
    United Kingdom71314040004
    BROOKES, Martin
    Fairbridge Road
    N19 3EW London
    39
    England
    Член LLP
    Fairbridge Road
    N19 3EW London
    39
    England
    United Kingdom141222180005
    BULL, Ian Alan
    16 Wykeham Gate
    HP17 8DF Haddenham
    Член LLP
    16 Wykeham Gate
    HP17 8DF Haddenham
    England210299090001
    CAKEBREAD, Stuart Alan Charles
    Manor Cottage
    The Green
    OX12 0LQ West Hanney
    Член LLP
    Manor Cottage
    The Green
    OX12 0LQ West Hanney
    United Kingdom141213960001
    CASTIAU, Jain Anne
    Marine Parade
    CT5 2BQ Whitstable
    6
    Kent
    England
    Член LLP
    Marine Parade
    CT5 2BQ Whitstable
    6
    Kent
    England
    United Kingdom78256720003
    CHALK, John William
    Flat 1501 20 Palace Street
    SW1E 5BB London
    Член LLP
    Flat 1501 20 Palace Street
    SW1E 5BB London
    United Kingdom74739180015
    CLOWES, David James Leonard
    54 Heathview
    Gordon House Road
    NW5 1LR London
    Член LLP
    54 Heathview
    Gordon House Road
    NW5 1LR London
    United Kingdom36989810001
    CRAWFORD, Philip James
    Cranbourne Lodge
    Drift Road
    SL4 4RP Winkfield
    Член LLP
    Cranbourne Lodge
    Drift Road
    SL4 4RP Winkfield
    England61146460001
    DANIEL, George Edward
    Oak Lane
    TN13 1UF Sevenoaks
    Burwood Lodge
    Kent
    Член LLP
    Oak Lane
    TN13 1UF Sevenoaks
    Burwood Lodge
    Kent
    United Kingdom141222400002
    DONNELLY, Mal
    Fieldings
    Berry Lane
    MK17 8HS Aspley Guise
    Член LLP
    Fieldings
    Berry Lane
    MK17 8HS Aspley Guise
    United Kingdom74225620001
    DOOTSON, David Philip
    Finlow Hill Lane
    Over Alderley
    SK10 4UG Macclesfield
    Finlow Hill
    Cheshire
    England
    Член LLP
    Finlow Hill Lane
    Over Alderley
    SK10 4UG Macclesfield
    Finlow Hill
    Cheshire
    England
    United Kingdom222661330001
    DWYER, Tonianne
    Castle Street
    4103 Fairfield
    20
    Queensland
    Australia
    Член LLP
    Castle Street
    4103 Fairfield
    20
    Queensland
    Australia
    Australia141222160004
    DYSON, Arthur John
    Cambridge Street
    SW1V 4QQ London
    60
    England
    Член LLP
    Cambridge Street
    SW1V 4QQ London
    60
    England
    United Kingdom141222710006
    FRANGAKIS, Athanassios
    4 Hillside Close
    NW8 0EF London
    Член LLP
    4 Hillside Close
    NW8 0EF London
    United Kingdom32310140001
    GIBSON, Peter John Bradford
    Great Bardfield Hall
    Great Bardfield
    CM7 4RZ Braintree
    Член LLP
    Great Bardfield Hall
    Great Bardfield
    CM7 4RZ Braintree
    United Kingdom141222440001
    GRASSO, Luigi
    Hyde Park Square
    W2 2LU London
    14
    England
    Член LLP
    Hyde Park Square
    W2 2LU London
    14
    England
    United Kingdom141213770003
    GRAY, Duncan Cameron
    Clandon Road
    GU4 7UW West Glandon
    Haven House
    Член LLP
    Clandon Road
    GU4 7UW West Glandon
    Haven House
    United Kingdom141222560003
    GREEN, Philip
    4 Denewood Road
    N6 4AJ London
    Член LLP
    4 Denewood Road
    N6 4AJ London
    England30316150004
    GWYN JONES, Timothy
    Hamstead Lodge Hampstead House
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    Член LLP
    Hamstead Lodge Hampstead House
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    United Kingdom48297190002
    HALE, Graham
    Graythwaite
    Barrow Lane
    WA15 0DL Hale
    Член LLP
    Graythwaite
    Barrow Lane
    WA15 0DL Hale
    England16807130001
    HANSON, Ian Lawrence
    House On The Hill
    Beechwood Drive
    SI7 2DH Marlow
    Член LLP
    House On The Hill
    Beechwood Drive
    SI7 2DH Marlow
    United Kingdom99645000001
    HARRIS, George
    6 Clonway
    PL20 6EG Yelverton
    Член LLP
    6 Clonway
    PL20 6EG Yelverton
    United Kingdom3087310001
    HARTWELL, Andrew James
    57 Corringham Road
    NW11 7BS London
    Член LLP
    57 Corringham Road
    NW11 7BS London
    United Kingdom141222530001
    HAYEEM, Marc
    4 Royce Grove
    WD25 7GD Leavesden
    Член LLP
    4 Royce Grove
    WD25 7GD Leavesden
    United Kingdom77750110001
    HENMAN, Timothy Henry
    Filberts
    Aston Tirrold
    OX11 9DY Didcot
    Член LLP
    Filberts
    Aston Tirrold
    OX11 9DY Didcot
    United Kingdom141222230001
    HERBERT, Richard David Standish
    Forty Green Road
    HP9 1XS Beaconsfield
    Orchard Cottage
    Член LLP
    Forty Green Road
    HP9 1XS Beaconsfield
    Orchard Cottage
    England141222460001
    HOLDEN, Gary
    62 Paper Mill Wharf
    50 Narrow Street Limehouse
    E14 8BZ London
    Член LLP
    62 Paper Mill Wharf
    50 Narrow Street Limehouse
    E14 8BZ London
    United Kingdom78011050001
    HUGHES, Colin Norman
    Chaithanya Smaran
    Kannamangala Main Road
    Whitefield
    R-108
    Bangalore 560067
    India
    Член LLP
    Chaithanya Smaran
    Kannamangala Main Road
    Whitefield
    R-108
    Bangalore 560067
    India
    United Kingdom141222210002

    Каковы последние заявления о лицах, осуществляющих значительный контроль над THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.6, LLP?

    Заявления лиц, оказывающих значительное влияние
    УведомленПрекращеноЗаявление
    23 мар. 2017 г.Компания знает или имеет разумные основания полагать, что в отношении компании нет ни одного регистрируемого лица или регистрируемого соответствующего юридического лица.

    Есть ли у THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.6, LLP какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    Charge over assets
    Создан 01 авг. 2002 г.
    Поставлен 05 авг. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of first fixed charge the whole and every part of its right title and interest in and to all monies from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account, the right to demand the same. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Sociiti Ginirale
    Транзакции
    • 05 авг. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 апр. 2019 г.Удовлетворение залога (LLMR04)
    Charge over assets
    Создан 28 июн. 2002 г.
    Поставлен 05 июл. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All obligations and liabilities due or to become due from the borrowers or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    First fixed charge over all right,title and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each dedicated account and the debts represented thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Societe Generale
    Транзакции
    • 05 июл. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 апр. 2019 г.Удовлетворение залога (LLMR04)
    Pledge and chage
    Создан 03 мая 2002 г.
    Поставлен 09 мая 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    First fixed charge over the rights and interests of parties to the existing agreements; by way of pledge of thge delivery material relating to the tv programmes entitled "ncs manhunt - series 2","the secret" and "man & boy". See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Centre House Productions Limited
    Транзакции
    • 09 мая 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 апр. 2019 г.Удовлетворение залога (LLMR04)
    Pledge and charge
    Создан 16 апр. 2002 г.
    Поставлен 26 апр. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to sg leasing (march) limited (sglm) and/or the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of first fixed charge all the chargor's right title and interest in and to the rights. By way of pledge of the delivery material (the original picture negative and other physical materials and documentation relating to the television programmes entitled "born and bred" (aka "heart of the valley") and "murder in mind" series 2 episodes 3-6). see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Centre House Productions Limited
    Транзакции
    • 26 апр. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 апр. 2019 г.Удовлетворение залога (LLMR04)
    Charge over assets
    Создан 16 апр. 2002 г.
    Поставлен 17 апр. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    By way of first fixed charge the whole and every part of its right title and nterest in and to the security assignment please refer to form 395 for full details.
    Уполномоченные лица
    • Societe Generale
    Транзакции
    • 17 апр. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 апр. 2019 г.Удовлетворение залога (LLMR04)
    Charge over assets
    Создан 27 мар. 2002 г.
    Поставлен 04 апр. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The whole and every part of its right title and interest in and to the security assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Societe Generale
    Транзакции
    • 04 апр. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 апр. 2019 г.Удовлетворение залога (LLMR04)
    Charge over assets
    Создан 28 февр. 2002 г.
    Поставлен 08 мар. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    The company with full title guarantee, as security for the payment, discharge and performance of all secured liabilities; charges to the chargee by way of first fixed charge (a) the whole and every part of its right, title and interest in and to the security assignment;. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Societe Generale
    Транзакции
    • 08 мар. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 02 апр. 2019 г.Удовлетворение залога (LLMR04)

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0