STEWART MILNE GROUP LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подтверждающее заявление
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииSTEWART MILNE GROUP LIMITED
    Статус компанииВ управлении
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании SC057709
    ЮрисдикцияШотландия
    Дата создания

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель STEWART MILNE GROUP LIMITED?

    • Строительство коммерческих зданий (41201) / Строительство
    • Деятельность головных офисов (70100) / Деятельность профессиональная, научная и техническая

    Где находится STEWART MILNE GROUP LIMITED?

    Юридический адрес
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    66 Hanover Street
    EH2 1EL Edinburgh
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Каковы последние отчеты STEWART MILNE GROUP LIMITED?

    ПросроченоДа
    Следующие отчеты
    Следующий отчетный период заканчивается30 окт. 2023 г.
    Следующие отчеты должны быть представлены30 июл. 2024 г.
    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на31 окт. 2022 г.

    Каков статус последнего подтверждающего заявления для STEWART MILNE GROUP LIMITED?

    ПросроченоДа
    Последнее подтверждающее заявление составлено по состоянию на08 янв. 2024 г.
    Следующее подтверждающее заявление должно быть представлено22 янв. 2024 г.
    Последнее подтверждающее заявление
    Следующее подтверждающее заявление составлено по состоянию на08 янв. 2023 г.
    ПросроченоДа

    Какие последние документы подавались STEWART MILNE GROUP LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Промежуточный отчет администратора

    54 страницыAM10(Scot)

    Прекращение полномочий Gerald Campbell More в качестве директора 21 янв. 2025 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Robert Fraser Pearson Park в качестве директора 21 дек. 2024 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий Robert Fraser Pearson Park в качестве секретаря 21 дек. 2024 г.

    1 страницыTM02

    Уведомление о продлении срока управления

    5 страницыAM19(Scot)

    Прекращение полномочий Stuart Alastair Macgregor в качестве директора 14 нояб. 2024 г.

    1 страницыTM01

    Промежуточный отчет администратора

    47 страницыAM10(Scot)

    Одобрение предложений администратора

    65 страницыAM06(Scot)

    Одобрение предложений администратора

    65 страницыAM06(Scot)

    Уведомление о предложении администратора

    65 страницыAM03(Scot)

    Заявление о состоянии дел AM02SOASCOT

    27 страницыAM02(Scot)

    Юридический адрес изменен с Peregrine House, Mosscroft Avenue Westhill Business Park Westhill Aberdeen AB32 6JQ United Kingdom на C/O Teneo Financial Advisory Limited 66 Hanover Street Edinburgh EH2 1EL 22 янв. 2024 г.

    2 страницыAD01

    Назначение администратора

    4 страницыAM01(Scot)

    Юридический адрес изменен с Peregrine House,Mosscroft Avenue Westhill Business Park Westhill Aberdeeen AB32 6TQ на Peregrine House, Mosscroft Avenue Westhill Business Park Westhill Aberdeen AB32 6JQ 01 авг. 2023 г.

    1 страницыAD01

    Консолидированная бухгалтерская отчетность

    53 страницыAA

    Полное погашение обременения 99

    1 страницыMR04

    Регистрация обременения SC0577090232, создано 06 мар. 2023 г.

    7 страницыMR01

    Полное погашение обременения SC0577090195

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения SC0577090229

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения SC0577090230

    1 страницыMR04

    Уведомление о подтверждении, составленное 08 янв. 2023 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Полное погашение обременения SC0577090140

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения SC0577090204

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 37

    1 страницыMR04

    Полное погашение обременения 126

    1 страницыMR04

    Кто является должностными лицами STEWART MILNE GROUP LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    EVERETT, Martyn John
    66 Hanover Street
    EH2 1EL Edinburgh
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    Директор
    66 Hanover Street
    EH2 1EL Edinburgh
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    EnglandBritishCompany Director30098070003
    FENTON, Clive
    Westhill Business Park
    Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House, Mosscroft Avenue
    Scotland
    Директор
    Westhill Business Park
    Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House, Mosscroft Avenue
    Scotland
    United KingdomBritishCompany Director176758890001
    MILNE, Stewart
    Dalhebity House
    Baillieswells Road, Bieldside
    AB15 9BQ Aberdeen
    Директор
    Dalhebity House
    Baillieswells Road, Bieldside
    AB15 9BQ Aberdeen
    ScotlandBritishCompany Director190960001
    ANDERSON, Lesley
    70 Woodend Crescent
    AB15 6YQ Aberdeen
    Секретарь
    70 Woodend Crescent
    AB15 6YQ Aberdeen
    British83529270002
    CORRAY, Pamela Jane
    146 Hamilton Place
    AB15 5BB Aberdeen
    Aberdeenshire
    Секретарь
    146 Hamilton Place
    AB15 5BB Aberdeen
    Aberdeenshire
    British83551930001
    IRVINE, John Christopher
    34 Cairds Wynd
    AB31 5XU Banchory
    Kincardineshire
    Секретарь
    34 Cairds Wynd
    AB31 5XU Banchory
    Kincardineshire
    British38442060002
    KERR, Gayle
    Terryvale House
    Dunecht
    AB32 7BS Westhill
    Секретарь
    Terryvale House
    Dunecht
    AB32 7BS Westhill
    British102984300001
    MARTIN, Scott Craig
    Mosscroft Avenue
    Westhill Business Park Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House
    Scotland
    Секретарь
    Mosscroft Avenue
    Westhill Business Park Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House
    Scotland
    178781280001
    MEDINE, Michael Sinclair
    Peregrine House,Mosscroft Avenue
    Westhill Business Park
    AB32 6TQ Westhill
    Aberdeeen
    Секретарь
    Peregrine House,Mosscroft Avenue
    Westhill Business Park
    AB32 6TQ Westhill
    Aberdeeen
    248550390001
    MILNE, Hamish
    Alt Na Braigh
    265 North Deeside Road
    AB13 0HD Milltimber,Aberdeen
    Секретарь
    Alt Na Braigh
    265 North Deeside Road
    AB13 0HD Milltimber,Aberdeen
    British189710004
    MITCHELL, Paul Watt
    2 Kingswood Avenue
    Kingswells
    AB15 8AE Aberdeen
    Секретарь
    2 Kingswood Avenue
    Kingswells
    AB15 8AE Aberdeen
    British86499970002
    OAG, Stuart Charles
    Woodlands Crescent
    Cults
    AB15 9DH Aberdeen
    7
    Aberdeenshire
    Секретарь
    Woodlands Crescent
    Cults
    AB15 9DH Aberdeen
    7
    Aberdeenshire
    British129503880001
    PARK, Robert Fraser Pearson
    66 Hanover Street
    EH2 1EL Edinburgh
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    Секретарь
    66 Hanover Street
    EH2 1EL Edinburgh
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    274119610001
    ALLISON, Glenn Fraser Whyte
    Linden Beeches
    442 North Deeside Road
    AB15 9ET Cults
    Aberdeenshire
    Директор
    Linden Beeches
    442 North Deeside Road
    AB15 9ET Cults
    Aberdeenshire
    United KingdomBritishCompany Director63687770002
    BETHUNE, Hamish William
    Auchenross
    PH6 2JU Comrie
    Perthshire
    Директор
    Auchenross
    PH6 2JU Comrie
    Perthshire
    BritishExecutive Director1198020003
    COCHRANE, Gordon
    Beaconhill Den
    AB13 0HT Milltimber
    Aberdeen
    Директор
    Beaconhill Den
    AB13 0HT Milltimber
    Aberdeen
    ScotlandBritishCompany Director545540005
    FOTHERINGHAM, John
    St Helens
    KY8 4JL Earlsferry
    Fife
    Директор
    St Helens
    KY8 4JL Earlsferry
    Fife
    BritishCompany Director141280001
    GOODFELLOW, Alex
    Westhill Business Park
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House
    Scotland
    Директор
    Westhill Business Park
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House
    Scotland
    ScotlandBritishCompany Director164294980001
    GRANT, Alan
    Fairways
    AB33 8FW Alford
    Aberdeenshire
    Директор
    Fairways
    AB33 8FW Alford
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishCompany Director190450001
    INNES, Iain Baxter
    6 Macaulay Place
    Hazlehead
    AB15 8FP Aberdeen
    Aberdeenshire
    Директор
    6 Macaulay Place
    Hazlehead
    AB15 8FP Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishCompany Director122348030001
    IRVINE, John Christopher
    Forestside Road
    AB31 5ZH Banchory
    38
    Kincardineshire
    Директор
    Forestside Road
    AB31 5ZH Banchory
    38
    Kincardineshire
    ScotlandUnited KingdomFinance Director38442060003
    MACGREGOR, Stuart Alastair
    Westhill Business Park
    Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House, Mosscroft Avenue
    Scotland
    Директор
    Westhill Business Park
    Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House, Mosscroft Avenue
    Scotland
    ScotlandBritishFinance Director330152850001
    MACKAY, Hugh James
    The Oaks
    Abergeldie Road
    AB35 5RR Ballater
    Aberdeenshire
    Директор
    The Oaks
    Abergeldie Road
    AB35 5RR Ballater
    Aberdeenshire
    United KingdomBritishCompany Director189730001
    MILNE, Barbara
    Beaconhill Cottage
    Milltimber
    AB1 0HT Aberdeen
    Директор
    Beaconhill Cottage
    Milltimber
    AB1 0HT Aberdeen
    BritishCompany Director842580002
    MILNE, Hamish
    Alt Na Braigh
    265 North Deeside Road
    AB13 0HD Milltimber,Aberdeen
    Директор
    Alt Na Braigh
    265 North Deeside Road
    AB13 0HD Milltimber,Aberdeen
    United KingdomBritishCompany Director189710004
    MORE, Gerald Campbell
    66 Hanover Street
    EH2 1EL Edinburgh
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    Директор
    66 Hanover Street
    EH2 1EL Edinburgh
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    ScotlandBritishChartered Accountant211208700001
    MURRAY, Michael Gerard
    49 Milverton Road
    Giffnock
    G46 7JN Glasgow
    Lanarkshire
    Директор
    49 Milverton Road
    Giffnock
    G46 7JN Glasgow
    Lanarkshire
    BritishManagement Consultant127460001
    PARK, Robert Fraser Pearson
    66 Hanover Street
    EH2 1EL Edinburgh
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    Директор
    66 Hanover Street
    EH2 1EL Edinburgh
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    ScotlandBritishGroup Finance Director241939100001
    REDBURN, Timothy John
    Westhill Business Park
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House
    Scotland
    Директор
    Westhill Business Park
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House
    Scotland
    EnglandBritishAccountant22018030002
    SLATER FEARN, John
    12 Church Green
    Ramsey
    PE26 1DW Huntingdon
    Cambridgeshire
    Директор
    12 Church Green
    Ramsey
    PE26 1DW Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishManaging Director84997180003

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над STEWART MILNE GROUP LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    HX1 2RG Halifax
    Trinity Road
    United Kingdom
    08 авг. 2017 г.
    HX1 2RG Halifax
    Trinity Road
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаCorporate
    Страна регистрацииUnited Kingdom
    Юридическое основаниеEngland And Wales
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер02249630
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    Westhill Business Park
    Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House, Mosscroft Avenue
    Scotland
    31 мар. 2017 г.
    Westhill Business Park
    Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House, Mosscroft Avenue
    Scotland
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииScotland
    Юридическое основаниеUnited Kingdom (Scotland)
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номерSc558821
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.
    Mr Stewart Milne
    Baillieswells Road, Bieldside
    AB15 9BQ Aberdeen
    Dalhebity House
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    Baillieswells Road, Bieldside
    AB15 9BQ Aberdeen
    Dalhebity House
    United Kingdom
    Да
    Гражданство: British
    Страна проживания: Scotland
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.
    Mr Gary Stewart Milne
    Violet Place
    Newton Mearns
    G77 6FQ Glasgow
    2
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    Violet Place
    Newton Mearns
    G77 6FQ Glasgow
    2
    United Kingdom
    Да
    Гражданство: British
    Страна проживания: United Kingdom
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 25%, но не более 50% голосующих акций компании.
    Mr Michael William Milne
    Earlspark Avenue
    Bieldside
    AB15 9BU Aberdeen
    12
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    Earlspark Avenue
    Bieldside
    AB15 9BU Aberdeen
    12
    United Kingdom
    Да
    Гражданство: Scottish
    Страна проживания: Scotland
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 25%, но не более 50% голосующих акций компании.

    Есть ли у STEWART MILNE GROUP LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 06 мар. 2023 г.
    Поставлен 21 мар. 2023 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    29 wellington drive, aberdeen registered in the land register of scotland under title number KNC22838.
    Уполномоченные лица
    • Mcewan Properties Limited
    Транзакции
    • 21 мар. 2023 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 18 мар. 2021 г.
    Поставлен 30 мар. 2021 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    All and whole the subjects at schoolhill, portlethen, aberdeen shown outlined in red and coloured pink of the plan annexed to the instrument accompanying this MR01 being part and portion of all and whole the subject registered in the land register of scotland under title number KNC3125 (as more particularly described in the instrument evidencing the charge accompanying this MR01).
    Уполномоченные лица
    • Vion Food Group Limited (As Defined in the Instrument Evidencing the Charge Accompanying This MR01)
    Транзакции
    • 30 мар. 2021 г.Регистрация залога (MR01)
    • 09 сент. 2022 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 19 нояб. 2020 г.
    Поставлен 23 нояб. 2020 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    (First) all and whole the subjects registered in the land register of scotland under title number PTH16526 and (second) all and whole our one half pro indiviso share in the subjects registered in the land register of scotland under title numbers PTH34439, PTH37576, PTH36084 and PTH39094.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Almond Valley LTD
    Транзакции
    • 23 нояб. 2020 г.Регистрация залога (MR01)
    • 06 февр. 2023 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 12 нояб. 2020 г.
    Поставлен 23 нояб. 2020 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    (First) all and whole the subjects registered in the land register of scotland under title number PTH16526 and (second) all and whole our one half pro indiviso share in the subjects registered in the land register of scotland under title numbers PTH34439, PTH37576, PTH36084 and PTH39094.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Almond Valley LTD
    Транзакции
    • 23 нояб. 2020 г.Регистрация залога (MR01)
    • 06 февр. 2023 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 13 окт. 2020 г.
    Поставлен 15 окт. 2020 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    All and whole that area of ground at sauchen, inverurie shown delineated in red on the plan annexed to the standard security.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Уполномоченные лица
    • Kathleen Elizabeth Burr
    • Alison Burr or Harper
    • Brian Burr
    Транзакции
    • 15 окт. 2020 г.Регистрация залога (MR01)
    • 11 нояб. 2021 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 19 нояб. 2019 г.
    Поставлен 26 нояб. 2019 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    The area or piece of ground at the gardens at crathes, banchory, aberdeenshire, in the registration county of kincardine, known as plot number 13 the gardens at crathes which forms part and portion of all and whole the subjects registered in the land registere of scotland under title number KNC24381.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Уполномоченные лица
    • The Dickinson Trust Limited
    Транзакции
    • 26 нояб. 2019 г.Регистрация залога (MR01)
    • 23 нояб. 2021 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 07 июн. 2019 г.
    Поставлен 10 июн. 2019 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    The land at roften works, hooton heath with title numbers CH518548, CH130416 and CH250054.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 10 июн. 2019 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 21 нояб. 2018 г.
    Поставлен 23 нояб. 2018 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    The freehold property known as part of the land at roften works, hooton heath, wirral being the strip of land 2 metres in depth shown in green on plan 1 annexed to the charge and the land shown edged blue on plan 2 annexed to the charge and being the whole of the property registered at the land registry under title numbers CH518548, CH261482, CH130416 and CH250054 (please refer to the definition of "property" of the instrument for more information).
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Burford Delta Limited
    Транзакции
    • 23 нояб. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    • 06 сент. 2022 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 09 окт. 2018 г.
    Поставлен 16 окт. 2018 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    All and whole that area or piece of ground at charleston road, cove shown delineated in red on the plan marked ‘plan 1’ annexed and signed as relative to the security and which subjects are currently undergoing registration in the land register of scotland under title number KNC23694; together with (one) the whole fixtures and fittings pertaining thereto; (two) the parts, pertinents and privileges thereof; and (three) the chargor’s whole right, title and interest, present and future, therein and thereto.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Транзакции
    • 16 окт. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 11 сент. 2018 г.
    Поставлен 15 сент. 2018 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    4.0 hectares (10.06 acres) or thereby forming part of west hillhead, mauchline. Please refer to instrument for further details.
    Уполномоченные лица
    • Bryce Cunningham
    Транзакции
    • 15 сент. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 20 июл. 2018 г.
    Поставлен 25 июл. 2018 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    N/A.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Транзакции
    • 25 июл. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 14 июн. 2018 г.
    Поставлен 15 июн. 2018 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    All and whole the subjects at colinhill farm, strathaven registered in the land register of scotland under title number LAN235204.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 15 июн. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 25 апр. 2018 г.
    Поставлен 01 мая 2018 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    All and whole the subjects registered in the land register of scotland under title number GLA231425, being that plot or area of ground extending to 1.42 hectares or thereby and forming the site of the former st oswalds primary school, brunton street, glasgow being the subjects shown edged red on the plan annexed and signed relative to the standard security, which subjects form part and portion of (in the first place) all and whole the subjects in the county of glasgow described in contract of ground annual by the trustees of james bunten in favour of the school board of the parish of cathcart recorded in the division of the general register of sasines applicable to the county of renfrew on 24 may 1875 and (in the second place) all and whole the area of ground extending to 2.592 acres or thereby more particularly described in and disponed by disposition by mactaggart and mickel limited in favour of the corporation of the city of glasgow registered in the division of the general register of sasines applicable to the barony and regality of glasgow on 9 may 1957.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 01 мая 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 17 мар. 2018 г.
    Поставлен 27 мар. 2018 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    The two areas of ground situated at and forming part of the subjects known as the former st oswalds primary, brunton street, glasgow. For more details of the land charged, please refer to the written instrument.
    Уполномоченные лица
    • Glasgow City Council
    Транзакции
    • 27 мар. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 14 февр. 2018 г.
    Поставлен 20 февр. 2018 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    All and whole the property known as tranche 4, dargavel village, bishopton registered in the land register of scotland under title number REN146821.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Транзакции
    • 20 февр. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 08 февр. 2018 г.
    Поставлен 13 февр. 2018 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    All and whole those areas of ground shown delineated red on the plan annexed and signed as relative to this standard security which area of ground form part and portion of the subjects more particularly described in the feu disposition by henry james kennaway in favour of john craik deuchar and mrs elizabeth mary phillip or deuchar dated the fifteenth and recorded in the division of the general register of sasines applicable to the county of kincardine on the twentieth both days of may nineteen hundred and thirty-nine.
    Уполномоченные лица
    • Mrs Elizabeth Hederwick or Deuchar or Ross
    Транзакции
    • 13 февр. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    • 23 нояб. 2021 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 08 февр. 2018 г.
    Поставлен 13 февр. 2018 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    All and whole those areas of ground shown hatched green on the plan annexed and signed as relative to this standard security which areas of ground form part and portion of the subjects more particularly described in the feu disposition by henry james kennaway in favour of john craik deuchar and mrs elizabeth mary phillip or deuchar dated the fifteenth and recorded in the division of the general register of sasines applicable to the county of kincardine on the twentieth both days of may nineteen hundred and thirty-nine.
    Уполномоченные лица
    • Mrs Elizabeth Hederwick or Deuchar or Ross
    Транзакции
    • 13 февр. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 21 сент. 2017 г.
    Поставлен 03 окт. 2017 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    All and whole the subjects lying to the west of the roads from perth to ruthvenfield title to which is registered in the land register of scotland under title number PTH16526.
    Уполномоченные лица
    • Trustees of the Hc Pilkington Trust
    • Jonathan Henson as Trustee of the Hc Pilkington Trust
    • Anthony Bayliss as Trustee of the Hc Pilkington Trust
    • David Reid as Trustee of the Hc Pilkington Trust
    Транзакции
    • 03 окт. 2017 г.Регистрация залога (MR01)
    • 01 дек. 2020 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 21 сент. 2017 г.
    Поставлен 03 окт. 2017 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    All and whole the subjects lying to the west of the roads from perth to ruthvenfield title to which is registered in the land register of scotland under title number PTH16526.
    Уполномоченные лица
    • Trustees of the Hc Pilkington Trust
    • Jonathan Henson as Trustee of the Hc Pilkington Trust
    • Anthony Bayliss as Trustee of the Hc Pilkington Trust
    • David Reid as Trustee of the Hc Pilkington Trust
    Транзакции
    • 03 окт. 2017 г.Регистрация залога (MR01)
    • 01 дек. 2020 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 03 июл. 2017 г.
    Поставлен 12 июл. 2017 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    Colinhill farm, strathaven, LAN228225.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 12 июл. 2017 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 23 июн. 2017 г.
    Поставлен 27 июн. 2017 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    Subjects at brackenhill, hamilton being all and whole the subjects registered in the land register of scotland under title number LAN216338.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Транзакции
    • 27 июн. 2017 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 04 апр. 2017 г.
    Поставлен 12 апр. 2017 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    The subjects at redwood drive, peel park, east kilbride being the subjects registered in the land register of scotland under title number LAN198677.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Транзакции
    • 12 апр. 2017 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 04 апр. 2017 г.
    Поставлен 05 апр. 2017 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    All and whole the plot or area of ground at symington being the whole subjects registered in the land register under title number AYR107748.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Транзакции
    • 05 апр. 2017 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 31 мар. 2017 г.
    Поставлен 07 апр. 2017 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    The freehold property known as land and buildings lying to the west of arrowe park road, wirral as the same is registered at the land registry under title number MS633058.
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • Bank of Scotland PLC
    Транзакции
    • 07 апр. 2017 г.Регистрация залога (MR01)
    A registered charge
    Создан 29 мар. 2017 г.
    Поставлен 08 апр. 2017 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    Areas of ground at hillside schoolhill, portlethen extending to 98 hectares. KNC14898.
    Уполномоченные лица
    • The Trustees of the Lombard Merton Trust
    Транзакции
    • 08 апр. 2017 г.Регистрация залога (MR01)
    • 23 нояб. 2021 г.Удовлетворение залога (MR04)

    Есть ли у STEWART MILNE GROUP LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    08 янв. 2024 г.Начало управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Gavin George Scott Park
    The Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    Практик
    The Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    Adele Macleod
    The Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    Практик
    The Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    Matthew David Smith
    The Colmore Building, 20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    Практик
    The Colmore Building, 20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0