STADCO EUROPE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | STADCO EUROPE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00386527 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von STADCO EUROPE LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich STADCO EUROPE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | International House Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von STADCO EUROPE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| STADCO AUTOMATION LIMITED | 27. Sept. 2001 | 27. Sept. 2001 |
| CASTLE BROMWICH PRESSINGS LIMITED | 15. Juni 2001 | 15. Juni 2001 |
| STADCO AUTOMATION LIMITED | 01. März 1995 | 01. März 1995 |
| ALUMINIUM WINDOW CO.LIMITED | 29. März 1944 | 29. März 1944 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STADCO EUROPE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für STADCO EUROPE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. Sept. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark John Smith am 18. Apr. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Paul Fisher am 18. Apr. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW zum International House Siskin Parkway East Middlemarch Business Park Coventry CV3 4PE am 07. Okt. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Mark John Smith als Sekretär am 05. Sept. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Hayhurst als Sekretär am 05. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 19 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Mark John Smith als Direktor am 30. Nov. 2015 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Paul Fisher als Direktor am 30. Nov. 2015 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gregory Ian Macleod als Geschäftsführer am 30. Nov. 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Gordon Hussey als Geschäftsführer am 30. Nov. 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Stadco Queensway Hortonwood Telford Shropshire TF1 7LL zum Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW am 29. Dez. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von STADCO EUROPE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Mark John | Sekretär | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | 213570990001 | |||||||
| FISHER, Christopher Paul | Geschäftsführer | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | United Kingdom | British | 183747270001 | |||||
| SMITH, Mark John | Geschäftsführer | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | United Kingdom | British | 124719430001 | |||||
| ALLSEBROOK, Stephen David | Sekretär | Norbrook House Yockleton SY5 9PH Shrewsbury Shropshire | British | 42268010001 | ||||||
| HAYHURST, Michael | Sekretär | 5 Apollo Way CV34 6RW Warwick Tachbrook Park Warwickshire | British | 15201970002 | ||||||
| KYNASTON, Stephen Lloyd | Sekretär | Plas Onn Quinta Weston Rhyn SY10 7LW Oswestry Shropshire | British | 10529040001 | ||||||
| KYNASTON, Stephen Lloyd | Sekretär | Plas Onn Quinta Weston Rhyn SY10 7LW Oswestry Shropshire | British | 10529040001 | ||||||
| LINDER-PATTON, David Michael | Sekretär | 17 Park End Edgmond Park SY4 5ST Newport Shropshire | British | 43447380003 | ||||||
| YOUENS, Michael Arthur | Sekretär | 14 Westwood Drive The Mount SY3 8YB Shrewsbury Shropshire | British | 36008490001 | ||||||
| YOUENS, Michael Arthur | Sekretär | 14 Westwood Drive The Mount SY3 8YB Shrewsbury Shropshire | British | 36008490001 | ||||||
| YOUENS, Michael Arthur | Sekretär | 14 Westwood Drive The Mount SY3 8YB Shrewsbury Shropshire | British | 36008490001 | ||||||
| COOK, Jonathan Charles | Gesch äftsführer | The Backs 38 South Parade, Harbury CV33 9JE Leamington Spa Warwickshire | British | 72559760001 | ||||||
| HALL, John | Geschäftsführer | Charnes Hall ST21 6NP Eccleshall Staffordshire | British | 9819250001 | ||||||
| HALL, Richard Nicholas Congreve | Geschäftsführer | Hales Hall Hales TF9 2PP Market Drayton Shropshire | England | British | 9819260001 | |||||
| HUGHES, Mark Leonard William | Geschäftsführer | Pippin Lodge Church Road Snitterfield CV37 0LF Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 51202520001 | ||||||
| HUSSEY, David Gordon | Geschäftsführer | 5 Apollo Way CV34 6RW Warwick Tachbrook Park Warwickshire | England | British | 131639570002 | |||||
| HUSSEY, David Gordon | Geschäftsführer | Callingwood Lane Tatenhill DE13 9SH Burton-On-Trent Callingwood Hall Staffordshire United Kingdom | British | 131639570001 | ||||||
| KYNASTON, Stephen Lloyd | Geschäftsführer | Harlescott Lane Shrewsbury SY1 3AS Shropshire | United Kingdom | British | 10529040001 | |||||
| KYNASTON, Stephen Lloyd | Geschäftsführer | Plas Onn Quinta Weston Rhyn SY10 7LW Oswestry Shropshire | United Kingdom | British | 10529040001 | |||||
| MACLEOD, Gregory Ian | Geschäftsführer | 5 Apollo Way CV34 6RW Warwick Tachbrook Park Warwickshire | United Kingdom | Australian | 60518160005 | |||||
| MORRISS, Andrew Stuart | Geschäftsführer | Harlescott Lane Shrewsbury SY1 3AS Shropshire | England | British | 11643310001 | |||||
| MORRISS, Andrew Stuart | Geschäftsführer | Hillside Cottage Rasen Road Walesby LN8 3UW Market Rasen Lincolnshire | England | British | 11643310001 | |||||
| ROACHE, David John | Geschäftsführer | Fallowfield Badgers Lane CV35 0BY Lower Tysoe Warwickshire | United Kingdom | British | 40953790002 | |||||
| SMITH, Alastair Moray | Geschäftsführer | Ryecroft Stafford Road Great Bridgeford ST18 9SQ Stafford Staffordshire | British | 9819210001 | ||||||
| SWORD, John David | Geschäftsführer | Chivel OX7 5TR Chipping Norton Oxfordshire | England | British | 1600540001 | |||||
| WILLIS, David John | Geschäftsführer | Damson Cottage Highfields SY4 5UN Wem Shropshire | British | 51085590002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei STADCO EUROPE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadco Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat STADCO EUROPE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 29. Aug. 2013 Geliefert am 06. Sept. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Castle bromwich, fort parkway, fort dunlop, erdington,t/no: WM835446 & WM918474;. Land and buildings on the north side of harlescott lane, shrewsbury, t/no: SL100479; and. Unit a, fford y cain, cain valley trading estate, llanfyllin, t/no: WA725094, CYM389181 and CYM387145. (For details of all other property charged, please refer to the docs). Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 29. Aug. 2013 Geliefert am 04. Sept. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Castle bromwich fort parkway fort dunlop erdington t/no.WM835446 and WM918474. Land and buildings on the north side of harlescott lane shrewsbury t/no.SL100479. Unit a, fford y cain cain valley trading estate llanfyllin t/no.WA725094, CYM389181 and CYM387145. Land and buildings to the west side of queensway trench lock interchange hadley telford t/no.SL21563, SL81932 and SL96965. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Partnership interest pledge agreement | Erstellt am 23. Nov. 2005 Geliefert am 06. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any of the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben A pledge over the existing shares and all additional partnership interests in the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Nov. 2005 Geliefert am 01. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge agreement executed outside the united kingdom over property situated there | Erstellt am 18. Nov. 2005 Geliefert am 06. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any of the borrowers and the guarantors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben A pledge over: the shares and all additional future shares in the company together with all present and future ancillary rights and claims in particular dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0