CARILLION CONSTRUCTION LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CARILLION CONSTRUCTION LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Liquidation |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00594581 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
- Bau von Geschäftsgebäuden (41201) / Bauwesen
Wo befindet sich CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TARMAC CONSTRUCTION LIMITED | 29. Nov. 1957 | 29. Nov. 1957 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2017 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2018 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 07. Mai 2018 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 21. Mai 2018 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 07. Mai 2017 |
| Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 6 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 5 Seiten | NDISC | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , Crown House Birch Street, Wolverhampton, WV1 4JX, United Kingdom zum Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL am 17. Juli 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 3 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | NDISC | ||
Change of details for Carillion Plc as a person with significant control on 01. Okt. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , Carillion House 84 Salop Street, Wolverhampton, WV3 0SR zum Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL am 01. Okt. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 10 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 5 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 5 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 21 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 27 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 27 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 15 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 39 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 33 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 15 Seiten | NDISC | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 13 Seiten | NDISC | ||
Wer sind die Geschäftsführer von CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITZHUGH, Dirk Olaf | Sekretär | Beesdau House Mount Road Tettenhall Wood WV6 8HT Wolverhampton | British | 612090001 | ||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Sekretär | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 24075160004 | ||||||
| MAFFEI, Westley | Sekretär | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 235183600001 | |||||||
| MCCORMACK, James Joseph | Sekretär | Broome House Chapel Lane Knockin Heath SY10 8EB Oswestry Shropshire | British | 678610003 | ||||||
| MCEWAN, Euan | Sekretär | 2 Bradshaw Close The Fairways PE28 4UZ Brampton Cambridgeshire | British | 110597480001 | ||||||
| TAPP, Richard Francis | Sekretär | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 173852420001 | ||||||
| ADAM, Richard John | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 67133560004 | |||||
| BAKER, Bryan William | Geschäftsführer | Little Hales House Chetwynd Aston TF10 9AW Newport Shropshire | British | 12567920001 | ||||||
| BOORMAN, Derek, Sir | Geschäftsführer | Lower Rowling Goodnestone CT3 1QA Canterbury Kent | British | 62319660001 | ||||||
| BOOTH, Karen Jane | Geschäftsführer | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | United Kingdom | British | 192636860001 | |||||
| BOYES, Brian Chester | Geschäftsführer | Border Close The Crescent Woodlands Road Ashurst SO40 7AQ Southampton Hants | British | 11609460003 | ||||||
| BRYDEN, Gordon | Geschäftsführer | 20 Dumville Drive RH9 8NY Godstone Surrey | British | 53913100004 | ||||||
| GELSTON, John Richard | Geschäftsführer | 12 Longbridge Road WS14 9AL Lichfield Staffordshire | British | 9996190001 | ||||||
| GEORGEL, Brian | Geschäftsführer | Le Groeg 54 Clifton Road Tettenhall WV6 9AP Wolverhampton West Midlands | British | 8675730001 | ||||||
| GILL, Matthew Clement Hugh | Geschäftsführer | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | British | 160968480002 | |||||
| GIRLING, Christopher Francis | Geschäftsführer | 12 Spithead Close PO34 5AZ Seaview Isle Of Wight | British | 67125270002 | ||||||
| GREEN, Adam Richard | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 129918780001 | |||||
| HAYWARD, Alan | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 154549030001 | |||||
| HERZBERG, Francis Robin | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 52429400001 | |||||
| HOWSON, Richard John | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 147650310001 | |||||
| HURCOMB, David Stuart | Geschäftsführer | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | United Kingdom | British | 34516340004 | |||||
| KENNEDY, Francis Milne | Geschäftsführer | Aughton 36 St Albans Road RH2 9LN Reigate Surrey | British | 3792110001 | ||||||
| KHAN, Zafar Iqbal | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 195408780001 | |||||
| KIRK, Paul Robert | Geschäftsführer | 4 Beauchamp Gardens Myton Lane CV34 6QG Warwick Warwickshire | United Kingdom | British | 29144870002 | |||||
| LEDWIDGE, Joseph John | Geschäftsführer | 153 Sneyd Lane Essington WV11 2DX Wolverhampton | United Kingdom | British | 105384920001 | |||||
| LUMBY, Richard Gregg | Geschäftsführer | Yew Tree House West Felton SY11 4EQ Oswestry Shropshire | England | British | 65529640001 | |||||
| MASON, Terence Harold | Geschäftsführer | Stratton Court Long Common WV5 7AX Claverley Shropshire | England | British | 3741500002 | |||||
| MCDONOUGH, John | Geschäftsführer | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | Uk | British | 74536340007 | |||||
| MCEWAN, Euan | Geschäftsführer | 2 Bradshaw Close The Fairways PE28 4UZ Brampton Cambridgeshire | British | 110597480001 | ||||||
| MERCER, Emma Louise | Geschäftsführer | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | British | 163383420001 | |||||
| MILLS, Lee James | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 53951880001 | |||||
| MOORE, John | Geschäftsführer | 23 Hollington Way B90 4YD Solihull West Midlands | British | 84441190001 | ||||||
| MYATT, Christopher John | Geschäftsführer | High Clere 166 Oulton Road ST15 8DR Stone Staffordshire | England | British | 649790001 | |||||
| OSBORNE, Alan | Geschäftsführer | Windtridge 30 Ludlow Road WV16 5AF Bridgnorth Salop | England | British | 108956240001 | |||||
| PALMER, Martyn Charles | Geschäftsführer | Woodlands Church End, Bishampton WR10 2LT Pershore Worcestershire | United Kingdom | British | 203408350001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion Plc | 06. Apr. 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CARILLION CONSTRUCTION LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 09. Dez. 2016 Geliefert am 16. Dez. 2016 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 26. Juli 2011 Geliefert am 29. Juli 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Monies from time to time standing to the credit of a designated deposit account see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 13. Dez. 2007 Geliefert am 15. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £17,625.00 due or to become due from the company to | |
Kurze Angaben The rent deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 22. Nov. 2007 Geliefert am 28. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £17,037.50 due or to become due from the company to | |
Kurze Angaben Rent deposit of £17,037.50. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 22. Nov. 2007 Geliefert am 28. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £4,406.25 due or to become due from the company to | |
Kurze Angaben Rent deposit of £4,406.25. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 26. Jan. 2007 Geliefert am 31. Jan. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Monies from time to time standing to the credit of a designated deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 30. Juli 2002 Geliefert am 06. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The interest of the company in the account (as defined in the rent deposit deed). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 23. Aug. 1999 Geliefert am 07. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under clause 3 of the guarantee and additional fee agreement as defined | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all present and future shares and dividends by way of assignment the benefit to the company of the shareholders agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 23. Aug. 1999 Geliefert am 07. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under clause 3 of the guarantee and additional fee agreement as defined | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all present and future shares and dividends by way of assignment the benefit to the company of the shareholders agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 24. Dez. 1997 Geliefert am 07. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee to pay the success fee and/or observe its obligations under the guarantee and additional fee agreement dated 24 december 1997 | |
Kurze Angaben All present and future shares of baa-mcarthur/glen (mansfield) limited and/or baa-mcarthur/glen (swindon) limited and baa-mcarthur/glen (bridgend) limitedheld by or on behalf of the company and all dividends bonuses options etc in relation thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit deed | Erstellt am 19. Okt. 1994 Geliefert am 21. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement for lease dated 12TH september 1994 and a licence for alterations dated 19TH october 1994 | |
Kurze Angaben The sum of £2,000 deposited by the company with the chargee in accordance with the terms of the deed and any interest accrued thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security deposit agreement | Erstellt am 21. Feb. 1994 Geliefert am 24. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein acting together in a joint venture as translink joint venture to the chargee under the terms of a lease dated 21ST february 1994 and this agreement | |
Kurze Angaben The sum of £20,000 and all interest earned thereon deposited under the terms of the security deposit deed dated 21ST february 1994. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental trust deed | Erstellt am 26. Juni 1972 Geliefert am 07. Juli 1972 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Supplemental trust deed for securing debenture stock of tarmac LTD amounting to £2,750,000 | |
Kurze Angaben By way of floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental trust deed | Erstellt am 16. Dez. 1968 Geliefert am 16. Dez. 1968 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Third supplemental trust deed securing debenture stock of tarmac derby LTD amounting to £7,652,725 inclusive of £5,000,000 secured by a trust deed dated 05/10/64 and deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second supplemental trust deed | Erstellt am 17. Juli 1967 Geliefert am 17. Juli 1967 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Second supplemental trust deed for securing debenture stock of tarmac LTD amounting to £5,000,000 inclusive of £3,000,000 secured by two deeds dated 05/10/64 & 26/10/65 respectively | |
Kurze Angaben By way of floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental trust deed | Erstellt am 26. Okt. 1965 Geliefert am 09. Nov. 1965 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Supplemental trust deed for securing debenture stock of tarmac LTD amounting to £3,000,000 inclusive of £2,000,000 secured by a trust deed dated 05/10/64 | |
Kurze Angaben First floating charge by way of security for the repayment by tarmac LTD of the debenture stock mentioned in col.3 On the undertaking of the company and all its property and assets both present and future (including uncalled capital). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 05. Okt. 1964 Geliefert am 04. Okt. 1964 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £2,000,000 debenture stock of tarmac LTD | |
Kurze Angaben First floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CARILLION CONSTRUCTION LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Zwangsliquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0