DISTINCTIVE CLUBS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDISTINCTIVE CLUBS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00730625
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DISTINCTIVE CLUBS LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich DISTINCTIVE CLUBS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DISTINCTIVE CLUBS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis29. Sept. 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für DISTINCTIVE CLUBS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    10 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom New Castle House Castle Boulevard Nottingham Nottinghamshire NG7 1FT England am 01. Juli 2013

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Insolvenzbeschluss

    Resolution INSOLVENCY:Extraordinary Resolution ;- "In Specie"
    1 SeitenLIQ MISC RES

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 20. Juni 2013

    LRESSP

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Sept. 2012

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Kapitalaufstellung am 24. Mai 2013

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Share premium cancelled 16/05/2013
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Änderung der Details des Direktors für Mr Harry Willits am 19. Feb. 2013

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 71 Queensway London W2 4QH England am 15. Feb. 2013

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Sept. 2011

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 25. Sept. 2010

    5 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Diane Penfold als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Harry Willits als Direktor

    2 SeitenAP01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Ernennung von Gala Coral Properties Limited als Direktor

    2 SeitenAP02

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von DISTINCTIVE CLUBS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Sekretär
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    69240850005
    WILLITS, Harry Andrew
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish175965490001
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    76454320002
    GALA CORAL PROPERTIES LIMITED
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer3720332
    154706530001
    CHEATLE, Martyn David
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    British149874460001
    DIBBLE, Keith George
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    Sekretär
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    British82410610001
    NOBLE, Michael Jeremy
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    Sekretär
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    British32786810004
    SIMMONDS, Gordon Graham
    Flat 1 20 Harrington Gardens
    SW7 4LS London
    Sekretär
    Flat 1 20 Harrington Gardens
    SW7 4LS London
    British34446930003
    SINTON, Charles Blair Ritchie
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    Sekretär
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    British52292450003
    SMERDON, Leigh
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Sekretär
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Other89075910001
    BENNETT, Michael Daniel
    1 Baker Street
    W1M 1AA London
    Geschäftsführer
    1 Baker Street
    W1M 1AA London
    British71518290003
    BORG, Robert George Caesar
    12 Archer Street
    W1V 7UG London
    Geschäftsführer
    12 Archer Street
    W1V 7UG London
    British40722260002
    BRACKENBURY, Frederick Edwin John Gedge
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    Geschäftsführer
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    United KingdomBritish53682420001
    CHALK, Robert Clifford
    1 Mulroy Drive
    GU15 1LX Camberley
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Mulroy Drive
    GU15 1LX Camberley
    Surrey
    BritainBritish35401590001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Geschäftsführer
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    DAVEY, Johann Lesley
    71 Queensway
    W2 4QH London
    Geschäftsführer
    71 Queensway
    W2 4QH London
    British42372810002
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    One The Shires
    RG41 4SZ Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    One The Shires
    RG41 4SZ Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish21686380003
    GRIFFITHS, Jonathan
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    Geschäftsführer
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    British73691620003
    HARLEY, Susan Boyle
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish41384040001
    HASKER, Robert Charles
    12 Archer Street
    W1V 7HG London
    Geschäftsführer
    12 Archer Street
    W1V 7HG London
    British46747960001
    HAYWARD, Patrick Henry
    81 Queensway
    W2 4QY London
    Geschäftsführer
    81 Queensway
    W2 4QY London
    British52032550002
    HEMMINGS, Trevor James
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritish65090920001
    KELLY, John Michael
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish141916500001
    KENT-LEMON, Nigel William
    29 Queensdale Road
    W11 4SB London
    Geschäftsführer
    29 Queensdale Road
    W11 4SB London
    British6467990001
    LLOYD, Thomas Richard
    Little Foxwood 207 The Street
    Capel
    RH5 5ER Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Little Foxwood 207 The Street
    Capel
    RH5 5ER Dorking
    Surrey
    British66394670001
    LOVE, Andrew Michael
    1a Palace Gate
    Kensington
    W8 5LS London
    Geschäftsführer
    1a Palace Gate
    Kensington
    W8 5LS London
    British35693230002
    MATTINGLEY, Brian Roger
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    British22417130001
    NUNN, Philip Trevor
    79 Queensway
    W2 4QH London
    Geschäftsführer
    79 Queensway
    W2 4QH London
    British48144120002
    PAYNE, Ian Timothy
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    British78974110002
    PENFOLD, Diane June
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    United KingdomBritish59962430002
    QUINLAN, Timothy Edward
    121 Thorpe Bay Gardens
    Thorpe Bay
    SS1 3NW Southend On Sea
    Essex
    Geschäftsführer
    121 Thorpe Bay Gardens
    Thorpe Bay
    SS1 3NW Southend On Sea
    Essex
    EnglandBritish49553030001
    RAHA, Maryse
    10 Copse Wood Way
    HA6 2UE Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    10 Copse Wood Way
    HA6 2UE Northwood
    Middlesex
    French24036050001
    ROBERTS, Edward Matthew Giles
    Gala Group Limited
    New Castle House Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Gala Group Limited
    New Castle House Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    British100607290001
    ROSS, Alan Spencer
    1a Palace Gate
    Kensington
    W8 5LS London
    Geschäftsführer
    1a Palace Gate
    Kensington
    W8 5LS London
    British69823550001
    SIMMONDS, Gordon Graham
    Flat 1 20 Harrington Gardens
    SW7 4LS London
    Geschäftsführer
    Flat 1 20 Harrington Gardens
    SW7 4LS London
    British34446930003

    Hat DISTINCTIVE CLUBS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 11. Mai 2006
    Geliefert am 24. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 24. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 27. Okt. 2005
    Geliefert am 09. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 01. Sept. 2005
    Geliefert am 20. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H high street acton london t/no AGL114684, f/h high street aldershot hants t/no HP517737, f/h anchor road aldridge walsall t/no WM167521 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 11. Feb. 2005
    Geliefert am 18. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Senior Financeparties and the Mezzanine Finance Parties
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 17. März 2003
    Geliefert am 03. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party or any mezzanine finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including 196 piccadilly,london W1V 9LG; NGL770277; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston,London Branch,as Security Trustee for the Finance Parties and Themezzanine Finance Parties
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fifth supplemental and accession deed
    Erstellt am 21. Dez. 2000
    Geliefert am 11. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and liabilities (whether actual or contingent) which are at the date of the debenture or thereafter due owing or payable or expressed to be due owing or payable to any creditor (as defined) from or by any obligor (as defined) under or in connection with the facilities agreement,a hedging contract,the deposit agreement and charge on cash deposits or the debenture as such deeds and agreements may be amended or restated in the future
    Kurze Angaben
    High street london W3 8BR,the ritz high street aldershot hants,essoldo milburn r oad nothumberland the real property (as defined) all plant machinery and equipment all right title and interest in the investments described in the continuation to form 395,goodwill,book debts.policies of insurance and by way of first floating charge all property and assets of the company for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkas Security Agent and Trustee
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 01. Okt. 1993
    Geliefert am 19. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) under the terms of this charge and any of the financing documents (as therein defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 30. März 1992
    Geliefert am 14. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under clause 2.1 of the composite guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    See form 395 ref M709 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The William Hill Group Limited
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Mai 1993Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 20. Okt. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 27. März 1992
    Geliefert am 13. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the composite guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    (See form 395 ref M101 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank(Acting as Agent and Trustee for Itself and Each of the "Lenders" as Defined)
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Mai 1993Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 20. Okt. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 11. Nov. 1991
    Geliefert am 28. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility agreement dated 11TH november 1991
    Kurze Angaben
    See form 395 ref M115 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 28. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 01. Juli 1991
    Geliefert am 18. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the brent walker group PLC and certain of its subsidiaries to the chargee under the terms of the facility agreement dated 1ST july 1991
    Kurze Angaben
    (See doc M148 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 18. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 29. Sept. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 28. März 1991
    Geliefert am 17. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the brent walker group PLC and/or any other company named therein to the chargee under the terms of this deed
    Kurze Angaben
    (See doc M137 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank (As Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders as Defined)
    Transaktionen
    • 17. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 29. Mai 1993Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 20. Okt. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 28. März 1991
    Geliefert am 16. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from brent walker limited under the terms of the facility agreement dated 19/2/91 and this deed
    Kurze Angaben
    (See doc M168 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 29. Mai 1993Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 20. Okt. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 28. März 1991
    Geliefert am 16. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the brent walker group PLC under the terms of a standby facility agreement dated 15/11/90 and this deed
    Kurze Angaben
    (See doc M145 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 29. Sept. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 28. März 1991
    Geliefert am 16. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the brent walker group PLC and/or any other company named therein under the terms of the facility agreement dated 28/3/91 and this deed
    Kurze Angaben
    (See doc M122 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 29. Mai 1993Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 20. Okt. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat DISTINCTIVE CLUBS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. Dez. 2013Aufgelöst am
    20. Juni 2013Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jill Sandford
    Rivermead Court 7 Lewis Court Grove Park
    Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Praktiker
    Rivermead Court 7 Lewis Court Grove Park
    Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Patrick B Ellward
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Praktiker
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0