Martyn David CHEATLE
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Martyn |
Zweites Vornamen | David |
Nachname | CHEATLE |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 6 |
Zurückgetreten | 62 |
Gesamt | 68 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAWS PETROLEUM LIMITED | 28. Nov. 2012 | Aufgelöst | None | Geschäftsführer | Hermes Road WS13 6RH Lichfield Midlands House Staffordshire | England | British | |
LEICESTER CARRIAGE BUILDERS 2002 LIMITED | 19. März 2010 | Aufgelöst | Chief Executive | Geschäftsführer | Hermes Road WS13 6RH Lichfield Central House Staffordshire England | England | British | |
ILKESTON TRAVEL SERVICES LIMITED | 19. März 2010 | Aufgelöst | Chief Executive | Geschäftsführer | Hermes Road WS13 6RH Lichfield Central House Staffordshire England | England | British | |
ILKESTON MOTOR FINANCE LIMITED | 19. März 2010 | Aufgelöst | Chief Executive | Geschäftsführer | Hermes Road WS13 6RH Lichfield Central House Staffordshire England | England | British | |
MIDLANDS CO-OPERATIVE FINANCE LIMITED | 19. März 2010 | Aufgelöst | Chief Executive | Geschäftsführer | Central House, Hermes Road Lichfield WS13 6RH Staffordshire | England | British | |
ILKESTON CONSUMER CO-OPERATIVE SOCIETY PENSION TRUSTEES LIMITED | 04. Jan. 2007 | Aufgelöst | Chief Executive | Geschäftsführer | Hermes Road WS13 6RH Lichfield Central House Staffordshire England | England | British | |
JAMES RETAIL HOLDINGS LIMITED | 30. Sept. 2016 | 25. Apr. 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Hermes Road WS13 6RH Lichfield Central House Staffordshire England | England | British |
CENTRAL ENGLAND DERSINGHAM LIMITED | 30. Sept. 2016 | 25. Apr. 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Hermes Road WS13 6RH Lichfield Central House England | England | British |
YAXLEY FARM LIMITED | 01. Dez. 2013 | 25. Apr. 2019 | Aktiv | Chief Executive | Geschäftsführer | Hermes Road WS13 6RH Lichfield Central House Staffordshire | England | British |
MIDLANDS CO-OP GENERAL PARTNER LIMITED | 17. Mai 2012 | 25. Apr. 2019 | Aktiv | Chief Executive | Geschäftsführer | 65 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh Citypoint Scotland | England | British |
TERRY SMITH LIMITED | 19. März 2010 | 25. Apr. 2019 | Aktiv | Chief Executive | Geschäftsführer | Hermes Road WS13 6RH Lichfield Central House Staffordshire England | England | British |
METRO DISCOUNT STORES (MIDLANDS) LIMITED | 19. März 2010 | 25. Apr. 2019 | Aktiv | Chief Executive | Geschäftsführer | Hermes Road WS13 6RH Lichfield Central House Staffordshire England | England | British |
KEN IVES MOTORS (DERBY) LIMITED | 19. März 2010 | 25. Apr. 2019 | Aufgelöst | Chief Executive | Geschäftsführer | Hermes Road WS13 6RH Lichfield Central House Staffordshire England | England | British |
FEDERAL RETAIL AND TRADING SERVICES LIMITED | 02. Sept. 2014 | 05. Apr. 2019 | Aktiv | Chief Executive | Geschäftsführer | Hermes Road WS13 6RH Lichfield Central House Staffordshire England | England | British |
TCCT HOLDINGS UK LIMITED | 24. Okt. 2011 | 30. Nov. 2017 | Liquidation | Chief Executive | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6FZ Peterborough Westpoint England | England | British |
CEC OPTICAL LIMITED | 01. Dez. 2013 | 25. Sept. 2014 | Aktiv | Chief Executive | Geschäftsführer | Central House Hermes Road WS13 6RH Lichfield Central England Co-Operative Staffordshire England | England | British |
MONEYCORP CFX LIMITED | 19. März 2010 | 01. Okt. 2011 | Aktiv | Chief Executive | Geschäftsführer | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs | England | British |
CLOSE NUMBER 29 LIMITED | 19. März 2010 | 01. Okt. 2011 | Aufgelöst | Chief Executive | Geschäftsführer | c/o Thomas Cook Travel Head Office Coningsby Road Bretton PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambridgeshire | England | British |
BUZZ ENTERTAINMENT LIMITED | 06. Juli 1998 | 06. Aug. 2001 | Aktiv | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British | ||
BUZZ GROUP LIMITED | 29. Juli 1996 | 06. Aug. 2001 | Aktiv | Company Secretary | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British | |
PARKSIDE CLUBS (NOTTINGHAM) LIMITED | 20. Dez. 2000 | 06. Aug. 2001 | Aufgelöst | Company Secretary | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British | |
LYDIASHOURNE LIMITED | 20. Dez. 2000 | 06. Aug. 2001 | Aufgelöst | Company Secretary | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British | |
STAKIS LEISURE LIMITED | 20. Dez. 2000 | 06. Aug. 2001 | Aufgelöst | Company Secretary | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British | |
PATMOR LIMITED | 20. Dez. 2000 | 06. Aug. 2001 | Aufgelöst | Company Secretary | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British | |
CRANDMILL LIMITED | 20. Dez. 2000 | 06. Aug. 2001 | Aufgelöst | Company Secretary | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British | |
STAKIS CASINOS LIMITED | 20. Dez. 2000 | 06. Aug. 2001 | Aufgelöst | Company Secretary | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British | |
THE NORTH ROTUNDA CASINO LIMITED | 20. Dez. 2000 | 06. Aug. 2001 | Aufgelöst | Company Secretary | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British | |
VICTORIA CASINO LIMITED | 20. Dez. 2000 | 06. Aug. 2001 | Aufgelöst | Company Secretary | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British | |
STAKIS INNS LIMITED | 20. Dez. 2000 | 06. Aug. 2001 | Aufgelöst | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British | ||
DISTINCTIVE CLUBS LIMITED | 20. Dez. 2000 | 06. Aug. 2001 | Aufgelöst | Company Secretary | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British | |
REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED | 20. Dez. 2000 | 06. Aug. 2001 | Aufgelöst | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British | ||
EVENTDAY LIMITED | 20. Dez. 2000 | 06. Aug. 2001 | Aufgelöst | Company Secretary | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British | |
ALBINDENE (BARRACUDA) LIMITED | 20. Dez. 2000 | 06. Aug. 2001 | Aufgelöst | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British | ||
TORCHLIGHT UK LIMITED | 20. Dez. 2000 | 06. Aug. 2001 | Aufgelöst | Company Secretary | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British | |
GRAVITAS 1025 LIMITED | 20. Dez. 2000 | 06. Aug. 2001 | Aufgelöst | Company Secretary | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0