VICTORIA CASINO LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameVICTORIA CASINO LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00898336
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von VICTORIA CASINO LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich VICTORIA CASINO LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Suite A, 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VICTORIA CASINO LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis29. Sept. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für VICTORIA CASINO LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für VICTORIA CASINO LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    10 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * the Poynt 45 Wollaton Street Nottingham NG1 5FW* am 07. Juli 2014

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * New Castle House Castle Boulevard Nottingham Nottinghamshire NG7 1FT England* am 10. März 2014

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 03. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Cancel share prem a/c 29/01/2014
    RES13

    Erklärung der Unternehmensgegenstände

    3 SeitenCC04

    Beschlüsse

    Resolutions
    33 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschlüsse

    Re-transitional provisions & savings 20/08/2013
    RES13
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Sept. 2012

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Harry Willits am 19. Feb. 2013

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 71 Queensway London W2 4QH England* am 15. Feb. 2013

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Sept. 2011

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 25. Sept. 2010

    5 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Diane Penfold als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Harry Willits als Direktor

    2 SeitenAP01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von VICTORIA CASINO LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Sekretär
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    69240850005
    WILLITS, Harry Andrew
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish175965490001
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    76454320002
    GALA CORAL PROPERTIES LIMITED
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer3720332
    154706290001
    BOTTERILL, Sheila Mary
    1 Appledore Close
    Kingsthorpe
    NN2 8JG Northampton
    Northamptonshire
    Sekretär
    1 Appledore Close
    Kingsthorpe
    NN2 8JG Northampton
    Northamptonshire
    British11261450001
    CHEATLE, Martyn David
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    British149874460001
    HODGES, Simon
    Meadowbank 102 Crosshill Street
    Lennoxtown
    G66 7HQ Glasgow
    Lanarkshire
    Sekretär
    Meadowbank 102 Crosshill Street
    Lennoxtown
    G66 7HQ Glasgow
    Lanarkshire
    British66090970001
    MACKAY, William Donald
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    Sekretär
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    British796730001
    MILLER, John Ashley Laing
    18 Learmonth Gardens
    EH4 1HB Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    18 Learmonth Gardens
    EH4 1HB Edinburgh
    Midlothian
    British97666900001
    NOBLE, Michael Jeremy
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    Sekretär
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    British32786810004
    SINTON, Charles Blair Ritchie
    York House 14 Ashton Place
    SL6 4TA Maidenhead
    Berkshire
    Sekretär
    York House 14 Ashton Place
    SL6 4TA Maidenhead
    Berkshire
    British52292450002
    SMERDON, Leigh
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Sekretär
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Other89075910001
    CHISMAN, Ronald Neil
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    Geschäftsführer
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    United KingdomBritish780950001
    CHISMAN, Ronald Neil
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    Geschäftsführer
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    United KingdomBritish780950001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Geschäftsführer
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    DAVIS, Leonard Lewis
    3 Lake Walk
    Collingtree
    NN4 0NH Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    3 Lake Walk
    Collingtree
    NN4 0NH Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomEnglish19157470001
    DAVIS, Leonard Lewis
    3 Lake Walk
    Collingtree
    NN4 0NH Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    3 Lake Walk
    Collingtree
    NN4 0NH Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomEnglish19157470001
    DAVIS, Sarah Luise
    64 Wrentham Avenue
    Kensal Rise
    NW10 3HG London
    Geschäftsführer
    64 Wrentham Avenue
    Kensal Rise
    NW10 3HG London
    British56962430002
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish21686380006
    GRIFFITHS, Jonathan
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    Geschäftsführer
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    British73691620003
    HARLEY, Susan Boyle
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish41384040001
    KELLY, John Michael
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    Geschäftsführer
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    British56474600002
    MATTINGLEY, Brian Roger
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    British22417130001
    MCCARVILL, James
    37 Brightside Avenue
    Uddingston
    G71 7NF Glasgow
    Geschäftsführer
    37 Brightside Avenue
    Uddingston
    G71 7NF Glasgow
    British24036030002
    MCCARVILL, James
    37 Brightside Avenue
    Uddingston
    G71 7NF Glasgow
    Geschäftsführer
    37 Brightside Avenue
    Uddingston
    G71 7NF Glasgow
    British24036030002
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    British4855250001
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    British39465560001
    PAYNE, Ian Timothy
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    British78974110002
    PENFOLD, Diane June
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    United KingdomBritish59962430002
    SHINE, David
    The White House
    Wellingborough Road
    NN3 3HY Northampton
    Northants
    Geschäftsführer
    The White House
    Wellingborough Road
    NN3 3HY Northampton
    Northants
    British8824890001
    SHINE, David
    The White House
    Wellingborough Road
    NN3 3HY Northampton
    Northants
    Geschäftsführer
    The White House
    Wellingborough Road
    NN3 3HY Northampton
    Northants
    British8824890001
    SHINE, Martyn
    The Grange Kennel Terrace
    Brixworth
    NN6 9DL Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    The Grange Kennel Terrace
    Brixworth
    NN6 9DL Northampton
    Northamptonshire
    British78895540001
    SHINE, Martyn
    40 Wildern Lane
    East Hunsbury
    NN4 0SN Northampton
    Geschäftsführer
    40 Wildern Lane
    East Hunsbury
    NN4 0SN Northampton
    British78895540002
    SOWERBY, Richard Thomas Neville
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish47734920003
    STANLEY, Kate Emma
    5 The Barns
    West Leith
    HP23 6JJ Tring
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    5 The Barns
    West Leith
    HP23 6JJ Tring
    Hertfordshire
    British66637240001

    Hat VICTORIA CASINO LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 11. Mai 2006
    Geliefert am 24. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 24. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 27. Okt. 2005
    Geliefert am 09. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 01. Sept. 2005
    Geliefert am 20. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H high street acton london t/no AGL114684, f/h high street aldershot hants t/no HP517737, f/h anchor road aldridge walsall t/no WM167521 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 11. Feb. 2005
    Geliefert am 18. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Senior Financeparties and the Mezzanine Finance Parties
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 17. März 2003
    Geliefert am 03. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party or any mezzanine finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including (I) regent st,northampton NN1 2LA; NN44035; (ii) 21 thornley st,wolverhampton WV1 1JR; WM271335; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston,London Branch,as Security Trustee for the Finance Parties and Themezzanine Finance Parties
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fifth supplemental and accession deed
    Erstellt am 21. Dez. 2000
    Geliefert am 11. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and liabilities (whether actual or contingent) which are at the date of the debenture or thereafter due owing or payable or expressed to be due owing or payable to any creditor (as defined) from or by any obligor (as defined) under or in connection with the facilities agreement,a hedging contract,the deposit agreement and charge on cash deposits or the debenture as such deeds and agreements may be amended or restated in the future
    Kurze Angaben
    High street london W3 8BR,the ritz high street aldershot hants,essoldo milburn r oad nothumberland the real property (as defined) all plant machinery and equipment all right title and interest in the investments described in the continuation to form 395,goodwill,book debts.policies of insurance and by way of first floating charge all property and assets of the company for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkas Security Agent and Trustee
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. Sept. 1993
    Geliefert am 10. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the debenture
    Kurze Angaben
    Floating charge over all. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Agent for Itself and for the Banks (As Defined Therein)
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Dez. 1995Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 17. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. Sept. 1993
    Geliefert am 10. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the debenture
    Kurze Angaben
    Floating charge over all. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Stakis PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 11. Sept. 1992
    Geliefert am 21. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See doc ref M478C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Juni 1990
    Geliefert am 14. Juni 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the west side of regent square northampton northamptonshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juni 1990Registrierung einer Belastung
    • 07. Sept. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Juni 1990
    Geliefert am 11. Juni 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    116 ashburnham road northampton.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juni 1990Registrierung einer Belastung
    • 25. Aug. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Dez. 1988
    Geliefert am 09. Dez. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    51 south holme court, thorplands, northampton title no. NN67378.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 1988Registrierung einer Belastung
    • 28. Aug. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 1987
    Geliefert am 06. Okt. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a no 1 summerfield road, chapel ash, wolverhampton west midlands.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 1987Registrierung einer Belastung
    • 25. Aug. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Mai 1987
    Geliefert am 02. Juni 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Rubicon casi no 22 22 regent street northampton, northamptonshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1987Registrierung einer Belastung
    • 25. Aug. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Juni 1983
    Geliefert am 04. Juli 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 'layayette club' 21 thornley street wolverhampton west midlands.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 1983Registrierung einer Belastung
    • 07. Sept. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat VICTORIA CASINO LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    17. Okt. 2014Aufgelöst am
    27. Feb. 2014Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jill Sandford
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Nottinghamshire
    Praktiker
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Nottinghamshire
    Patrick B Ellward
    The Poynt
    45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Praktiker
    The Poynt
    45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0