HALLITE POLYTEK LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HALLITE POLYTEK LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01308929 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HALLITE POLYTEK LIMITED?
- Herstellung von Kunststoffen in Primärform (20160) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich HALLITE POLYTEK LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor Lowgate House Lowgate HU1 1EL Hull |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HALLITE POLYTEK LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HALLITE DEVELOPMENTS LIMITED | 31. Dez. 1980 | 31. Dez. 1980 |
| HALLITE BELLOWS LIMITED | 31. Dez. 1977 | 31. Dez. 1977 |
| TRUSHELFCO (NO. 134) LIMITED | 15. Apr. 1977 | 15. Apr. 1977 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HALLITE POLYTEK LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Aug. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HALLITE POLYTEK LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Jan. 2021 | 8 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Jan. 2020 | 8 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Hesslewood Country Office Park Ferriby Road Hessle East Yorkshire HU13 0PW zum C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor Lowgate House Lowgate Hull HU1 1EL am 06. Feb. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 08. Jan. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard William Hewlett als Geschäftsführer am 12. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Vijay Markanday als Geschäftsführer am 12. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr William John Pratt am 10. Sept. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Aug. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Aug. 2018 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. Aug. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr William John Pratt am 16. März 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Alan Davies als Geschäftsführer am 05. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Aug. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HALLITE POLYTEK LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADBURY, Debra | Sekretär | Lowgate House Lowgate HU1 1EL Hull C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor | British | 72879990002 | ||||||
| CALEY, Andrew Maitland | Geschäftsführer | Lowgate House Lowgate HU1 1EL Hull C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor | United Kingdom | British | 49060800002 | |||||
| PRATT, William John | Geschäftsführer | Lowgate House Lowgate HU1 1EL Hull C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor | United Kingdom | British | 194710300003 | |||||
| GILLETT, Christopher Joseph | Sekretär | White Lodge 12 Ashurst Road KT20 5EU Tadworth Surrey | British | 69961270001 | ||||||
| HARDACRE, Eian Clark | Sekretär | 6 Wilcot Close Bisley GU24 9DE Woking Surrey | British | 119450490001 | ||||||
| LYALL, Gordon John | Sekretär | Hildegarth New Yatt OX8 6TF Witney Oxfordshire | British | 15413660003 | ||||||
| MARKANDAY, Vijay | Sekretär | 20 Birchdale SL9 7JA Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 49523130001 | ||||||
| WELLER, Christopher | Sekretär | 3 Halfway Cottages Bath Road RG20 8NG Newbury Berkshire | British | 80664920001 | ||||||
| BENNETT, Peter Ian | Geschäftsführer | 24 Coulter Close Cuffley EN6 4RR Potters Bar Hertfordshire | British | 4154020001 | ||||||
| CHAFFIN, Peter | Geschäftsführer | The Croft 21 The Ridgeway TN10 4NH Tonbridge Kent | British | 1508410001 | ||||||
| DAVIES, Simon Alan | Geschäftsführer | 28 Stonebridge Field Eton SL4 6PS Windsor Berkshire | British | 44598860003 | ||||||
| GILLETT, Christopher Joseph | Geschäftsführer | White Lodge 12 Ashurst Road KT20 5EU Tadworth Surrey | Great Britain | British | 69961270001 | |||||
| HARDACRE, Eian Clark | Geschäftsführer | 6 Wilcot Close Bisley GU24 9DE Woking Surrey | England | British | 119450490001 | |||||
| HEWLETT, Richard William | Geschäftsführer | 34 Bradford Drive KT19 0AH Epsom Surrey | British | 59434460001 | ||||||
| HOWIE, Andrew Wright | Geschäftsführer | 4 Tregarth Place GU21 3JY Woking Surrey | British | 15413650001 | ||||||
| JONES, David Henry | Geschäftsführer | Neen Court DY14 0AH Neen Sollars Worcestershire | United Kingdom | British | 101383260001 | |||||
| KINGSNORTH, Robert Stanley | Geschäftsführer | The Dolphins 23 Kingsley Avenue GU15 2NA Camberley Surrey | British | 58131230001 | ||||||
| LYALL, Gordon John | Geschäftsführer | Hildegarth New Yatt OX8 6TF Witney Oxfordshire | British | 15413660003 | ||||||
| MARKANDAY, Vijay | Geschäftsführer | 20 Birchdale SL9 7JA Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 49523130001 | ||||||
| MUMFORD, Michael Charles | Geschäftsführer | Crookhaugh 3 Rydens Avenue KT12 3JB Walton On Thames Surrey | British | 18807630002 | ||||||
| PAVER, Michael | Geschäftsführer | 27 Cavendish Meads SL5 9TB Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 10035580002 | |||||
| PERRY, Richard John | Geschäftsführer | Hesslewood Country Office Park Ferriby Road HU13 0PW Hessle East Yorkshire | United Kingdom | British | 40260860002 | |||||
| RUBERY, Steven Henry | Geschäftsführer | 16 Whynot Lane SP10 3ES Andover Hampshire | British | 15413670001 | ||||||
| WELLER, Christopher | Geschäftsführer | 3 Halfway Cottages Bath Road RG20 8NG Newbury Berkshire | British | 80664920001 | ||||||
| WESTON, Peter Maurice | Geschäftsführer | 28 Curley Hill Road GU18 5YQ Lightwater Surrey | England | British | 112416950001 | |||||
| WILKINS, Christopher Stuart Henry | Geschäftsführer | Banktop House Hopton Lane Hopton ST18 0AH Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | 127017930001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HALLITE POLYTEK LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallite Limited | 06. Apr. 2016 | Hesslewood Country Office Park Ferriby Road HU13 0PW Hessle Unit 5 East Yorkshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat HALLITE POLYTEK LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 17. Sept. 1998 Geliefert am 22. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 31. Jan. 1994 Geliefert am 21. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the agreement (as defined in the original debenture) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 23. Feb. 1990 Geliefert am 13. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent & trustee for itself, the arranger & the banks (as defined in the original debenture being 2 debentures dated 27.7.89 & 1.9.89) an any account whatsoever under the terms of the agreement (as defined in the original debenture) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Sept. 1989 Geliefert am 05. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company as agent and trustee for itself, the arranger and for the danks under the terms of the agreement and ancilliary facility and/or any other security documents | |
Kurze Angaben (For full details see doc. M372).. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & second debenture | Erstellt am 25. Aug. 1989 Geliefert am 05. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility agreement dated 27/7/89 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & second debenture | Erstellt am 27. Juli 1989 Geliefert am 17. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See doc for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & second debenture | Erstellt am 27. Juli 1989 Geliefert am 07. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from and/or all or any of the other companies named therein under the terms of a mezzanine loan agreement dated 27TH july 1989 and the deed. The company to the chargee. | |
Kurze Angaben (See form 395 - ref M541C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Juli 1989 Geliefert am 07. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as agrent and trustee for itself the arrange and for the banks) on any account whatsoever under the terms of a facility agreement dated 27.7.89, the ancillary facility and the security documents (as defined in the facility agreement). | |
Kurze Angaben For further details see doc M106).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat HALLITE POLYTEK LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0