CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Liquidation |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01521006 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 4 Abbey Orchard Street SW1P 2HT London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES GROUP LIMITED | 31. Dez. 2001 | 31. Dez. 2001 |
| KENNEDY CONSTRUCTION GROUP LIMITED | 08. Okt. 1980 | 08. Okt. 1980 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2017 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2018 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 17. Mai 2019 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 31. Mai 2019 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 17. Mai 2018 |
| Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geänderte Geschäftsanschrift vom Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom zum 4 Abbey Orchard Street London SW1P 2HT am 03. Okt. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR zum Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX am 01. Okt. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Change of details for Carillion (Am) Limited as a person with significant control on 01. Okt. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 2 Seiten | COCOMP | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Francis Tapp als Sekretär am 25. Juni 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lee James Mills als Geschäftsführer am 18. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel Paul Taylor als Geschäftsführer am 29. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen William Hudson als Geschäftsführer am 17. Apr. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nigel Paul Taylor am 17. März 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Stephen William Hudson am 02. März 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Lee James Mills am 02. März 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Richard Francis Tapp am 02. März 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 24 Birch Street Wolverhampton WV1 4HY zum Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR am 02. März 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Stephen William Hudson am 09. Aug. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATKINSON, Sarah Elizabeth | Sekretär | 13 Milverton Drive Bramhall SK7 1EY Stockport Cheshire | British | 53216670002 | ||||||
| FORSTER, Garry James | Sekretär | Pilgrim Cottage Path Hill RG8 7RE Goring Heath Oxfordshire | British | 38750850004 | ||||||
| HIGGINS, Caroline Patricia | Sekretär | Flat 10 7 Aubert Park N5 1TL London | British | 88102970001 | ||||||
| KIRKIN, Richard William | Sekretär | 2 Redwood Close Woolston WA1 4EH Warrington Cheshire | British | 1180700001 | ||||||
| LEE, Christopher Michael | Sekretär | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | British | 133709330001 | ||||||
| TAPP, Richard Francis | Sekretär | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 173852420001 | ||||||
| ATKINSON, Sarah Elizabeth | Geschäftsführer | 13 Milverton Drive Bramhall SK7 1EY Stockport Cheshire | British | 53216670002 | ||||||
| BODDINGTON, Richard Stewart | Geschäftsführer | Quercus House Winsford Road Cholmondeston CW7 4DP Winsford Cheshire | British | 15834890001 | ||||||
| CARNEY, Patrick | Geschäftsführer | 22 Carrwood Road SK9 5DL Wilmslow Cheshire | British | 27467650001 | ||||||
| CAROLAN, Peter Vincent | Geschäftsführer | 272 Leigh Road Worsley M28 1LF Manchester | Irish | 62299930001 | ||||||
| CARTER, Sholto Douglas Bowie | Geschäftsführer | 103 Appleby Road LA9 6HE Kendal Cumbria | British | 27715730002 | ||||||
| COCKER, Neil David | Geschäftsführer | 5 Rossett Close Kingsmead CW9 8WP Northwich Cheshire | England | British | 260158230001 | |||||
| COCLIFF, Stephen Jeffrey | Geschäftsführer | Coton Grange Coton Hill SY1 2PD Shrewsbury | England | British | 125427070002 | |||||
| DOUGHTY, Stuart John | Geschäftsführer | Bradley Farm House Kinlet DY12 3BU Bewdley Worcestershire | United Kingdom | British | 31394540001 | |||||
| GRICE, Ian Michael | Geschäftsführer | Heronshaw Oldbury Lane TN15 9DE Ightham Kent | United Kingdom | British | 44883010002 | |||||
| HOUGH, Robert Eric | Geschäftsführer | Manor House 10 Theobald Road WA14 3HG Bowdon Cheshire | England | British | 38776360001 | |||||
| HUDSON, Stephen William | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 78380050003 | |||||
| JACKSON, Andrew Philip | Geschäftsführer | 6 Sparvells Eversley RG27 0QG Hook Hampshire | England | British | 7921750002 | |||||
| JONES, Peter Rudulph | Geschäftsführer | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | Irish | 173952430001 | |||||
| KENNEDY, John Gerard | Geschäftsführer | 7 Rivershill Gardens Halebarns WA15 0AZ Altrincham Cheshire | Irish | 58803900001 | ||||||
| KENNEDY, Kathleen | Geschäftsführer | Brooks Drive WA15 8TL Hale Barns Cheshire | United Kingdom | Irish | 47720550002 | |||||
| KENNEDY, Patrick James | Geschäftsführer | Mayo Brooks Drive Halebarns WA15 8TL Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 47720560001 | |||||
| KIRKIN, Richard William | Geschäftsführer | 2 Redwood Close Woolston WA1 4EH Warrington Cheshire | England | British | 1180700001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Geschäftsführer | 2 West Grove SE10 8QT London Flat 3 | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| MEMMOTT, Robert William | Geschäftsführer | Oak Lodge 29 Stonyhurst Crescent Culcheth WA3 4DN Warrington Cheshire | British | 109306950001 | ||||||
| MILLS, Lee James | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 53951880001 | |||||
| PARSONS, James Christopher | Geschäftsführer | Chudleigh 34 Arthog Road Hale WA15 0LY Altrincham | British | 1180670002 | ||||||
| REID, John Watson | Geschäftsführer | The Laurels Park Gates Drive Cheadle Hulme SK8 7DF Cheadle Cheshire | England | British | 12949730002 | |||||
| ROBERTSON, Alan Robert | Geschäftsführer | Little Bote House Etherington Hill TN3 0TN Speldhurst Kent | British | 107595570001 | ||||||
| TAYLOR, Nigel Paul | Geschäftsführer | 40 Melton Street NW1 2FD London One Euston Square United Kingdom | United Kingdom | British | 162715410001 | |||||
| WILKINS, Andrew Michael | Geschäftsführer | PR25 | United Kingdom | British | 125411390001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion (Am) Limited | 06. Apr. 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Erstellt am 29. Aug. 1997 Geliefert am 10. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Subject lying to the southwest side of union street hamilton t/n-lan 95859. subjects lying on the northwest side of goil avenue bellshill t/n-LAN90356. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Aug. 1997 Geliefert am 16. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys, obligations and liabilities for the time being, owing or incurred by the obligors (as defined therein) to the chargee under or in connection with the finance documents (as defined therein) and/or on any other account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Cash collateral security | Erstellt am 13. Aug. 1997 Geliefert am 15. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Assign the charged account being the account of the company with the depository (being the royal bank of scotland international limited) which account is blocked or designated as charged to the bank and the deposit being all sums at the date of the cash collateral security or thereafter standing to the credit of the charged account together with all interest and other amounts accruing on such sums (in whatever currency) together with all the rights titles and benefits of the company whatsoever present and future therein. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Juni 1987 Geliefert am 22. Juni 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H-land and buildings to the south-east side of chaddock lane astley tyldesley wigan greater manchester title no gm 387045 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Juni 1987 Geliefert am 22. Juni 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H-land and buildings to the north west side of choddock lane tyldesley wigan greater manchester fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Okt. 1983 Geliefert am 07. Nov. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land forming park of mayo blooks drive halo barns trafford, gt manchester together with all fixture whatsoever now or at any time hereafter afflxed or attached to the property or any part therof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1978. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 27. Okt. 1981 Geliefert am 29. Okt. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing the sums due under a loan agreement dated 27 oct 1981 | |
Kurze Angaben Motor vehicles,daimler sovereign hba 71V daimler sovereign mnc 935W, rolls royce silver spirit dpm 1C. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Juli 1981 Geliefert am 18. Aug. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge undertaking and all property and all property and assetspresent and future including goodwill bookdebts uncalled capital & all fixtures & fittings (inc. Trade fixtures & fittings) fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Zwangsliquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0