A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameA.N.C. (SCOTLAND) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01762078
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Parkhouse East Industrial Estate
    Newcastle Under Lyme
    ST5 7RB Staffordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    5 Seiten4.71

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2013

    6 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Roel Jos Coleta Staes am 26. Juli 2013

    3 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    15 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Mai 2013

    Kapitalaufstellung am 21. Mai 2013

    • Kapital: GBP 8,100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2012

    6 SeitenAA

    Ernennung von Roel Jos Coleta Staes als Direktor am 03. Apr. 2012

    3 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    15 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Mark Russell Allen als Geschäftsführer am 30. März 2012

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2011

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    15 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2010

    6 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mark Russell Allen am 04. Sept. 2010

    3 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Robert Elliott als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Kenneth Koval als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    17 SeitenAR01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    2 SeitenAD02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2009

    6 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Robert William Elliott am 15. Dez. 2006

    1 SeitenCH01

    legacy

    7 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HAWKINS, James Edmund
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Sekretär
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    British101387860002
    PARROTT, Stephen John
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    Sekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British48941480002
    HOLT, Michael John
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    United KingdomBritish121123210001
    STAES, Roel Jos Coleta
    Kantersteen 47
    1000 Brussels
    Federal Express Europe, Inc
    Belgium
    Geschäftsführer
    Kantersteen 47
    1000 Brussels
    Federal Express Europe, Inc
    Belgium
    BelgiumBelgian170094650001
    DURACK, Sean Patrick
    4 Churchston Avenue
    Bramhall
    SK7 3DA Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    4 Churchston Avenue
    Bramhall
    SK7 3DA Stockport
    Cheshire
    British87327210001
    RONALD, Paul
    15 Arran Close
    Holmes Chapel
    CW4 7QP Crewe
    Cheshire
    Sekretär
    15 Arran Close
    Holmes Chapel
    CW4 7QP Crewe
    Cheshire
    British71473700001
    TAYLOR, Michael John
    6 Garratts Lane
    SM7 2DZ Banstead
    Surrey
    Sekretär
    6 Garratts Lane
    SM7 2DZ Banstead
    Surrey
    British64380001
    ALLEN, Mark Russell
    St.Goedeleplein 14
    1000 Brussels
    Federal Express Europe Inc.
    Belgium
    Geschäftsführer
    St.Goedeleplein 14
    1000 Brussels
    Federal Express Europe Inc.
    Belgium
    BelgiumUnited States77781820007
    CALLAGHAN, Andrew Michael
    Graybrook Farm
    Middlewich Road
    WA16 9JQ Allostock
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Graybrook Farm
    Middlewich Road
    WA16 9JQ Allostock
    Cheshire
    British76165950001
    CRANMER, Charles David
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    British60508750002
    ELLIOTT, Robert William
    B-1420 Braine L'Alleud
    Avenue Des Champs 2
    Belgium
    Geschäftsführer
    B-1420 Braine L'Alleud
    Avenue Des Champs 2
    Belgium
    American77782020004
    GITTINS, Jonathan Mark
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    British75431680002
    HAY, James Brian
    Fairways
    81 Allington Road Newick
    BN8 4ND Lewes
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Fairways
    81 Allington Road Newick
    BN8 4ND Lewes
    East Sussex
    British11163140001
    HENDERSON, John Iain
    12 Dale Street
    W4 2BL London
    Geschäftsführer
    12 Dale Street
    W4 2BL London
    British38376070001
    KOVAL, Kenneth Francis
    23 Rue Leon Lepage
    B1000 Brussels
    Belgium
    Geschäftsführer
    23 Rue Leon Lepage
    B1000 Brussels
    Belgium
    American118262180001
    MCCANN, Anthony Joseph
    12 Phillimore Gardens
    W8 7QD London
    Geschäftsführer
    12 Phillimore Gardens
    W8 7QD London
    British20509810002
    PYWELL, Christopher Graham
    Highfield Farm Cobbs Lane
    Hough
    CW2 5JL Crewe
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Highfield Farm Cobbs Lane
    Hough
    CW2 5JL Crewe
    Cheshire
    United KingdomBritish37719690005
    SUTTON, Timothy James
    Holly Bank
    Queensway
    Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Holly Bank
    Queensway
    Knutsford
    Cheshire
    British1278170001

    Hat A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee and fixed and floating security document
    Erstellt am 25. Sept. 2001
    Geliefert am 04. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future moneys debts and liabilities due (including the guaranteed liabilities) owing or incurred by a chargor to any finance party (including the chargee as security trustee for the finance parties) under or in connection with any finance document (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    Including premises at unit 6 marston gate development site station rd brogborough milton keynes beds, f/h interest in premises on the south side of parkhouse road east bradwell newcastle under lyme t/no.SF245317, premises at unit 3 watchmoor point camberley, the parkland buildings k/a tangent point central way park royal london NW10 and unit 41 parkhouse industrial estate rosevale road newcastle under lyme staffs. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 26. Mai 1995
    Geliefert am 09. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the deed
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC("the Security Trustee")
    Transaktionen
    • 09. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 26. Mai 1995
    Geliefert am 08. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to an instrument dated 26TH may 1995 constituting £19,000,000 8 per cent secured loan stock 2004 to be issued by broomco (910) limited
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Montagu Equity Limitedas Agent for the Holders from Time to Time of the Stock
    Transaktionen
    • 08. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 01. Juli 1988
    Geliefert am 08. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or stuntbrand limited (the 'agent'-as defined) for itself and as agent and trustee for the banks set out in the attached schedule here to under the the terms of the charge and the documents referred to therein
    Kurze Angaben
    Stocks shares see doc for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Creditorstalt Bank Verein
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    • Standard Chartered Bank
    • Barclays Bank PLC
    • Credit Lyonnais the Royal Bank of Scotland Plcand Any Other Bank Which May Assume Participation for the Purposes of the Acquisition Facility and/or the Working Capital Facilities.
    Transaktionen
    • 08. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 14. Jan. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 19. Mai 1986
    Geliefert am 22. Mai 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Mai 1986Registrierung einer Belastung
    Omnibus letter of set-off
    Erstellt am 19. Mai 1986
    Geliefert am 22. Mai 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank PLC.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Mai 1986Registrierung einer Belastung

    Hat A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. März 2014Beginn der Liquidation
    12. Feb. 2015Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0