• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Stephen John PARROTT

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameStephen
    Zweites VornamenJohn
    NachnamePARROTT
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv0
    Inaktiv10
    Zurückgetreten25
    Gesamt35

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    EDINBURGH DISTRIBUTION SERVICES LIMITED30. Juni 2009AufgelöstCompany SecretarySekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    NUMITOR LIMITED02. Juni 2008AufgelöstCompany SecretarySekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    A. N. C. (SOUTH YORKSHIRE) LIMITED28. März 2008AufgelöstCompany SecretarySekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    PRICE TRANSPORT GROUP LIMITED28. März 2008AufgelöstCompany SecretarySekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    PTG LIMITED28. März 2008AufgelöstCompany SecretarySekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    A.N.C. (NOTTINGHAM) LIMITED15. Dez. 2006AufgelöstBusiness ExecutiveSekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    ANC GROUP TRUSTEES LIMITED15. Dez. 2006AufgelöstBusiness ExecutiveSekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    ANC TRUSTEES NO. 2 LIMITED15. Dez. 2006AufgelöstBusiness ExecutiveSekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    ANC INTERNATIONAL LIMITED15. Dez. 2006AufgelöstBusiness ExecutiveSekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED15. Dez. 2006AufgelöstBusiness ExecutiveSekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    FEDERAL EXPRESS EUROPE INC.01. Nov. 200120. März 2017AktivBusiness ExecutiveGeschäftsführer
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    UkBritish
    FEDERAL EXPRESS FINANCE LIMITED09. Apr. 199620. März 2017LiquidationBusiness ExecutiveGeschäftsführer
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    UkBritish
    ANC HOLDINGS (1995) LIMITED15. Dez. 200628. Feb. 2017AktivBusiness ExecutiveSekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    ANC BUSINESS SERVICES LIMITED15. Dez. 200628. Feb. 2017AktivBusiness ExecutiveSekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    ANC GROUP LIMITED15. Dez. 200628. Feb. 2017AktivBusiness ExecutiveSekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    FEDEX UK LIMITED15. Dez. 200628. Feb. 2017AktivBusiness ExecutiveSekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    ANC HOLDINGS LIMITED17. Sept. 200728. Feb. 2017AufgelöstSekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    ANC LIMITED17. Sept. 200728. Feb. 2017AufgelöstSekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    ESPRIT IN-NIGHT EXPRESS LIMITED17. Sept. 200728. Feb. 2017AufgelöstSekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    FEDERAL EXPRESS FINANCE LIMITED09. Apr. 199628. Feb. 2017LiquidationFinancial ControllerSekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    FEDERAL EXPRESS (NI) LIMITED.15. März 201131. Dez. 2016LiquidationFinancial ControllerGeschäftsführer
    Bedford Street
    BT2 7FW Belfast
    50
    Northern Ireland
    EnglandBritish
    FEDEX (NI) LIMITED22. Juni 198931. Dez. 2016LiquidationSekretär
    C/O Cleaver Fulton Rankin
    50 Bedford Street
    BT2 7FW
    Belfast
    British
    FEDEX (NI) LIMITED22. Juni 198931. Dez. 2016LiquidationFinancial ControllerGeschäftsführer
    C/O Cleaver Fulton Rankin
    50 Bedford Street
    BT2 7FW
    Belfast
    EnglandBritish
    DENCOM FREIGHT HOLDINGS LIMITED16. Juli 197531. Dez. 2016LiquidationSekretär
    Bedford Street
    BT2 7FW Belfast
    50
    Northern Ireland
    British
    DENCOM FREIGHT HOLDINGS LIMITED16. Juli 197531. Dez. 2016LiquidationFinancial ControllerGeschäftsführer
    Bedford Street
    BT2 7FW Belfast
    50
    Northern Ireland
    EnglandBritish
    DENCOM INVESTMENTS LIMITED12. Juni 197331. Dez. 2016LiquidationSekretär
    C/O Cleaver Fulton Rankin
    50 Bedford Street
    BT2 7FW
    Belfast
    British
    DENCOM INVESTMENTS LIMITED12. Juni 197331. Dez. 2016LiquidationFinancial ControllerGeschäftsführer
    C/O Cleaver Fulton Rankin
    50 Bedford Street
    BT2 7FW
    Belfast
    EnglandBritish
    FEDERAL EXPRESS (NI) LIMITED.31. Dez. 2016LiquidationSekretär
    Bedford Street
    BT2 7FW Belfast
    50
    Northern Ireland
    British
    FEDEX UK SUPPLY CHAIN SERVICES LIMITED15. Dez. 200616. Dez. 2014AktivBusiness ExecutiveSekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    FEDEX UK HOLDINGS LIMITED15. Dez. 200616. Dez. 2014AktivBusiness ExecutiveSekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British
    FEDERAL EXPRESS (UK) PENSION TRUSTEES LIMITED08. März 199626. Nov. 2013AktivSekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    British
    FEDERAL EXPRESS (UK) PENSION TRUSTEES LIMITED08. Feb. 199626. Nov. 2013AktivBusiness ExecutiveGeschäftsführer
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    UkBritish
    FEDERAL EXPRESS (NI) LIMITED.15. März 2011LiquidationFinancial ControllerGeschäftsführer
    15 Riverview Croft
    The Shrubberies
    CV4 7HB Coventry
    England
    British
    MARCHAMONT ESTATES LIMITED09. Apr. 199608. Mai 1998AufgelöstFinancial ControllerSekretär
    15 Riverford Croft
    The Shrubberies
    CV4 7HB Coventry
    Midlands
    British
    MARCHAMONT ESTATES LIMITED09. Apr. 199608. Mai 1998AufgelöstFinancial ControllerGeschäftsführer
    15 Riverford Croft
    The Shrubberies
    CV4 7HB Coventry
    Midlands
    British

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0