CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED

CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCHEM-DRY FRANCHISING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02199693
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED?

    • Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche

    Wo befindet sich CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O FRP ADVISORY TRADING LIMITED
    4th Floor Abbey House 32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CHEM-DRY NORTHERN & SOUTHERN LIMITED22. Feb. 199622. Feb. 1996
    CHEM-DRY NORTHERN LIMITED01. Feb. 198801. Feb. 1988
    TANSLING LIMITED27. Nov. 198727. Nov. 1987

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    29 SeitenAM23

    Beendigung der Bestellung von Stuart Pace als Geschäftsführer am 14. Dez. 2022

    1 SeitenTM01

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    34 SeitenAM10

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    3 SeitenAM06

    Vorschlag des Verwalters

    43 SeitenAM03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW United Kingdom zum 4th Floor Abbey House 32 Booth Street Manchester M2 4AB am 23. Jan. 2023

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA

    10 SeitenAM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Frp Advisory Trading Limited 4th Floor, Abbey House 32 Booth Street Manchester M2 4AB zum 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW am 06. Jan. 2023

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom zum C/O Frp Advisory Trading Limited 4th Floor, Abbey House 32 Booth Street Manchester M2 4AB am 17. Dez. 2022

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    3 SeitenAM01

    Erfüllung der Belastung 021996930018 vollständig

    1 SeitenMR04

    Änderung der Details des Direktors für Gold Round Limited am 25. Juli 2022

    1 SeitenCH02

    Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 25. Juli 2022

    2 SeitenPSC05

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2021

    26 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 21. Juli 2021

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2020

    24 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2020 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 18. Apr. 2016

    2 SeitenPSC05

    Beendigung der Bestellung von Alan Albert Horton als Geschäftsführer am 30. Juni 2020

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 29. Juni 2020

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    RJP SECRETARIES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer02989995
    61999120002
    GOLD ROUND LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer05687325
    149588400001
    DALES, Shirley
    27 South Parade
    Leven
    HU17 5LJ Beverley
    North Humberside
    Sekretär
    27 South Parade
    Leven
    HU17 5LJ Beverley
    North Humberside
    British10362760002
    FEWSTER, Kathleen
    27 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    North Humberside
    Sekretär
    27 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    North Humberside
    British12623000001
    HUTCHINSON, Angela Denise
    Southwold
    36 Greenstiles Lane
    HU14 3NH Swanland
    North Humberside
    Sekretär
    Southwold
    36 Greenstiles Lane
    HU14 3NH Swanland
    North Humberside
    British49658870002
    HUTCHINSON, Jonathan Mark
    Southwold
    36 Greenstiles Lane
    HU14 3NH Swanland
    North Ferriby
    Sekretär
    Southwold
    36 Greenstiles Lane
    HU14 3NH Swanland
    North Ferriby
    British35378250004
    MAUGHAN, Anna
    404 Chester Road
    Boldmere
    B73 5BS Sutton Coldfield
    Sekretär
    404 Chester Road
    Boldmere
    B73 5BS Sutton Coldfield
    British53071850001
    THOMAS, Caroline Emma Roberts
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    Sekretär
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    British154322040001
    WARD, Shirley
    27 South Parade
    Leven
    HU17 5LJ Beverley
    North Humberside
    Sekretär
    27 South Parade
    Leven
    HU17 5LJ Beverley
    North Humberside
    British10362760001
    ANNISON, Roger Neil
    19 Sackville Close
    HU17 8XF Beverley
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    19 Sackville Close
    HU17 8XF Beverley
    East Yorkshire
    British69954830003
    BELK, Andrew John
    Pen Plannau
    Moelfre
    SY10 7QL Llansilin
    North Wales
    Geschäftsführer
    Pen Plannau
    Moelfre
    SY10 7QL Llansilin
    North Wales
    British65603000003
    BELL, Jonathan
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish123082590001
    BENNETT, Martin John
    St Peters Church Lane
    WR9 7AN Droitwich
    St Peters Manor
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    St Peters Church Lane
    WR9 7AN Droitwich
    St Peters Manor
    Worcestershire
    EnglandBritish69181180003
    CARLISLE, Ian
    The Clock House
    West End Road Box End
    MK43 8RT Kempston Rural
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    The Clock House
    West End Road Box End
    MK43 8RT Kempston Rural
    Bedfordshire
    EnglandBritish146715900001
    DALES, Shirley
    27 South Parade
    Leven
    HU17 5LJ Beverley
    North Humberside
    Geschäftsführer
    27 South Parade
    Leven
    HU17 5LJ Beverley
    North Humberside
    British10362760002
    DAVISON, Jonathan Charles
    75 Megson Way
    Walkington
    HU17 8YA Beverley
    North Humberside
    Geschäftsführer
    75 Megson Way
    Walkington
    HU17 8YA Beverley
    North Humberside
    EnglandBritish54751860002
    DICKINSON, Louise
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish139480580001
    FEWSTER, David Murray
    27 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    North Humberside
    Geschäftsführer
    27 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    North Humberside
    British9381710001
    FEWSTER, Kathleen
    27 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    North Humberside
    Geschäftsführer
    27 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    North Humberside
    British12623000001
    HORTON, Alan Albert
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish182208240001
    HUDSON, Anthony Phillip
    151 Westella Road
    Kirkella
    HU10 7RN Hull
    North Humberside
    Geschäftsführer
    151 Westella Road
    Kirkella
    HU10 7RN Hull
    North Humberside
    EnglandBritish13603510001
    HUTCHINSON, Jonathan Mark
    7509 Dickenson Place
    V42 1JG Chilliwack Bc
    Canada
    Geschäftsführer
    7509 Dickenson Place
    V42 1JG Chilliwack Bc
    Canada
    British35378250005
    JOHNSTON, Iain
    3 Scholes Park Road
    YO12 6RE Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    3 Scholes Park Road
    YO12 6RE Scarborough
    North Yorkshire
    United KingdomUk702270001
    JOLLY, Adrian Richard
    268 Moorhouse Road
    HU5 5PL Hull
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    268 Moorhouse Road
    HU5 5PL Hull
    East Yorkshire
    United KingdomBritish87664160001
    LEE, Peter Francis
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish207608120001
    LEES, Stuart
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish70032700001
    LLOYD-JONES, Andrew Mark
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish149155620001
    PACE, Stuart
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    4th Floor Abbey House
    Geschäftsführer
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    4th Floor Abbey House
    EnglandBritish207506130003
    ROCKETT, Matthew Ian
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    BritishBritish146169560001
    ROCKETT, Matthew Ian
    Trent Walk
    Welton Grange
    HU15 1GF Brough
    7
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    Trent Walk
    Welton Grange
    HU15 1GF Brough
    7
    East Yorkshire
    BritishBritish146169560001
    SIMPSON DENT, Jonathan
    Carisbrook
    19 Briar Walk Putney
    SW15 6UD London
    Geschäftsführer
    Carisbrook
    19 Briar Walk Putney
    SW15 6UD London
    United KingdomBritish110396210002
    SIMPSON-DENT, Jonathan Andrew
    Briar Walk
    SW15 6UD London
    19
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Briar Walk
    SW15 6UD London
    19
    United Kingdom
    United KingdomBritish121064970001
    SMITH, Andrew John
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    Geschäftsführer
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    United KingdomBritish207506140001
    SMITH, Andrew John
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    UkBritish149018750001
    SMITH, Philip Norman
    44 Copandale Road
    HU17 7BW Beverley
    North Humberside
    Geschäftsführer
    44 Copandale Road
    HU17 7BW Beverley
    North Humberside
    British16903250003

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    18. Apr. 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUnited Kingdom
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer05687325
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer07200489
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 01. Sept. 2016
    Geliefert am 13. Sept. 2016
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Blackstar 2016 Limited
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 03. Juni 2016
    Geliefert am 17. Juni 2016
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Secure Trust Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 29. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 18. Apr. 2016
    Geliefert am 21. Apr. 2016
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Fcap Six Limited
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A composite guarantee and debenture
    Erstellt am 31. Jan. 2011
    Geliefert am 08. Feb. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Andrew Lloyd-Jones
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 26 june 2009
    Erstellt am 31. Jan. 2011
    Geliefert am 08. Feb. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 31. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 31. Jan. 2011
    Geliefert am 03. Feb. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    A composite guarantee and debenture
    Erstellt am 31. Juli 2010
    Geliefert am 07. Aug. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Evander Limited
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 02. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 30. Juli 2010
    Geliefert am 10. Aug. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 02. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juli 2010
    Geliefert am 05. Aug. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 02. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 24. Sept. 2009
    Geliefert am 14. Okt. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from ingleby (1823) limited to the noteholders on any account whatsoever and all other monies due or to become due from any charging company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the property and assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Jonathan Simpson-Dent (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 14. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 24. Sept. 2009
    Geliefert am 03. Okt. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 02. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debentures
    Erstellt am 24. Sept. 2009
    Geliefert am 02. Okt. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the note issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Dez. 2002
    Geliefert am 11. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Colonial house swinemoor lane beverley east riding of yorkshire with f/h title HS259370. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Dez. 2002
    Geliefert am 11. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Dez. 2002
    Geliefert am 11. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The land and buildings lying on the north east side of swinemoor lane beverley (k/a belprin house belprin road beverley east riding of yorkshire HU17 0LP) with freehold t/n YEA9405. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Jan. 1998
    Geliefert am 03. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a colonial house swinemoor lane beverley t/no HS259370. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 02. Jan. 1996
    Geliefert am 11. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Juni 1988
    Geliefert am 28. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC.
    Transaktionen
    • 28. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 28. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed & floating
    Erstellt am 07. Apr. 1988
    Geliefert am 11. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 10. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    06. Dez. 2022Beginn der Verwaltung
    14. Nov. 2023Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Goodall
    4th Floor Abbey House Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Praktiker
    4th Floor Abbey House Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Anthony Collier
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Praktiker
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0