CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02199693 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED?
- Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O FRP ADVISORY TRADING LIMITED 4th Floor Abbey House 32 Booth Street M2 4AB Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CHEM-DRY NORTHERN & SOUTHERN LIMITED | 22. Feb. 1996 | 22. Feb. 1996 |
| CHEM-DRY NORTHERN LIMITED | 01. Feb. 1988 | 01. Feb. 1988 |
| TANSLING LIMITED | 27. Nov. 1987 | 27. Nov. 1987 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 29 Seiten | AM23 | ||
Beendigung der Bestellung von Stuart Pace als Geschäftsführer am 14. Dez. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 34 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 3 Seiten | AM06 | ||
Vorschlag des Verwalters | 43 Seiten | AM03 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW United Kingdom zum 4th Floor Abbey House 32 Booth Street Manchester M2 4AB am 23. Jan. 2023 | 2 Seiten | AD01 | ||
Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA | 10 Seiten | AM02 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Frp Advisory Trading Limited 4th Floor, Abbey House 32 Booth Street Manchester M2 4AB zum 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW am 06. Jan. 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom zum C/O Frp Advisory Trading Limited 4th Floor, Abbey House 32 Booth Street Manchester M2 4AB am 17. Dez. 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Verwalters | 3 Seiten | AM01 | ||
Erfüllung der Belastung 021996930018 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Änderung der Details des Direktors für Gold Round Limited am 25. Juli 2022 | 1 Seiten | CH02 | ||
Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 25. Juli 2022 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2021 | 26 Seiten | AA | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 21. Juli 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2020 | 24 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 18. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Beendigung der Bestellung von Alan Albert Horton als Geschäftsführer am 30. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 29. Juni 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJP SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom |
| 61999120002 | ||||||||||
| GOLD ROUND LIMITED | Geschäftsführer | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom |
| 149588400001 | ||||||||||
| DALES, Shirley | Sekretär | 27 South Parade Leven HU17 5LJ Beverley North Humberside | British | 10362760002 | ||||||||||
| FEWSTER, Kathleen | Sekretär | 27 Crawshaw Avenue HU17 7QW Beverley North Humberside | British | 12623000001 | ||||||||||
| HUTCHINSON, Angela Denise | Sekretär | Southwold 36 Greenstiles Lane HU14 3NH Swanland North Humberside | British | 49658870002 | ||||||||||
| HUTCHINSON, Jonathan Mark | Sekretär | Southwold 36 Greenstiles Lane HU14 3NH Swanland North Ferriby | British | 35378250004 | ||||||||||
| MAUGHAN, Anna | Sekretär | 404 Chester Road Boldmere B73 5BS Sutton Coldfield | British | 53071850001 | ||||||||||
| THOMAS, Caroline Emma Roberts | Sekretär | 5 Broomsleigh Street NW6 1QQ London | British | 154322040001 | ||||||||||
| WARD, Shirley | Sekretär | 27 South Parade Leven HU17 5LJ Beverley North Humberside | British | 10362760001 | ||||||||||
| ANNISON, Roger Neil | Geschäftsführer | 19 Sackville Close HU17 8XF Beverley East Yorkshire | British | 69954830003 | ||||||||||
| BELK, Andrew John | Geschäftsführer | Pen Plannau Moelfre SY10 7QL Llansilin North Wales | British | 65603000003 | ||||||||||
| BELL, Jonathan | Geschäftsführer | Swinemoor Lane HU17 0LS Beverley Colonial House East Yorkshire United Kingdom | England | British | 123082590001 | |||||||||
| BENNETT, Martin John | Geschäftsführer | St Peters Church Lane WR9 7AN Droitwich St Peters Manor Worcestershire | England | British | 69181180003 | |||||||||
| CARLISLE, Ian | Geschäftsführer | The Clock House West End Road Box End MK43 8RT Kempston Rural Bedfordshire | England | British | 146715900001 | |||||||||
| DALES, Shirley | Geschäftsführer | 27 South Parade Leven HU17 5LJ Beverley North Humberside | British | 10362760002 | ||||||||||
| DAVISON, Jonathan Charles | Geschäftsführer | 75 Megson Way Walkington HU17 8YA Beverley North Humberside | England | British | 54751860002 | |||||||||
| DICKINSON, Louise | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 139480580001 | |||||||||
| FEWSTER, David Murray | Geschäftsführer | 27 Crawshaw Avenue HU17 7QW Beverley North Humberside | British | 9381710001 | ||||||||||
| FEWSTER, Kathleen | Geschäftsführer | 27 Crawshaw Avenue HU17 7QW Beverley North Humberside | British | 12623000001 | ||||||||||
| HORTON, Alan Albert | Geschäftsführer | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | England | British | 182208240001 | |||||||||
| HUDSON, Anthony Phillip | Geschäftsführer | 151 Westella Road Kirkella HU10 7RN Hull North Humberside | England | British | 13603510001 | |||||||||
| HUTCHINSON, Jonathan Mark | Geschäftsführer | 7509 Dickenson Place V42 1JG Chilliwack Bc Canada | British | 35378250005 | ||||||||||
| JOHNSTON, Iain | Geschäftsführer | 3 Scholes Park Road YO12 6RE Scarborough North Yorkshire | United Kingdom | Uk | 702270001 | |||||||||
| JOLLY, Adrian Richard | Geschäftsführer | 268 Moorhouse Road HU5 5PL Hull East Yorkshire | United Kingdom | British | 87664160001 | |||||||||
| LEE, Peter Francis | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 207608120001 | |||||||||
| LEES, Stuart | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 70032700001 | |||||||||
| LLOYD-JONES, Andrew Mark | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 149155620001 | |||||||||
| PACE, Stuart | Geschäftsführer | 32 Booth Street M2 4AB Manchester 4th Floor Abbey House | England | British | 207506130003 | |||||||||
| ROCKETT, Matthew Ian | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | British | British | 146169560001 | |||||||||
| ROCKETT, Matthew Ian | Geschäftsführer | Trent Walk Welton Grange HU15 1GF Brough 7 East Yorkshire | British | British | 146169560001 | |||||||||
| SIMPSON DENT, Jonathan | Geschäftsführer | Carisbrook 19 Briar Walk Putney SW15 6UD London | United Kingdom | British | 110396210002 | |||||||||
| SIMPSON-DENT, Jonathan Andrew | Geschäftsführer | Briar Walk SW15 6UD London 19 United Kingdom | United Kingdom | British | 121064970001 | |||||||||
| SMITH, Andrew John | Geschäftsführer | High Street KT7 0SR Thames Ditton 2 A C Court Surrey England | United Kingdom | British | 207506140001 | |||||||||
| SMITH, Andrew John | Geschäftsführer | Swinemoor Lane HU17 0LS Beverley Colonial House East Yorkshire | Uk | British | 149018750001 | |||||||||
| SMITH, Philip Norman | Geschäftsführer | 44 Copandale Road HU17 7BW Beverley North Humberside | British | 16903250003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Round Limited | 18. Apr. 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Aghoco 1022 Limited | 06. Apr. 2016 | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 01. Sept. 2016 Geliefert am 13. Sept. 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 03. Juni 2016 Geliefert am 17. Juni 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 18. Apr. 2016 Geliefert am 21. Apr. 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Jan. 2011 Geliefert am 08. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 26 june 2009 | Erstellt am 31. Jan. 2011 Geliefert am 08. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Jan. 2011 Geliefert am 03. Feb. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Juli 2010 Geliefert am 07. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 30. Juli 2010 Geliefert am 10. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Juli 2010 Geliefert am 05. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 24. Sept. 2009 Geliefert am 14. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from ingleby (1823) limited to the noteholders on any account whatsoever and all other monies due or to become due from any charging company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the property and assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Sept. 2009 Geliefert am 03. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debentures | Erstellt am 24. Sept. 2009 Geliefert am 02. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the note issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Dez. 2002 Geliefert am 11. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Colonial house swinemoor lane beverley east riding of yorkshire with f/h title HS259370. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Dez. 2002 Geliefert am 11. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Dez. 2002 Geliefert am 11. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The land and buildings lying on the north east side of swinemoor lane beverley (k/a belprin house belprin road beverley east riding of yorkshire HU17 0LP) with freehold t/n YEA9405. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Jan. 1998 Geliefert am 03. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property k/a colonial house swinemoor lane beverley t/no HS259370. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 02. Jan. 1996 Geliefert am 11. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Juni 1988 Geliefert am 28. Juni 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed & floating | Erstellt am 07. Apr. 1988 Geliefert am 11. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CHEM-DRY FRANCHISING LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0