CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02388832 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| INNOVATIVE FRANCHISING LIMITED | 24. Mai 1989 | 24. Mai 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Change of details for Independent Group (Uk) Limited as a person with significant control on 06. Jan. 2023 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Beendigung der Bestellung von Rjp Secretaries Limited als Sekretär am 25. Jan. 2023 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Cossey Cosec Services Limited als Sekretär am 25. Jan. 2023 | 2 Seiten | AP04 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom zum 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW am 06. Jan. 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||
Notification of Independent Group (Uk) Limited as a person with significant control on 31. Okt. 2022 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Cessation of Aghoco 1022 Limited as a person with significant control on 31. Okt. 2022 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 25. Juli 2022 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Änderung der Details des Direktors für Gold Round Limited am 25. Juli 2022 | 1 Seiten | CH02 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2021 | 6 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 21. Juli 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2020 | 7 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Alan Albert Horton als Geschäftsführer am 30. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 29. Juni 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 18. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2019 | 7 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Rjp Secretaries Limited am 09. Aug. 2019 | 1 Seiten | CH04 | ||
Change of details for Aghoco 1022 Limited as a person with significant control on 09. Aug. 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 2 a C Court High Street Thames Ditton Surrey KT7 0SR England zum Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL am 12. Aug. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSSEY COSEC SERVICES LIMITED | Sekretär | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom |
| 302964180001 | ||||||||||
| PACE, Stuart | Geschäftsführer | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | England | British | 207506130003 | |||||||||
| GOLD ROUND LIMITED | Geschäftsführer | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom |
| 149588400001 | ||||||||||
| DALES, Shirley | Sekretär | 27 South Parade Leven HU17 5LJ Beverley North Humberside | British | 10362760002 | ||||||||||
| GARBETT, Anna Marie | Sekretär | 25 Tanhill Wilnecote B77 4LF Tamworth Staffordshire | British | 28626350001 | ||||||||||
| GREY, Elizabeth Jane | Sekretär | 6301 Vintage Oak Lane Salt Lake City Utah 84121 FOREIGN Usa | British | 13020220004 | ||||||||||
| JOHNSTON, Iain | Sekretär | 3 Scholes Park Road YO12 6RE Scarborough North Yorkshire | Uk | 702270001 | ||||||||||
| MAUGHAN, Anna | Sekretär | 404 Chester Road Boldmere B73 5BS Sutton Coldfield | British | 53071850001 | ||||||||||
| THOMAS, Caroline Emma Roberts | Sekretär | 5 Broomsleigh Street NW6 1QQ London | British | 154322040001 | ||||||||||
| RJP SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom |
| 61999120002 | ||||||||||
| ABBOTTS, Michael Anthony | Geschäftsführer | 40 Balmoral Road Four Oaks B74 4UE Sutton Coldfield West Midlands | British | 55787590001 | ||||||||||
| ANNISON, Roger Neil | Geschäftsführer | 19 Sackville Close HU17 8XF Beverley East Yorkshire | British | 69954830003 | ||||||||||
| BELK, Andrew John | Geschäftsführer | Pen Plannau Moelfre SY10 7QL Llansilin North Wales | British | 65603000003 | ||||||||||
| BELL, Jonathan | Geschäftsführer | Swinemoor Lane HU17 0LS Beverley Colonial House East Yorkshire United Kingdom | England | British | 123082590001 | |||||||||
| CARLISLE, Ian | Geschäftsführer | The Clock House West End Road Box End MK43 8RT Kempston Rural Bedfordshire | England | British | 146715900001 | |||||||||
| DALES, Shirley | Geschäftsführer | 27 South Parade Leven HU17 5LJ Beverley North Humberside | British | 10362760002 | ||||||||||
| DICKINSON, Louise | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 139480580001 | |||||||||
| GREY, Elizabeth Jane | Geschäftsführer | 6301 Vintage Oak Lane Salt Lake City Utah 84121 FOREIGN Usa | British | 13020220004 | ||||||||||
| GREY, Robin Francis | Geschäftsführer | 5272 Goldspring Place Chillingwalk FOREIGN British Colombia V 2r 373 Canada | British | 33733380005 | ||||||||||
| HORTON, Alan Albert | Geschäftsführer | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | England | British | 182208240001 | |||||||||
| JOHNSTON, Iain | Geschäftsführer | 3 Scholes Park Road YO12 6RE Scarborough North Yorkshire | United Kingdom | Uk | 702270001 | |||||||||
| JOLLY, Adrian Richard | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | United Kingdom | British | 87664160001 | |||||||||
| LEE, Peter Francis | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 207608120001 | |||||||||
| LEES, Stuart | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 70032700001 | |||||||||
| LLOYD-JONES, Andrew Mark | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 149155620001 | |||||||||
| ROCKETT, Matthew Ian | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | British | British | 146169560001 | |||||||||
| ROCKETT, Matthew Ian | Geschäftsführer | Trent Walk Welton Grange HU15 1GF Brough 7 East Yorkshire | British | British | 146169560001 | |||||||||
| SMITH, Andrew John | Geschäftsführer | High Street KT7 0SR Thames Ditton 2 A C Court Surrey England | United Kingdom | British | 207506140001 | |||||||||
| SMITH, Andrew John | Geschäftsführer | Swinemoor Lane HU17 0LS Beverley Colonial House East Yorkshire | Uk | British | 149018750001 | |||||||||
| SMITH, Robert John | Geschäftsführer | 16 Chelsea Drive Four Oaks B74 4UG Sutton Coldfield West Midlands | British | 109244130001 | ||||||||||
| TAYLOR, Mark Andrew | Geschäftsführer | Westlands Queensgate HU17 8NE Beverley | United Kingdom | British | 95264700003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independent Group (Uk) Limited | 31. Okt. 2022 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Gold Round Limited | 18. Apr. 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Aghoco 1022 Limited | 06. Apr. 2016 | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Gold Round Limited | 06. Apr. 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 5th Floor United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 01. Sept. 2016 Geliefert am 13. Sept. 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 03. Juni 2016 Geliefert am 17. Juni 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Jan. 2011 Geliefert am 08. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 26 june 2009 | Erstellt am 31. Jan. 2011 Geliefert am 08. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Jan. 2011 Geliefert am 03. Feb. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Juli 2010 Geliefert am 07. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 30. Juli 2010 Geliefert am 10. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Juli 2010 Geliefert am 05. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 24. Sept. 2009 Geliefert am 14. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from ingleby (1823) limited to the noteholders on any account whatsoever and all other monies due or to become due from any charging company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the property and assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Sept. 2009 Geliefert am 03. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debentures | Erstellt am 24. Sept. 2009 Geliefert am 02. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the note issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Juni 2000 Geliefert am 16. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 3 kettlebrook road tamworth stafforshire t/n's SF153292 and SF340069. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Nov. 1998 Geliefert am 13. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0