CRANDMILL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CRANDMILL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02475767 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CRANDMILL LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich CRANDMILL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Vernon House 23 Sicilian Avenue WC1A 2QS London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CRANDMILL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 29. Sept. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CRANDMILL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 19 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Aug. 2016 | 13 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Aug. 2016 | 13 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Fitzroy Square London W1T 5HP zum Vernon House 23 Sicilian Avenue London WC1A 2QS am 28. Sept. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Fitzroy Square London W1T 5HP zum 10 Fitzroy Square London W1T 5HP am 27. Aug. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Suite a, 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill Nottingham NG1 5FS zum 10 Fitzroy Square London W1T 5HP am 27. Aug. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Bescheinigung über die Abberufung des freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 4.38 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 01. Juli 2015 | 17 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 01. Juli 2014 | 15 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Rsm Tenon Restructuring the Poynt 45 Wollaton Street Nottingham NG1 5FW* am 07. Juli 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 3 Seiten | F10.2 | ||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 2 Seiten | F10.2 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * New Castle House Castle Boulevard Nottingham Nottinghamshire NG7 1FT England* am 08. Juli 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 6 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Sept. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 71 Queensway London W2 4QH England* am 15. Feb. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Sept. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 25. Sept. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Diane Penfold als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CRANDMILL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALA CORAL SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Glebe House Vicarage Drive IG11 7NS Barking Essex | 69240850005 | |||||||||||
| WILLITS, Harry Andrew | Geschäftsführer | 23 Sicilian Avenue WC1A 2QS London Vernon House | United Kingdom | British | 175965490001 | |||||||||
| GALA CORAL NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Queensway 71 Queensway W2 4QH London 71 England | 76454320002 | |||||||||||
| GALA CORAL PROPERTIES LIMITED | Geschäftsführer | Queensway W2 4QH London 71 England |
| 154706420001 | ||||||||||
| ALLARD, Tyrone James | Sekretär | Inis Smear Flemingston CF62 4QJ Barry South Glamorgan S Wales | British | 2343150002 | ||||||||||
| CHEATLE, Martyn David | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British | 149874460001 | ||||||||||
| HODGES, Simon | Sekretär | Meadowbank 102 Crosshill Street Lennoxtown G66 7HQ Glasgow Lanarkshire | British | 66090970001 | ||||||||||
| NOBLE, Michael Jeremy | Sekretär | Goathill Farm Well Hill Lane Well Hill BR6 7QJ Chelsfield Kent | British | 32786810004 | ||||||||||
| OSZTREICHER, George | Sekretär | 44 Mill Road Lisvane CF14 0XL Cardiff South Glamorgan | British | 38265400001 | ||||||||||
| SINTON, Charles Blair Ritchie | Sekretär | The Mill House Old Mill Lane SL6 2BG Bray Berkshire | British | 52292450003 | ||||||||||
| SMERDON, Leigh | Sekretär | 1 Cedar Grove The Hedgerows Great Wyrley WS6 6QH Walsall West Midlands | Other | 89075910001 | ||||||||||
| ALLARD, Tyrone James | Geschäftsführer | Inis Smear Flemingston CF62 4QJ Barry South Glamorgan S Wales | British | 2343150002 | ||||||||||
| CHISMAN, Ronald Neil | Geschäftsführer | 1 Beaufort Close SW15 3TL London | United Kingdom | British | 780950001 | |||||||||
| CRONK, John Julian Tristam | Geschäftsführer | Glebe House Vicarage Drive IG11 7NS Barking Essex | British | 6422100001 | ||||||||||
| GOULDEN, Neil Geoffrey | Geschäftsführer | One The Shires RG41 4SZ Wokingham Berkshire | England | British | 21686380003 | |||||||||
| GRIFFITHS, Jonathan | Geschäftsführer | 11 Pageant Crescent SE16 5FZ London | British | 73691620003 | ||||||||||
| HARLEY, Susan Boyle | Geschäftsführer | Threeways Gills Hill Lane WD7 8DD Radlett Hertfordshire | United Kingdom | British | 41384040001 | |||||||||
| JAMES, David Alan | Geschäftsführer | 6 Cliffside CF64 5RG Penarth South Glamorgan | British | 6644920001 | ||||||||||
| KELLY, John Michael | Geschäftsführer | New Castle House Castle Boulevard NG7 1FT Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 141916500001 | |||||||||
| LACEY, Richard Edward | Geschäftsführer | 33 Nettlecombe Avenue PO4 0QW Southsea Hampshire | United Kingdom | British | 23299890001 | |||||||||
| LAWRENCE, Raymond Geoffrey | Geschäftsführer | 54 Llyswen Road Cyncoed CF2 6PP Cardiff South Glamorgan | British | 14582770001 | ||||||||||
| MATTINGLEY, Brian Roger | Geschäftsführer | York House Kennedy Close SL7 3JA Marlow Buckinghamshire | British | 22417130001 | ||||||||||
| MCCARVILL, James | Geschäftsführer | 37 Brightside Avenue Uddingston G71 7NF Glasgow | British | 24036030002 | ||||||||||
| MICHELS, David Michael Charles | Geschäftsführer | 15 Court Drive HA7 4QH Stanmore Middlesex | British | 4855250001 | ||||||||||
| OSZTREICHER, George | Geschäftsführer | 44 Mill Road Lisvane CF14 0XL Cardiff South Glamorgan | United Kingdom | British | 38265400001 | |||||||||
| PAYNE, Ian Timothy | Geschäftsführer | The Elms 56 Avenue Road Dorridge B93 8JZ Solihull West Midlands | British | 78974110002 | ||||||||||
| PENFOLD, Diane June | Geschäftsführer | Queensway 71 Queensway W2 4QH London 71 England | United Kingdom | British | 59962430002 | |||||||||
| ROBERTS, Edward Matthew Giles | Geschäftsführer | Gala Group Limited New Castle House Castle Boulevard NG7 1FT Nottingham Nottinghamshire | British | 100607290001 | ||||||||||
| SANDERS, Philip John | Geschäftsführer | 11 Wentworth Road Bloxwich WS3 3UN Walsall West Midlands | British | 42425320001 | ||||||||||
| SOWERBY, Richard Thomas Neville | Geschäftsführer | Oakmead Farm Ockham Lane KT13 8EN Cobham Surrey | England | British | 47734920002 | |||||||||
| STANLEY, Kate Emma | Geschäftsführer | 5 The Barns West Leith HP23 6JJ Tring Hertfordshire | British | 66637240001 | ||||||||||
| WAGGETT, Colin | Geschäftsführer | 41 Spring Grove W4 3NH London | British | 62266600001 |
Hat CRANDMILL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating security document | Erstellt am 11. Mai 2006 Geliefert am 24. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 27. Okt. 2005 Geliefert am 09. Nov. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 01. Sept. 2005 Geliefert am 20. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H high street acton london t/no AGL114684, f/h high street aldershot hants t/no HP517737, f/h anchor road aldridge walsall t/no WM167521 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 11. Feb. 2005 Geliefert am 18. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 17. März 2003 Geliefert am 03. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party or any mezzanine finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Including 8-16 park chambers,park place,cardiff CF10 3DF; CYM5977; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fifth supplemental and accession deed | Erstellt am 21. Dez. 2000 Geliefert am 11. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys and liabilities (whether actual or contingent) which are at the date of the debenture or thereafter due owing or payable or expressed to be due owing or payable to any creditor (as defined) from or by any obligor (as defined) under or in connection with the facilities agreement,a hedging contract,the deposit agreement and charge on cash deposits or the debenture as such deeds and agreements may be amended or restated in the future | |
Kurze Angaben High street london W3 8BR,the ritz high street aldershot hants,essoldo milburn r oad nothumberland the real property (as defined) all plant machinery and equipment all right title and interest in the investments described in the continuation to form 395,goodwill,book debts.policies of insurance and by way of first floating charge all property and assets of the company for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CRANDMILL LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0