CRANDMILL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCRANDMILL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02475767
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CRANDMILL LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich CRANDMILL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Vernon House
    23 Sicilian Avenue
    WC1A 2QS London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CRANDMILL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis29. Sept. 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für CRANDMILL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    19 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Aug. 2016

    13 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Aug. 2016

    13 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Fitzroy Square London W1T 5HP zum Vernon House 23 Sicilian Avenue London WC1A 2QS am 28. Sept. 2016

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Fitzroy Square London W1T 5HP zum 10 Fitzroy Square London W1T 5HP am 27. Aug. 2015

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Suite a, 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill Nottingham NG1 5FS zum 10 Fitzroy Square London W1T 5HP am 27. Aug. 2015

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Bescheinigung über die Abberufung des freiwilligen Liquidators

    1 Seiten4.38

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 01. Juli 2015

    17 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 01. Juli 2014

    15 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Rsm Tenon Restructuring the Poynt 45 Wollaton Street Nottingham NG1 5FW* am 07. Juli 2014

    2 SeitenAD01

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * New Castle House Castle Boulevard Nottingham Nottinghamshire NG7 1FT England* am 08. Juli 2013

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Sept. 2012

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Mai 2013

    Kapitalaufstellung am 30. Mai 2013

    • Kapital: GBP 1,421,906
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 71 Queensway London W2 4QH England* am 15. Feb. 2013

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Sept. 2011

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 25. Sept. 2010

    5 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Diane Penfold als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von CRANDMILL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Sekretär
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    69240850005
    WILLITS, Harry Andrew
    23 Sicilian Avenue
    WC1A 2QS London
    Vernon House
    Geschäftsführer
    23 Sicilian Avenue
    WC1A 2QS London
    Vernon House
    United KingdomBritish175965490001
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    76454320002
    GALA CORAL PROPERTIES LIMITED
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer3720332
    154706420001
    ALLARD, Tyrone James
    Inis Smear
    Flemingston
    CF62 4QJ Barry
    South Glamorgan
    S Wales
    Sekretär
    Inis Smear
    Flemingston
    CF62 4QJ Barry
    South Glamorgan
    S Wales
    British2343150002
    CHEATLE, Martyn David
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    British149874460001
    HODGES, Simon
    Meadowbank 102 Crosshill Street
    Lennoxtown
    G66 7HQ Glasgow
    Lanarkshire
    Sekretär
    Meadowbank 102 Crosshill Street
    Lennoxtown
    G66 7HQ Glasgow
    Lanarkshire
    British66090970001
    NOBLE, Michael Jeremy
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    Sekretär
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    British32786810004
    OSZTREICHER, George
    44 Mill Road
    Lisvane
    CF14 0XL Cardiff
    South Glamorgan
    Sekretär
    44 Mill Road
    Lisvane
    CF14 0XL Cardiff
    South Glamorgan
    British38265400001
    SINTON, Charles Blair Ritchie
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    Sekretär
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    British52292450003
    SMERDON, Leigh
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Sekretär
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Other89075910001
    ALLARD, Tyrone James
    Inis Smear
    Flemingston
    CF62 4QJ Barry
    South Glamorgan
    S Wales
    Geschäftsführer
    Inis Smear
    Flemingston
    CF62 4QJ Barry
    South Glamorgan
    S Wales
    British2343150002
    CHISMAN, Ronald Neil
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    Geschäftsführer
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    United KingdomBritish780950001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Geschäftsführer
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    One The Shires
    RG41 4SZ Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    One The Shires
    RG41 4SZ Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish21686380003
    GRIFFITHS, Jonathan
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    Geschäftsführer
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    British73691620003
    HARLEY, Susan Boyle
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish41384040001
    JAMES, David Alan
    6 Cliffside
    CF64 5RG Penarth
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    6 Cliffside
    CF64 5RG Penarth
    South Glamorgan
    British6644920001
    KELLY, John Michael
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish141916500001
    LACEY, Richard Edward
    33 Nettlecombe Avenue
    PO4 0QW Southsea
    Hampshire
    Geschäftsführer
    33 Nettlecombe Avenue
    PO4 0QW Southsea
    Hampshire
    United KingdomBritish23299890001
    LAWRENCE, Raymond Geoffrey
    54 Llyswen Road
    Cyncoed
    CF2 6PP Cardiff
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    54 Llyswen Road
    Cyncoed
    CF2 6PP Cardiff
    South Glamorgan
    British14582770001
    MATTINGLEY, Brian Roger
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    British22417130001
    MCCARVILL, James
    37 Brightside Avenue
    Uddingston
    G71 7NF Glasgow
    Geschäftsführer
    37 Brightside Avenue
    Uddingston
    G71 7NF Glasgow
    British24036030002
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    British4855250001
    OSZTREICHER, George
    44 Mill Road
    Lisvane
    CF14 0XL Cardiff
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    44 Mill Road
    Lisvane
    CF14 0XL Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish38265400001
    PAYNE, Ian Timothy
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    British78974110002
    PENFOLD, Diane June
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    United KingdomBritish59962430002
    ROBERTS, Edward Matthew Giles
    Gala Group Limited
    New Castle House Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Gala Group Limited
    New Castle House Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    British100607290001
    SANDERS, Philip John
    11 Wentworth Road
    Bloxwich
    WS3 3UN Walsall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    11 Wentworth Road
    Bloxwich
    WS3 3UN Walsall
    West Midlands
    British42425320001
    SOWERBY, Richard Thomas Neville
    Oakmead Farm
    Ockham Lane
    KT13 8EN Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Oakmead Farm
    Ockham Lane
    KT13 8EN Cobham
    Surrey
    EnglandBritish47734920002
    STANLEY, Kate Emma
    5 The Barns
    West Leith
    HP23 6JJ Tring
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    5 The Barns
    West Leith
    HP23 6JJ Tring
    Hertfordshire
    British66637240001
    WAGGETT, Colin
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    Geschäftsführer
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    British62266600001

    Hat CRANDMILL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 11. Mai 2006
    Geliefert am 24. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 24. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 27. Okt. 2005
    Geliefert am 09. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 01. Sept. 2005
    Geliefert am 20. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H high street acton london t/no AGL114684, f/h high street aldershot hants t/no HP517737, f/h anchor road aldridge walsall t/no WM167521 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 11. Feb. 2005
    Geliefert am 18. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Senior Financeparties and the Mezzanine Finance Parties
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 17. März 2003
    Geliefert am 03. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party or any mezzanine finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including 8-16 park chambers,park place,cardiff CF10 3DF; CYM5977; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston,London Branch,as Security Trustee for the Finance Parties and Themezzanine Finance Parties
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fifth supplemental and accession deed
    Erstellt am 21. Dez. 2000
    Geliefert am 11. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and liabilities (whether actual or contingent) which are at the date of the debenture or thereafter due owing or payable or expressed to be due owing or payable to any creditor (as defined) from or by any obligor (as defined) under or in connection with the facilities agreement,a hedging contract,the deposit agreement and charge on cash deposits or the debenture as such deeds and agreements may be amended or restated in the future
    Kurze Angaben
    High street london W3 8BR,the ritz high street aldershot hants,essoldo milburn r oad nothumberland the real property (as defined) all plant machinery and equipment all right title and interest in the investments described in the continuation to form 395,goodwill,book debts.policies of insurance and by way of first floating charge all property and assets of the company for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkas Security Agent and Trustee
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CRANDMILL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    02. Juli 2013Beginn der Liquidation
    18. Okt. 2017Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Dilip K Dattani
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Praktiker
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Jill Sandford
    Rivermead Court 7 Lewis Court Grove Park
    Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Praktiker
    Rivermead Court 7 Lewis Court Grove Park
    Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Andrew Lawrence Hosking
    Quantuma Llp 10 Fitzroy Square
    W1T 5HP London
    Praktiker
    Quantuma Llp 10 Fitzroy Square
    W1T 5HP London
    Simon James Bonney
    10 Fitzroy Square
    W1T 5HP London
    Praktiker
    10 Fitzroy Square
    W1T 5HP London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0