YORKSHIRE COAST RADIO LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | YORKSHIRE COAST RADIO LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02775583 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von YORKSHIRE COAST RADIO LIMITED?
- Rundfunk (60100) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich YORKSHIRE COAST RADIO LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Media House Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von YORKSHIRE COAST RADIO LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für YORKSHIRE COAST RADIO LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Dez. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 46 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2020 bis 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Dez. 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 02. Okt. 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 14. Sept. 2020
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 20. Aug. 2020
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||
Ernennung von Bauer Group Secretariat Ltd als Sekretär am 20. Aug. 2020 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Sigsworth als Geschäftsführer am 20. Aug. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Richard Preece als Geschäftsführer am 20. Aug. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Preece als Sekretär am 20. Aug. 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 11 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mrs Deidre Ann Ford als Direktor am 20. Apr. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Sarah Jane Vickery als Direktor am 20. Apr. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von YORKSHIRE COAST RADIO LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUER GROUP SECRETARIAT LTD | Sekretär | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Mesdia House England |
| 270106790001 | ||||||||||
| FORD, Deidre Ann | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England | United Kingdom | British | 109666380002 | |||||||||
| KEENAN, Paul Anthony | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England | England | British | 243390510001 | |||||||||
| VICKERY, Sarah Jane | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England | England | British | 119137220004 | |||||||||
| BELL, Lynn | Sekretär | Cherry Lodge Highfield YO8 6DP Bubwith North Yorkshire | British | 57444830001 | ||||||||||
| BOOM, Caroline Virginia | Sekretär | Rose Cottage 61 Main Street Fulford YO1 4PN York North Yorkshire | British | 58048730001 | ||||||||||
| CHARTERS REID, Sarah Jane | Sekretär | 16 Millrace Close Norton YO17 9PF Malton North Yorkshire | British | 67973060001 | ||||||||||
| FENNELL, Andrew Phillip | Sekretär | Stanley Hill Avenue HP7 9BD Amersham 6 Buckinghamshire United Kingdom | English | 135981330001 | ||||||||||
| PREECE, Andrew | Sekretär | Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Carn Brea Studios Cornwall United Kingdom | 186615390001 | |||||||||||
| ROSE, Martyn Craig | Sekretär | 39a Limerston Street SW10 0BQ London | British | 75808040001 | ||||||||||
| RUSLING, Anne | Sekretär | 107 Woodland Drive Anlaby HU10 7HP Hull East Yorkshire | British | 17363260001 | ||||||||||
| TURNER, Robert Roger | Sekretär | The Beeches Melbourne YO42 4QJ York East Yorkshire | British | 5728340001 | ||||||||||
| TURNER, Robert Roger | Sekretär | The Beeches Melbourne YO42 4QJ York East Yorkshire | British | 5728340001 | ||||||||||
| WATERHOUSE, Ann Marguerite | Sekretär | Fairholme Reeds Lane Sayers Common BN6 9JG Hassocks West Sussex | British | 67890250005 | ||||||||||
| WELLS, Lynette Ann | Sekretär | Little Croft Maple Walk TN39 4SN Bexhill On Sea East Sussex | British | 98242040001 | ||||||||||
| WINN, Geoffrey Frank | Sekretär | Barmoor House Barmoor Scalby YO13 0PG Scarborough North Yorkshire | British | 3100340001 | ||||||||||
| WOODS, Sian | Sekretär | Studios Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Carn Brea Cornwall United Kingdom | British | 138145820001 | ||||||||||
| FIRST SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 72 New Bond Street W1S 1RR London | 900000780001 | |||||||||||
| BELL, Lynn | Geschäftsführer | Cherry Lodge Highfield YO8 6DP Bubwith North Yorkshire | British | 57444830001 | ||||||||||
| CARTER, Andrew John | Geschäftsführer | West End Cottage Blyth Road, Ranskill DN22 8LR Retford Nottinghamshire | British | 77093650001 | ||||||||||
| CHAPMAN, Ian Douglas | Geschäftsführer | 40 Westway Eastfield YO11 3ED Scarborough North Yorkshire | British | 27494690001 | ||||||||||
| DYSON, Elizabeth Ann | Geschäftsführer | 9 Hopefield Chase Meadow Walk Rothwell LS26 0XX Leeds Yorkshire | British | 75073980001 | ||||||||||
| FENNELL, Andrew Phillip | Geschäftsführer | Stanley Hill Avenue HP7 9BD Amersham 6 Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | English | 135981330001 | |||||||||
| HORTON, Gavin Tobias Alexander Winterbottom | Geschäftsführer | Whorlton Cottage Swainby DL6 3ER Northallerton North Yorkshire | United Kingdom | British | 6640640001 | |||||||||
| HUMM, Roger James | Geschäftsführer | Dinghurst Road Churchill BS25 5PJ Winscombe Westfield Orchard Avon | England | British | 29914990003 | |||||||||
| JACKSON, Timothy Walter Gaines | Geschäftsführer | Ashfield House Castleton YO21 2EN Whitby North Yorkshire | British | 1735110001 | ||||||||||
| LLOYD, Humphrey Alexander | Geschäftsführer | The Old Coach House Wycombe Road Studley Green HP14 3XB High Wycombe | British | 22345580004 | ||||||||||
| MACKENZIE, Alistair William | Geschäftsführer | 142 Widmore Road BR1 3BP Bromley | British | 38279630005 | ||||||||||
| MCCARTHY, Sarah Louise | Geschäftsführer | 4 Jubilee Terrace Scalby YO13 0NS Scarborough North Yorkshire | British | 33819790001 | ||||||||||
| MITCHELL, John Brian | Geschäftsführer | 1a The Park Scalby YO13 0PY Scarborough North Yorkshire | United Kingdom | British | 16958340002 | |||||||||
| MYERS, John Frederick | Geschäftsführer | 21 Middle Drive Darras Hal NE20 9DH Ponteland Northumberland | British | 70386430001 | ||||||||||
| ORCHARD, Stephen | Geschäftsführer | Clements Meadow Cross Lane SN8 1JZ Marlborough Wiltshire | England | British | 46952160003 | |||||||||
| PINDAR, George Thomas Ventress | Geschäftsführer | 10 High Street Scalby YO13 0PT Scarborough North Yorkshire | United Kingdom | British | 1020460001 | |||||||||
| PREECE, Andrew Richard | Geschäftsführer | Carn Brea Studios Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Ukrd Group Limited Cornwall United Kingdom | England | British | 158905700001 | |||||||||
| PROUDFOOT, Ian Andrew | Geschäftsführer | 2 Weaponess House 31 Deepdale Avenue YO11 2UF Scarborough North Yorkshire | British | 2460670001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei YORKSHIRE COAST RADIO LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrd Group Limited | 06. Apr. 2016 | Carn Brea Studios Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Ukrd Group Limited Cornwall England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat YORKSHIRE COAST RADIO LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 16. Juni 2006 Geliefert am 29. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Juni 1996 Geliefert am 26. Juni 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of charge | Erstellt am 10. März 1994 Geliefert am 16. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from minster sound radio PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any accounts of the company in the bank's books. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0