FIRST RADIO SALES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FIRST RADIO SALES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02795622 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FIRST RADIO SALES LIMITED?
- Werbeagenturen (73110) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich FIRST RADIO SALES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Media House Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FIRST RADIO SALES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| RADIO SALES LIMITED | 12. Nov. 2002 | 12. Nov. 2002 |
| CLEAR CHANNEL RADIO SALES LIMITED | 13. Juni 2000 | 13. Juni 2000 |
| KATZ INTERNATIONAL LIMITED | 06. Mai 1993 | 06. Mai 1993 |
| SABREMOUNT SERVICES LIMITED | 03. März 1993 | 03. März 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FIRST RADIO SALES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FIRST RADIO SALES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Jan. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 46 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2020 bis 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Jan. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 29. Juli 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Scott William Taunton als Geschäftsführer am 30. Apr. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Change of details for Ukrd Group Limited as a person with significant control on 30. Apr. 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Cessation of Wireless Group Media (Gb) Limited as a person with significant control on 30. Apr. 2020 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Preece als Geschäftsführer am 30. Apr. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Michael Buckland als Geschäftsführer am 30. Apr. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Preece als Sekretär am 30. Apr. 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Bauer Group Secretariat Ltd als Sekretär am 30. Apr. 2020 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Deidre Ann Ford als Direktor am 30. Apr. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Sarah Jane Vickery als Direktor am 30. Apr. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Anthony Keenan als Direktor am 30. Apr. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FIRST RADIO SALES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUER GROUP SECRETARIAT LTD | Sekretär | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England |
| 270106790001 | ||||||||||
| FORD, Deidre Ann | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England | United Kingdom | British | 109666380002 | |||||||||
| KEENAN, Paul Anthony | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England | England | British | 243390510001 | |||||||||
| VICKERY, Sarah Jane | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England | England | British | 119137220004 | |||||||||
| EMENY, Selina Holliday | Sekretär | 32 Defoe Avenue Kew TW9 4DT Richmond | British | 76404320001 | ||||||||||
| FENNELL, Andrew Phillip | Sekretär | Stanley Hill Avenue HP7 9BD Amersham 6 Buckinghamshire United Kingdom | English | 135981330001 | ||||||||||
| FENNELL, Andrew Phillip | Sekretär | Stanley Hill Avenue HP7 9BD Amersham 6 Buckinghamshire United Kingdom | English | 135981330001 | ||||||||||
| KILBY, Stuart Peter | Sekretär | 41 Bilberry Close Whitefield M45 8BL Manchester | British | 85175910001 | ||||||||||
| LAWLEY, Garth Anthony | Sekretär | Hurst Cottage Bradcutts Lane Cookham Dean SL6 9AB Maidenhead Berkshire | British | 52158790001 | ||||||||||
| MAUNDER, Timothy John | Sekretär | Dragons City Bledlow Ridge HP14 4AB High Wycombe Buckinghamshire | British | 62543060001 | ||||||||||
| MCARTHUR, Ronald James | Sekretär | 71 Ripplevale Grove Islington N1 1HS London | British | 32058430001 | ||||||||||
| MOORE, Debbie | Bevollmächtigter Sekretär | 71 Pitcairn House St Thomas's Square E9 6PU Hackney London | British | 900007470001 | ||||||||||
| PREECE, Andrew | Sekretär | Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Carn Brea Studios Cornwall United Kingdom | 186953630001 | |||||||||||
| SCHLAGMAN, Michael Edward | Sekretär | 56 Fitzalan Road Finchley N3 3PE London | British | 32752590002 | ||||||||||
| WELLS, Lynette Ann | Sekretär | Little Croft Maple Walk TN39 4SN Bexhill On Sea East Sussex | British | 98242040001 | ||||||||||
| WOODS, Sian | Sekretär | Studios Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Carn Brea Cornwall United Kingdom | British | 138145820001 | ||||||||||
| BELOYIANIS, James E | Geschäftsführer | 125 W55th Street New York 10019 Usa | American | 62884380001 | ||||||||||
| BOWLES, Howard | Geschäftsführer | Cleeve House Main Road HP27 0QN Lacey Green Buckinghamshire | Australian | 124988670001 | ||||||||||
| BROWN, Kevin Thomas | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 30 Harts Grove IG8 0BN Woodford Green Essex | England | British | 900008020001 | |||||||||
| BUCKLAND, James Michael | Geschäftsführer | Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Carn Brea Studios Cornwall United Kingdom | United Kingdom | British | 180975020001 | |||||||||
| CASTRO, Nicholas | Geschäftsführer | 18 Branscombe Gardens N21 3BN London | England | British | 39006500001 | |||||||||
| CONROY III, John Francis | Geschäftsführer | 2 Kings Yard Stanbridge Road SW15 1DE London | American | 73948560001 | ||||||||||
| DAMON, Robert | Geschäftsführer | 54 Quebec Drive Huntington Station New York 11746 Usa | American | 62884460001 | ||||||||||
| FENNELL, Andrew Phillip | Geschäftsführer | Stanley Hill Avenue HP7 9BD Amersham 6 Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | English | 135981330001 | |||||||||
| GOULAZIAN, Peter | Geschäftsführer | Katz Corporation 125 West 55th Street New York 10019 FOREIGN Usa | American | 35209690001 | ||||||||||
| GREENWALD, James | Geschäftsführer | 125 West 55th Treet New York New York State 10019 FOREIGN Usa | American | 35209700001 | ||||||||||
| LAWLEY, Garth Anthony | Geschäftsführer | Hurst Cottage Bradcutts Lane Cookham Dean SL6 9AB Maidenhead Berkshire | England | British | 52158790001 | |||||||||
| LLOYD, Humphrey Alexander | Geschäftsführer | The Old Coach House Wycombe Road Studley Green HP14 3XB High Wycombe | British | 22345580004 | ||||||||||
| LYNDS, Simon Walter | Geschäftsführer | Block 4 Flat 4r Portman Mansions Chiltern Street W1M 1LF London | British | 60221850002 | ||||||||||
| MACAULAY, Callum Roderick | Geschäftsführer | Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Carn Brea Studios Cornwall United Kingdom | United Kingdom | British | 182163470001 | |||||||||
| MACKENZIE, Alistair William | Geschäftsführer | 142 Widmore Road BR1 3BP Bromley | British | 38279630005 | ||||||||||
| MAROCCO, Michael J | Geschäftsführer | Sandler Media Group 767 5th Avenue 45th Floor New York 10153 FOREIGN Usa | American | 35209680001 | ||||||||||
| MCANN, John | Geschäftsführer | 175 Malone Road BT9 6TB Belfast County Antrim | British | 108977390001 | ||||||||||
| MCARTHUR, Ronald James | Geschäftsführer | 71 Ripplevale Grove Islington N1 1HS London | England | British | 32058430001 | |||||||||
| MYERS, John Frederick | Geschäftsführer | 21 Middle Drive Darras Hal NE20 9DH Ponteland Northumberland | British | 70386430001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FIRST RADIO SALES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wireless Group Media (Gb) Limited | 07. Juli 2016 | 401 Faraday Street Birchwood Park WA3 6GA Warrington Ground Floor United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Ukrd Group Limited | 06. Apr. 2016 | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat FIRST RADIO SALES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Erstellt am 19. Jan. 2004 Geliefert am 20. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben £22,783.25, an interest bearing account in the name of the tenant, the amount from time to time standing to the credit of the deposit account, all interest credited to the deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 19. Okt. 1999 Geliefert am 20. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from chancellor media corporation of los angeles (formerly known as evergreen media corp.of los angeles) and its subsidiaries to the chargee,the lenders and the issuing bank (each as defined in a second amended and restated loan agreement dated 25 april 1997) | |
Kurze Angaben All right,title and interest in and to 65% of all capital stock in katz television sales LTD and all stocks,shares,warrants,dividends,income,property,etc. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 19. Okt. 1999 Geliefert am 20. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from chancellor media corporation of los angeles (formerly known as evergreen media corp.of los angeles) and its subsidiaries to the chargee,the lenders and the issuing bank (each as defined in a second amended and restated loan agreement dated 25 april 1997) | |
Kurze Angaben All right,title and interest in and to 65% of all capital stock in katz radio sales LTD and all stocks,shares,dividends,income,property,etc. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 19. Okt. 1999 Geliefert am 20. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from chancellor media corporation of los angeles (formerly known as evergreen media corp.of los angeles) and its subsidiaries to the chargee,the lenders and the issuing bank (each as defined in a second amended and restated loan agreement dated 25 april 1997) | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to 65% of all capital stock in katz U.K.LTD and all stocks,shares,warrants,dividends,income,etc. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 19. Okt. 1999 Geliefert am 20. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from chancellor media corporation of los angeles (formerly known as evergreen media corp. Of los angeles) and its subsidiaries to the chargee,the lenders and the issuing bank (each as defined in a second amended and restated loan agreement dated 25 april 1997) | |
Kurze Angaben All right,title and interest in and to (I) 65% of the capital stock in independent radio sales LTD,(ii) all stocks,shares,warrants,options,dividends,interest,income and other benefits. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 24. Sept. 1993 Geliefert am 07. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date and the sum of £32,205 plus V.A.T. which may become due under clause 6.2.2. of the said lease | |
Kurze Angaben The sum of £71,190 together with any other sum paid into a specifically designated solicitors deposit account to be held by manches & co and interest credited to the said account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0