TESL REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTESL REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02830123
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TESL REALISATIONS LIMITED?

    • Beratung im Bereich Informationstechnologie (62020) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich TESL REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Deloitte Llp
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    West Midlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TESL REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TRINITY EXPERT SYSTEMS LIMITED02. Okt. 200702. Okt. 2007

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TESL REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für TESL REALISATIONS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für TESL REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 09. Apr. 2015

    33 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 09. Apr. 2015

    33 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 01. Okt. 2014

    28 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 09. Apr. 2014

    31 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    97 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    10 Seiten2.16B

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed trinity expert systems LIMITED\certificate issued on 23/10/13
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name23. Okt. 2013

    Beschluss zur Änderung der Firma am 10. Okt. 2013

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 1 the Oaks Westwood Way Coventry West Midlands CV4 8JB* am 21. Okt. 2013

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung am 07. Aug. 2013

    • Kapital: GBP 52,056.71
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2012

    18 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2011

    19 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2010

    19 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Facilities letters/guarantee/agreement/finance documents 06/06/2011
    RES13

    Beendigung der Bestellung von John Sunderland als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Andrew Came als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Andrew Came als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von John Sunderland als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von TESL REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CAME, Andrew
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    C/O Deloitte Llp
    West Midlands
    Sekretär
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    C/O Deloitte Llp
    West Midlands
    153342870001
    CAME, Andrew
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    C/O Deloitte Llp
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    C/O Deloitte Llp
    West Midlands
    EnglandBritish152251560001
    MCDONAGH, Stephen Anthony
    3 Alfred Close
    Middleton-On-Sea
    PO22 7UF Bognor Regis
    West Sussex
    Geschäftsführer
    3 Alfred Close
    Middleton-On-Sea
    PO22 7UF Bognor Regis
    West Sussex
    United KingdomIrish22036920004
    DOYLE, Mark Patrick
    2 Dene Hollow
    Kings Heath
    B13 0EL Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    2 Dene Hollow
    Kings Heath
    B13 0EL Birmingham
    West Midlands
    British4274670001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Bevollmächtigter Sekretär
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    SUNDERLAND, John Robert Nicholas
    4 Moreall Meadows
    Gibbet Hill
    CV4 7HL Coventry
    West Midlands
    Sekretär
    4 Moreall Meadows
    Gibbet Hill
    CV4 7HL Coventry
    West Midlands
    British61926560002
    COX, Peter Stephen
    2501 Stratford Road
    Hockley Heath
    B94 6NN Birmingham
    Geschäftsführer
    2501 Stratford Road
    Hockley Heath
    B94 6NN Birmingham
    British21184860001
    DOYLE, Mark Patrick
    39 Glendon Way
    Dorridge
    B93 8SY Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    39 Glendon Way
    Dorridge
    B93 8SY Solihull
    West Midlands
    British4274670002
    FLINT, Brendan Gerrard
    Jubilee Bungalow
    Snarestone
    Appleby Magna
    Swadlincote
    Geschäftsführer
    Jubilee Bungalow
    Snarestone
    Appleby Magna
    Swadlincote
    British39848580001
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001
    RIDGWAY, Brian
    Hongar House
    St Weonards
    HR2 8QL Hereford
    Geschäftsführer
    Hongar House
    St Weonards
    HR2 8QL Hereford
    British57912350001
    SUNDERLAND, John Robert Nicholas
    4 Moreall Meadows
    Gibbet Hill
    CV4 7HL Coventry
    West Midlands
    Geschäftsführer
    4 Moreall Meadows
    Gibbet Hill
    CV4 7HL Coventry
    West Midlands
    British61926560002
    WRIGHT, Martin Robert
    Lower House
    Wern Lane
    SY16 4EN Sarn
    Powys
    Geschäftsführer
    Lower House
    Wern Lane
    SY16 4EN Sarn
    Powys
    British60156600001

    Hat TESL REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Rent deposit deed
    Erstellt am 30. März 2006
    Geliefert am 12. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The sum of £55,095.00 and any further sums including payment into the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Arup Group Limited
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 15. Okt. 2004
    Erworben am 31. Okt. 2007
    Geliefert am 21. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all property present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (Formerly the Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2007Registrierung eines Erwerbs (400)
    Debenture
    Erstellt am 15. Okt. 2004
    Erworben am 31. Okt. 2007
    Geliefert am 21. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all property present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (Formerly the Governor and Company of the Bank of Scotland)
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2007Registrierung eines Erwerbs (400)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juni 2003
    Erworben am 31. Okt. 2007
    Geliefert am 21. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all property present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (Formerly the Governor and Company of the Bank of Scotland)
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2007Registrierung eines Erwerbs (400)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juni 2003
    Geliefert am 05. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 23. Juni 1999
    Geliefert am 02. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Nov. 1996
    Geliefert am 07. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat TESL REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Okt. 2013Beginn der Verwaltung
    09. Apr. 2015Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Dominic Lee Zoong Wong
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Praktiker
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Paul James Meadows
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Praktiker
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Matthew James Cowlishaw
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Praktiker
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0