Lesley Joyce GRAEME
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Lesley |
Zweites Vornamen | Joyce |
Nachname | GRAEME |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 9881 |
Gesamt | 9881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLEEN KUTT LIMITED | 22. Dez. 2005 | 22. Dez. 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
INTERIOR PROJECTS (KENT) LTD | 05. Dez. 2005 | 05. Dez. 2005 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
JOHN MASON FINANCIAL PLANNING LIMITED | 23. Nov. 2005 | 23. Nov. 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
JENLEA DESIGN DEVELOPMENTS LIMITED | 23. Nov. 2005 | 23. Nov. 2005 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BETTER PREPARED LIMITED | 21. Nov. 2005 | 21. Nov. 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WHATKITCHEN.COM LIMITED | 21. Nov. 2005 | 21. Nov. 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
STARPIM LIMITED | 21. Nov. 2005 | 21. Nov. 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CYGNET GIFTS LIMITED | 21. Nov. 2005 | 21. Nov. 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
M.B. PHYSIOTHERAPY LIMITED | 21. Nov. 2005 | 21. Nov. 2005 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ECO-WORKS LIMITED | 02. Nov. 2005 | 02. Nov. 2005 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
COLLEGE MEWS LIMITED | 28. Okt. 2005 | 28. Okt. 2005 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ABSINTHE ENTERPRISES LIMITED | 20. Okt. 2005 | 20. Okt. 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AVISO MARKETING COMMUNICATIONS LIMITED | 05. Okt. 2005 | 05. Okt. 2005 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THINK PURPLE LIMITED | 26. Sept. 2005 | 26. Sept. 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PAUL BOND INSTALLATIONS LIMITED | 21. Sept. 2005 | 21. Sept. 2005 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
KOBUS SERVICES LIMITED | 16. Sept. 2005 | 16. Sept. 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ANTARUS LIMITED | 30. Aug. 2005 | 30. Aug. 2005 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
RAMSAY ENTERPRISES LIMITED | 23. Aug. 2005 | 23. Aug. 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
G J PARKER LIMITED | 17. Aug. 2005 | 17. Aug. 2005 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
V E WRIGHT (HEALTH & SAFETY CONSULTANCY) LIMITED | 16. Aug. 2005 | 16. Aug. 2005 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
25 AUGUSTA GARDENS LIMITED | 15. Aug. 2005 | 15. Aug. 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
J S DAVEY LIMITED | 02. Aug. 2005 | 02. Aug. 2005 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
2 J'S TRAVEL LIMITED | 01. Aug. 2005 | 01. Aug. 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ORION FUTURE TECHNOLOGY LIMITED | 28. Juli 2005 | 28. Juli 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MEADOWBANK MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED | 22. Juli 2005 | 22. Juli 2005 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
H & P SECURE PARKING LIMITED | 21. Jan. 2005 | 05. Juli 2005 | Liquidation | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
C F CARPENTRY SERVICES LIMITED | 04. Juli 2005 | 04. Juli 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ROEFORD PROPERTIES LIMITED | 11. Jan. 2005 | 16. Juni 2005 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LONGSTONE HOLIDAY COTTAGES LTD | 06. Juni 2005 | 06. Juni 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WAINS TRANSPORT LIMITED | 03. Juni 2005 | 03. Juni 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CROWN CHAMBERS LIMITED | 07. Jan. 2005 | 31. Mai 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
NING LIMITED | 24. Dez. 2004 | 27. Mai 2005 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
UNIFRAME LIMITED | 20. Jan. 2005 | 13. Mai 2005 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
JUST CHILLING LIMITED | 12. Mai 2005 | 12. Mai 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HANDY BAG LIMITED | 12. Mai 2005 | 12. Mai 2005 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0