ANC BUSINESS SERVICES LIMITED

ANC BUSINESS SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameANC BUSINESS SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03049044
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ANC BUSINESS SERVICES LIMITED?

    • Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich ANC BUSINESS SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Parkhouse East Industrial Estate
    Newcastle Under Lyme
    ST5 7RB Staffordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ANC BUSINESS SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ANC GROUP LIMITED09. Juni 199509. Juni 1995
    BROOMCO (910) LIMITED24. Apr. 199524. Apr. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ANC BUSINESS SERVICES LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Mai 2023
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am29. Feb. 2024
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2022

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ANC BUSINESS SERVICES LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis13. Apr. 2024
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung27. Apr. 2024
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis13. Apr. 2023
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für ANC BUSINESS SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Feb. 2025

    7 SeitenLIQ03

    Beendigung der Bestellung von Roel Jos Coleta Staes als Geschäftsführer am 31. Jan. 2025

    1 SeitenTM01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 26. Feb. 2024

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    8 SeitenLIQ01

    Beendigung der Bestellung von Helena Jansson als Geschäftsführer am 11. Mai 2023

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Apr. 2023 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2022

    25 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Lawrence Trevor Hoyle als Geschäftsführer am 03. Jan. 2023

    1 SeitenTM01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 04. Okt. 2022

    • Kapital: GBP 25,615,635.79
    4 SeitenSH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Beschluss zur Kapitalisierung oder Ausgabe von Gratisaktien

    Capitalise £25,553,000 04/10/2022
    RES14
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Kapitalaufstellung am 11. Okt. 2022

    • Kapital: GBP 0.01
    3 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenSH20

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Cancel share prem a/c and capital redemption reserve 10/10/2022
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2021

    23 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2020

    23 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von James Alexander Davies als Direktor am 12. Juni 2020

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Justin Neil Clarke als Geschäftsführer am 12. Juni 2020

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2019

    23 SeitenAA

    Ernennung von Justin Neil Clarke als Direktor am 02. Dez. 2019

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von ANC BUSINESS SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HAWKINS, James Edmund
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Sekretär
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    BritishAccountant101387860002
    DAVIES, James Alexander
    Holly Lane
    CV9 2RY Atherstone
    Express House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Holly Lane
    CV9 2RY Atherstone
    Express House
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor270834780001
    DURACK, Sean Patrick
    4 Churchston Avenue
    Bramhall
    SK7 3DA Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    4 Churchston Avenue
    Bramhall
    SK7 3DA Stockport
    Cheshire
    British87327210001
    PARROTT, Stephen John
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    Sekretär
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    BritishBusiness Executive48941480002
    PYWELL, Christopher Graham
    Highfield Farm Cobbs Lane
    Hough
    CW2 5JL Crewe
    Cheshire
    Sekretär
    Highfield Farm Cobbs Lane
    Hough
    CW2 5JL Crewe
    Cheshire
    BritishFinance Director37719690005
    RONALD, Paul
    15 Arran Close
    Holmes Chapel
    CW4 7QP Crewe
    Cheshire
    Sekretär
    15 Arran Close
    Holmes Chapel
    CW4 7QP Crewe
    Cheshire
    BritishFinancial Controller71473700001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    ALLEN, Mark Russell
    St.Goedeleplein 14
    Brussels
    Federal Express Europe Inc.
    1000
    Belgium
    Geschäftsführer
    St.Goedeleplein 14
    Brussels
    Federal Express Europe Inc.
    1000
    Belgium
    BelgiumAmericanBusiness Executive77781820002
    CALLAGHAN, Andrew Michael
    Graybrook Farm
    Middlewich Road
    WA16 9JQ Allostock
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Graybrook Farm
    Middlewich Road
    WA16 9JQ Allostock
    Cheshire
    BritishManaging Director76165950001
    CLARKE, Justin Neil
    Parkhouse East Industrial Estate
    Newcastle Under Lyme
    ST5 7RB Staffordshire
    Geschäftsführer
    Parkhouse East Industrial Estate
    Newcastle Under Lyme
    ST5 7RB Staffordshire
    EnglandBritishSolicitor184467260002
    CONNELL, Richard Andrew
    Lower Roundhurst
    Tennyson's Lane Roundhurst
    GU27 3BN Haslemere
    Surrey
    Geschäftsführer
    Lower Roundhurst
    Tennyson's Lane Roundhurst
    GU27 3BN Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant102127970001
    COWAN, Geoffrey Alan
    26 Satinwood Close
    Gerrards Park
    WN4 9NL Ashton In Makerfield
    Lancashire
    Geschäftsführer
    26 Satinwood Close
    Gerrards Park
    WN4 9NL Ashton In Makerfield
    Lancashire
    BritishOperations Director77265020001
    CRANMER, Charles David
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    BritishFinance Director60508750002
    ELLIOTT, Robert William
    B-1420 Braine L'Alleud
    Avenue Des Champs 2
    Belgium
    Geschäftsführer
    B-1420 Braine L'Alleud
    Avenue Des Champs 2
    Belgium
    AmericanBusiness Executive77782020004
    GITTINS, Jonathan Mark
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    BritishCeo75431680002
    HAMMOND, Nigel Derek
    Rust Hall
    Langton Road
    TN3 0BB Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    Rust Hall
    Langton Road
    TN3 0BB Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishBanker117998050001
    HOLT, Michael John
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director121123210001
    HOYLE, Lawrence Trevor
    ST5 7RB Newcastle Under Lyme
    Parkhouse East Industrial Estate
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    ST5 7RB Newcastle Under Lyme
    Parkhouse East Industrial Estate
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Operations Director130938230003
    JACKSON, Edward Thomas
    Little West End Wistaston Green Road
    CW2 8SA Crewe
    Geschäftsführer
    Little West End Wistaston Green Road
    CW2 8SA Crewe
    BritishPersonnel Director37861110003
    JANSSON, Helena
    Kantersteen 47
    1000 Brussels
    Federal Express Europe, Inc
    Belgium
    Geschäftsführer
    Kantersteen 47
    1000 Brussels
    Federal Express Europe, Inc
    Belgium
    BelgiumSwedishBusiness Executive184103240001
    KOVAL, Kenneth Francis
    23 Rue Leon Lepage
    B1000 Brussels
    Belgium
    Geschäftsführer
    23 Rue Leon Lepage
    B1000 Brussels
    Belgium
    AmericanFinance Director118262180001
    MCCANN, Anthony Joseph
    12 Phillimore Gardens
    W8 7QD London
    Geschäftsführer
    12 Phillimore Gardens
    W8 7QD London
    BritishChief Executive20509810002
    MITCHELL, Mark
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    BritishBusiness Development Director62274000002
    PARR-DAVIES, Robin
    21 Greenways
    Walton On The Hill
    KT20 7QE Tadworth
    Surrey
    Geschäftsführer
    21 Greenways
    Walton On The Hill
    KT20 7QE Tadworth
    Surrey
    BritishCompany Director49509220001
    PYWELL, Christopher Graham
    Highfield Farm Cobbs Lane
    Hough
    CW2 5JL Crewe
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Highfield Farm Cobbs Lane
    Hough
    CW2 5JL Crewe
    Cheshire
    United KingdomBritishManaging Director37719690005
    STAES, Roel Jos Coleta
    Kantersteen 47
    1000 Brussels
    Federal Express Europe, Inc
    Belgium
    Geschäftsführer
    Kantersteen 47
    1000 Brussels
    Federal Express Europe, Inc
    Belgium
    BelgiumBelgianBusiness Executive/Attorney170094650001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ANC BUSINESS SERVICES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle-Under-Lyme
    .
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle-Under-Lyme
    .
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland & Wales
    RechtsgrundlageLaws Of England
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer4269215
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat ANC BUSINESS SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 02. Feb. 2006
    Geliefert am 10. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due up to a maximum of £8,000,000 from any group company to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited as 'Security Trustee'
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 02. Feb. 2006
    Geliefert am 08. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and fixed and floating security document
    Erstellt am 25. Sept. 2001
    Geliefert am 04. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future moneys debts and liabilities due (including the guaranteed liabilities) owing or incurred by a chargor to any finance party (including the chargee as security trustee for the finance parties) under or in connection with any finance document (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    Including premises at unit 6 marston gate development site station rd brogborough milton keynes beds, f/h interest in premises on the south side of parkhouse road east bradwell newcastle under lyme t/no.SF245317, premises at unit 3 watchmoor point camberley, the parkland buildings k/a tangent point central way park royal london NW10 and unit 41 parkhouse industrial estate rosevale road newcastle under lyme staffs. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 12. Nov. 1999
    Geliefert am 18. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture, the other finance documents or on any other account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 18. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 26. Mai 1995
    Geliefert am 09. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the deed
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC("the Security Trustee")
    Transaktionen
    • 09. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 26. Mai 1995
    Geliefert am 08. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as broomco (910) limited) and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to an instrument dated 26TH may 1995 constituting £19,000,000 8 per cent secured loan stock 2004 to be issued by broomco (910) limited
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Montagu Equity Limitedas Agent for the Holders from Time to Time of the Stock
    Transaktionen
    • 08. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ANC BUSINESS SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    26. Feb. 2024Beginn der Liquidation
    22. Feb. 2024Erklärung der Zahlungsfähigkeit geleistet am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Emma Cray
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praktiker
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0