ANC BUSINESS SERVICES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ANC BUSINESS SERVICES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Liquidation |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03049044 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ANC BUSINESS SERVICES LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich ANC BUSINESS SERVICES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Parkhouse East Industrial Estate Newcastle Under Lyme ST5 7RB Staffordshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ANC BUSINESS SERVICES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ANC GROUP LIMITED | 09. Juni 1995 | 09. Juni 1995 |
BROOMCO (910) LIMITED | 24. Apr. 1995 | 24. Apr. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ANC BUSINESS SERVICES LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Mai 2023 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 29. Feb. 2024 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2022 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ANC BUSINESS SERVICES LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 13. Apr. 2024 |
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 27. Apr. 2024 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 13. Apr. 2023 |
Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für ANC BUSINESS SERVICES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Feb. 2025 | 7 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Roel Jos Coleta Staes als Geschäftsführer am 31. Jan. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 8 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Helena Jansson als Geschäftsführer am 11. Mai 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Apr. 2023 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2022 | 25 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lawrence Trevor Hoyle als Geschäftsführer am 03. Jan. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 04. Okt. 2022
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 11. Okt. 2022
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2021 | 23 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2020 | 23 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von James Alexander Davies als Direktor am 12. Juni 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Justin Neil Clarke als Geschäftsführer am 12. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2019 | 23 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Justin Neil Clarke als Direktor am 02. Dez. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ANC BUSINESS SERVICES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWKINS, James Edmund | Sekretär | Anc Group Head Office Parkhouse East Industrial Estate ST5 7RB Newcastle Staffordshire | British | Accountant | 101387860002 | |||||
DAVIES, James Alexander | Geschäftsführer | Holly Lane CV9 2RY Atherstone Express House United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 270834780001 | ||||
DURACK, Sean Patrick | Sekretär | 4 Churchston Avenue Bramhall SK7 3DA Stockport Cheshire | British | 87327210001 | ||||||
PARROTT, Stephen John | Sekretär | Matlock Road CV1 4JQ Coventry Sutherland House West Midlands | British | Business Executive | 48941480002 | |||||
PYWELL, Christopher Graham | Sekretär | Highfield Farm Cobbs Lane Hough CW2 5JL Crewe Cheshire | British | Finance Director | 37719690005 | |||||
RONALD, Paul | Sekretär | 15 Arran Close Holmes Chapel CW4 7QP Crewe Cheshire | British | Financial Controller | 71473700001 | |||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 | |||||||
ALLEN, Mark Russell | Geschäftsführer | St.Goedeleplein 14 Brussels Federal Express Europe Inc. 1000 Belgium | Belgium | American | Business Executive | 77781820002 | ||||
CALLAGHAN, Andrew Michael | Geschäftsführer | Graybrook Farm Middlewich Road WA16 9JQ Allostock Cheshire | British | Managing Director | 76165950001 | |||||
CLARKE, Justin Neil | Geschäftsführer | Parkhouse East Industrial Estate Newcastle Under Lyme ST5 7RB Staffordshire | England | British | Solicitor | 184467260002 | ||||
CONNELL, Richard Andrew | Geschäftsführer | Lower Roundhurst Tennyson's Lane Roundhurst GU27 3BN Haslemere Surrey | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 102127970001 | ||||
COWAN, Geoffrey Alan | Geschäftsführer | 26 Satinwood Close Gerrards Park WN4 9NL Ashton In Makerfield Lancashire | British | Operations Director | 77265020001 | |||||
CRANMER, Charles David | Geschäftsführer | Parkhouse East Industrial Estate ST5 7RB Newcastle Staffordshire | British | Finance Director | 60508750002 | |||||
ELLIOTT, Robert William | Geschäftsführer | B-1420 Braine L'Alleud Avenue Des Champs 2 Belgium | American | Business Executive | 77782020004 | |||||
GITTINS, Jonathan Mark | Geschäftsführer | Anc Group Head Office Parkhouse East Industrial Estate ST5 7RB Newcastle Staffordshire | British | Ceo | 75431680002 | |||||
HAMMOND, Nigel Derek | Geschäftsführer | Rust Hall Langton Road TN3 0BB Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | Banker | 117998050001 | ||||
HOLT, Michael John | Geschäftsführer | Anc Group Head Office Parkhouse East Industrial Estate ST5 7RB Newcastle Staffordshire | United Kingdom | British | Company Director | 121123210001 | ||||
HOYLE, Lawrence Trevor | Geschäftsführer | ST5 7RB Newcastle Under Lyme Parkhouse East Industrial Estate Staffordshire United Kingdom | England | British | Group Operations Director | 130938230003 | ||||
JACKSON, Edward Thomas | Geschäftsführer | Little West End Wistaston Green Road CW2 8SA Crewe | British | Personnel Director | 37861110003 | |||||
JANSSON, Helena | Geschäftsführer | Kantersteen 47 1000 Brussels Federal Express Europe, Inc Belgium | Belgium | Swedish | Business Executive | 184103240001 | ||||
KOVAL, Kenneth Francis | Geschäftsführer | 23 Rue Leon Lepage B1000 Brussels Belgium | American | Finance Director | 118262180001 | |||||
MCCANN, Anthony Joseph | Geschäftsführer | 12 Phillimore Gardens W8 7QD London | British | Chief Executive | 20509810002 | |||||
MITCHELL, Mark | Geschäftsführer | Anc Group Head Office Parkhouse East Industrial Estate ST5 7RB Newcastle Staffordshire | British | Business Development Director | 62274000002 | |||||
PARR-DAVIES, Robin | Geschäftsführer | 21 Greenways Walton On The Hill KT20 7QE Tadworth Surrey | British | Company Director | 49509220001 | |||||
PYWELL, Christopher Graham | Geschäftsführer | Highfield Farm Cobbs Lane Hough CW2 5JL Crewe Cheshire | United Kingdom | British | Managing Director | 37719690005 | ||||
STAES, Roel Jos Coleta | Geschäftsführer | Kantersteen 47 1000 Brussels Federal Express Europe, Inc Belgium | Belgium | Belgian | Business Executive/Attorney | 170094650001 | ||||
DLA NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003800001 | |||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ANC BUSINESS SERVICES LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anc Group Limited | 06. Apr. 2016 | Parkhouse East Industrial Estate ST5 7RB Newcastle-Under-Lyme . United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ANC BUSINESS SERVICES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 02. Feb. 2006 Geliefert am 10. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due up to a maximum of £8,000,000 from any group company to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 02. Feb. 2006 Geliefert am 08. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and fixed and floating security document | Erstellt am 25. Sept. 2001 Geliefert am 04. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future moneys debts and liabilities due (including the guaranteed liabilities) owing or incurred by a chargor to any finance party (including the chargee as security trustee for the finance parties) under or in connection with any finance document (all terms as defined) | |
Kurze Angaben Including premises at unit 6 marston gate development site station rd brogborough milton keynes beds, f/h interest in premises on the south side of parkhouse road east bradwell newcastle under lyme t/no.SF245317, premises at unit 3 watchmoor point camberley, the parkland buildings k/a tangent point central way park royal london NW10 and unit 41 parkhouse industrial estate rosevale road newcastle under lyme staffs. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 12. Nov. 1999 Geliefert am 18. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture, the other finance documents or on any other account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 26. Mai 1995 Geliefert am 09. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the deed | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 26. Mai 1995 Geliefert am 08. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (formerly known as broomco (910) limited) and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to an instrument dated 26TH may 1995 constituting £19,000,000 8 per cent secured loan stock 2004 to be issued by broomco (910) limited | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat ANC BUSINESS SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0