WILLENHALL ENGINEERING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WILLENHALL ENGINEERING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03060098 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WILLENHALL ENGINEERING LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich WILLENHALL ENGINEERING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Portebello School Street WV13 3PW Willenhall West Midlands |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WILLENHALL ENGINEERING LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| STOCKWELL INDUSTRIES LIMITED | 23. Nov. 1995 | 23. Nov. 1995 |
| SPLASHOUT LIMITED | 23. Mai 1995 | 23. Mai 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WILLENHALL ENGINEERING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WILLENHALL ENGINEERING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Arthur Vann als Geschäftsführer am 01. Juli 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Paddock Fabrications Ltd Fryers Road Bloxwich Walsall WS2 7LZ am 17. Sept. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Alexander Paul Stern als Sekret är | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Claire Louise Bailey als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von John Linley Middleton als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Allan David Talbot Cooper als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Neil Arthur Vann als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew King als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew King als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WILLENHALL ENGINEERING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STERN, Alexander Paul | Sekretär | School Street WV13 3PW Willenhall Portebello West Midlands | British | 154211740001 | ||||||
| BAILEY, Claire Louise | Geschäftsführer | School Street WV13 3PW Willenhall Portebello West Midlands | United Kingdom | British | 154201050001 | |||||
| COOPER, Allan David Talbot | Geschäftsführer | School Street WV13 3PW Willenhall Portebello West Midlands | United Kingdom | British | 154201290001 | |||||
| HUTCHINSON, Nigel John | Geschäftsführer | 1 Penkside Coven WV9 5BL Wolverhampton | United Kingdom | British | 63848530002 | |||||
| MIDDLETON, John Linley | Geschäftsführer | School Street WV13 3PW Willenhall Portebello West Midlands | United Kingdom | South African | 154201180001 | |||||
| ASH, Alan Joseph | Sekretär | 11 Stockwell Road Stockwell End Tettenhall WV6 9PG Wolverhampton West Midlands | British | 39221230001 | ||||||
| ASH, Alan Joseph | Sekretär | 11 Stockwell Road Stockwell End Tettenhall WV6 9PG Wolverhampton West Midlands | British | 39221230001 | ||||||
| BURNHOPE, Mark Edward | Sekretär | 113 Stafford Road Bloxwich WS3 3PG Walsall West Midlands | English | 60709550001 | ||||||
| GRAEME, Dorothy May | Bevollmächtigter Sekretär | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001330001 | ||||||
| JOHNSON, Danielle Helen | Sekretär | Flat 6 Woodland House 80-86 High Street Quarry Bank DY5 2AD Brierley Hill West Midlands | British | 43894560001 | ||||||
| KING, Andrew Mark | Sekretär | 23 Yew Croft Avenue Harborne B17 9TR Birmingham West Midlands | British | 96568110001 | ||||||
| MILLAR, Seamus Joseph | Sekretär | 5 Stainforth Close WA3 4HZ Culcheth Cheshire | British | 75263350001 | ||||||
| MILNE, Robert George | Sekretär | The Old Mission Whiston, Penkridge ST19 5QH Stafford Staffordshire | British | 63359780001 | ||||||
| PRIEST, David | Sekretär | 40 Langland Drive DY3 3TH Dudley West Midlands | British | 62678310001 | ||||||
| WATSON, Keith | Sekretär | 5 The Walmers Aldridge WS9 8QW Walsall West Midlands | British | 81999450001 | ||||||
| ASH, Alan Joseph | Geschäftsführer | 11 Stockwell Road Stockwell End Tettenhall WV6 9PG Wolverhampton West Midlands | British | 39221230001 | ||||||
| BURNHOPE, Mark Edward | Geschäftsführer | 113 Stafford Road Bloxwich WS3 3PG Walsall West Midlands | England | English | 60709550001 | |||||
| CLIFF, Richard Martyn | Geschäftsführer | 195 High Street B64 5HW Cradley Heath West Midlands | United Kingdom | British | 61911280001 | |||||
| COLE, Peter Gregory | Geschäftsführer | 3 Firtree Road WV3 8AN Wolverhampton | British | 61862720001 | ||||||
| DEAN, Andrew Michael | Geschäftsführer | Wrottesley Hall Hollyhead Road WV5 8AZ Codsall South Staffordshire | British | 17843300002 | ||||||
| GRAEME, Lesley Joyce | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001320001 | ||||||
| HARVEY, Richard Horace | Geschäftsführer | Long Birch Farm, Port Lane Coven WV9 5BE Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | 16753430002 | |||||
| KING, Andrew Mark | Geschäftsführer | 23 Yew Croft Avenue Harborne B17 9TR Birmingham West Midlands | England | British | 96568110001 | |||||
| LEGGE, Martin Joseph | Geschäftsführer | 54a Clifton Road Tettenhall WV6 9AP Wolverhampton | England | British | 30709360002 | |||||
| MILNE, Robert George | Geschäftsführer | The Old Mission Whiston, Penkridge ST19 5QH Stafford Staffordshire | British | 63359780001 | ||||||
| PEARCE, Graham Wilfred | Geschäftsführer | 9 Pavilion Grove St Georges TF2 9PN Telford Shropshire | British | 30888860002 | ||||||
| SAVAGE, John Richard | Geschäftsführer | Primrose Bank Brooks Lane Bosley SK11 0PU Macclesfield Cheshire | British | 61675390001 | ||||||
| VANN, Neil Arthur | Geschäftsführer | School Street WV13 3PW Willenhall Portebello West Midlands | United Kingdom | British | 154201650001 |
Hat WILLENHALL ENGINEERING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 27. Jan. 2006 Geliefert am 04. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of intellectual property rights | Erstellt am 27. Jan. 2006 Geliefert am 04. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the intellectual property rights, assigns all applications and all right title and interest in and to the applications, all right title and interest in and to all those third party rights and by way of fixed charge such part of the materials. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 19. Juli 2001 Erworben am 05. Apr. 2002 Geliefert am 13. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Freehold land on the south of froysell street walsall west midlands t/no;-SF101820. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 19. Juli 2001 Erworben am 05. Apr. 2002 Geliefert am 13. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Freehold property at 33A doctors place willenhall walsall west midlands t/no;-WM596661. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 19. Juli 2001 Erworben am 05. Apr. 2002 Geliefert am 13. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Freehold property known as 11 froysell street willenhall west midlands t/no.;-SF12984. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 19. Juli 2001 Erworben am 05. Apr. 2002 Geliefert am 13. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Freehold property known as 33 doctors piece willenhall walsall west midlands t/no;-WM530243. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Juli 2001 Geliefert am 01. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 03. Aug. 1995 Geliefert am 16. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral debenture | Erstellt am 03. Aug. 1995 Geliefert am 08. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat WILLENHALL ENGINEERING LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0